• Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Andy MUIR

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeAndy
    Último NomeMUIR
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo1
    Renunciado68
    Total69

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    PARTNERS 4 LIFT F7 LIMITED25/10/2021DissolvidaDirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ELC (SEDBERGH) LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CARVETI GROUP SERVICES LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ELIFT CUMBRIA LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ELC (TRANCHE 1) LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CLEVER INSITES LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    England
    EnglandBritish
    ELC (BARROW) HOLDCO LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    PRIMARY CARE ESTATES LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ONE NORTH CUMBRIA LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CARVETI PARTNERSHIP LTD28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ELC (BARROW) LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ELC VENTURES LIMITED28/10/202126/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    Greater Manchester
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CPP FUNDCO LIMITED26/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    LSHP DEVELOPMENT COMPANY LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    LIVERPOOL AND SEFTON HEALTH PARTNERSHIP LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    KHC FUNDCO LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    GOS FUNDCO LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    TPM FUNDCO LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    AEL FUNDCO LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    MCDC FUNDCO LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    MCDC MIDCO LIMITED20/10/202118/07/2024AtivaRegional DirectorDiretor
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Suite 12b, Manchester One
    United Kingdom
    EnglandBritish
    FOUNDATION FOR LIFE LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    BRAHM FUNDCO 1 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    INHOCO 2952 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    BLACKBURN FUNDCO LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    PACIFIC SHELF 888 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    BRAHM INTERMEDIATE HOLDCO 1 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    PIMCO 2401 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    PINCO 2033 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    PEMBERTON CARE LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    BRAHM LIFT LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    ROSSENDALE LIFT LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    PIMCO 2297 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    EAST LANCASHIRE BUILDING PARTNERSHIP LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish
    BOLTON FUNDCO 1 LIMITED28/10/202112/07/2024AtivaDirectorDiretor
    Suite 12b, Manchester One
    53 Portland Street
    M1 3LD Manchester
    Community Health Partnerships
    England
    EnglandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0