Sarah Jayne CLAPSON
Pessoa Física
Título | Mrs |
---|---|
Primeiro Nome | Sarah |
Segundo Nome | Jayne |
Último Nome | CLAPSON |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 2 |
Inativo | 2 |
Renunciado | 16 |
Total | 20 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THE GREY AREA LTD | 01/03/2024 | Ativa | Director | Diretor | Roydon Road SG12 8UU Stanstead Abbotts 16 The Maltings Hertfordshire England | England | British | |
AWKWARD CUSTOMER LTD | 01/07/2021 | Dissolvida | Director | Diretor | Roydon Road SG12 8UU Stanstead Abbotts 16 The Maltings Hertfordshire England | England | British | |
PROTECT THE MEDICS LTD | 10/10/2020 | Ativa | Director | Diretor | Crouch Lane EN7 6TH Goffs Oak Greenacres Hertfordshire United Kingdom | England | British | |
GREY AREA LIMITED | 20/10/1999 | Dissolvida | Company Secretary | Secretário | Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Hertfordshire | British | ||
LIBERTY ADAMS LIMITED | 18/09/2018 | 27/01/2023 | Dissolvida | Company Director | Diretor | Roydon Road SG12 8UU Stanstead Abbotts 16 The Maltings Hertfordshire England | England | British |
SIMPLY COMMUNICATIONS LTD | 24/06/2020 | 30/06/2022 | Dissolvida | Secretary | Diretor | Roydon Road SG12 8UU Stanstead Abbotts 16 The Maltings Hertfordshire England | England | British |
A FRANCIS LTD | 01/11/2019 | 04/01/2022 | Ativa | Director | Diretor | Roydon Road SG12 8UU Stanstead Abbotts 16 The Maltings Hertfordshire England | England | British |
WHITEHAWK CORPORATE SERVICES LIMITED | 10/08/2017 | 23/08/2021 | Ativa | Director | Diretor | Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Herts | England | British |
CHAPTERS THERAPY LTD | 17/10/2020 | 04/01/2021 | Ativa | Director | Diretor | Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware 106 England | England | British |
P1 PROPERTY SERVICES LIMITED | 01/11/2019 | 02/11/2019 | Dissolvida | Director | Diretor | 106 Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware Mill Studio Business Centre Hertfordshire | England | British |
CHRISTOPHER COX LTD | 01/04/2018 | 01/09/2019 | Ativa | Company Director | Diretor | Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Mill Studio United Kingdom | England | British |
NORTH ACQUISITIONS LIMITED | 10/05/2018 | 31/03/2019 | Dissolvida | Company Director | Diretor | Mill Studio SG12 9PY Crane Mead 106 United Kingdom | England | British |
JAKE COX LIMITED | 01/05/2018 | 31/03/2019 | Ativa | Company Director | Diretor | Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Hertfordshire England | England | British |
EVERSLEY HOMES LTD | 31/12/2016 | 31/05/2018 | Dissolvida | Accountant | Diretor | Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Mill Studio England | England | British |
QUESTVISION LIMITED | 04/01/2016 | 01/01/2018 | Ativa | Company Director | Diretor | Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Mill Studio Herts | England | British |
JC (DOA) LTD | 01/01/2013 | 01/09/2015 | Dissolvida | Accountant | Diretor | Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Hertfordshire | England | British |
CHRIS DECLERK LTD | 01/09/2010 | 11/04/2013 | Ativa | Accountant | Diretor | c/o Intega Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Hertfordshire United Kingdom | England | British |
GREY AREA LIMITED | 20/10/1999 | 01/01/2011 | Dissolvida | Company Secretary | Diretor | Mill Studio Crane Mead SG12 9PY Ware 106 Hertfordshire England | England | British |
THE WILLOWS (AMWELL LANE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 08/02/2001 | 10/05/2005 | Ativa | Secretário | 1 The Willows Amwell Lane, Stanstead Abbotts SG12 8DG Ware Hertfordshire | British | ||
THE WILLOWS (AMWELL LANE) MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 12/03/2000 | 10/05/2005 | Ativa | Receptionist | Diretor | 1 The Willows Amwell Lane, Stanstead Abbotts SG12 8DG Ware Hertfordshire | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0