Amanda HAMILTON-STANLEY
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Amanda HAMILTON-STANLEY

    Pessoa Física

    TítuloMs
    Primeiro NomeAmanda
    Último NomeHAMILTON-STANLEY
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo5
    Inativo4
    Renunciado36
    Total45

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    VICTIM SUPPORT05/05/2021AtivaSolicitorDiretor
    Wern Fawr Lane
    Old St. Mellons
    CF3 5EA Cardiff
    Building 3
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ SECOND PENSION TRUST LIMITED23/09/2013AtivaGeneral Counsel And DirectorDiretor
    16 Davy Court, Castle Mound Way
    CV23 0UZ Rugby
    Magma House
    Warwickshire
    EnglandBritish
    BROAD STREET SECURITIES LIMITED23/09/2013AtivaGeneral Counsel And DirectorDiretor
    16 Davy Court, Castle Mound Way
    CV23 0UZ Rugby
    Magma House
    Warwickshire
    EnglandBritish
    HAMMERSMITH (WP) LIMITED23/09/2013DissolvidaSenior Group CounselDiretor
    Chivas House
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    Hammersmith (Wp) Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish
    DENMARK STREET BRISTOL PENSION TRUST LIMITED23/09/2013DissolvidaSenior Group CounselDiretor
    Chivas House
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    Denmark Street Bristol Pension Trust Limited
    United Kingdom
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ RIVERSIDE LLC24/06/2011Convertida/FechadaLegal CounselDiretor
    Renfrew Road
    PA3 4D Paisley
    111-113
    Scotland
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ FIRST PENSION TRUST LIMITED01/01/2011AtivaGeneral Counsel And DirectorDiretor
    16 Davy Court
    Castle Mound Way
    CV23 0UZ Rugby
    Magma House
    Warwickshire
    EnglandBritish
    WYNDHAM INVESTMENTS LIMITED01/01/2011AtivaGeneral Counsel And DirectorDiretor
    16 Davy Court, Castle Mound Way
    CV23 0UZ Rugby
    Magma House
    Warwickshire
    EnglandBritish
    PERNOD RICARD UK HOLDINGS LIMITED02/06/2009Convertida/FechadaLawyerDiretor
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    Chivas House
    EnglandBritish
    ADIUK01/09/201801/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    AD INV LIMITED01/09/201801/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    AD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED01/09/201801/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    OPTISURE LIMITED01/09/201801/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    AD OVERSEAS LIMITED01/09/201801/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    PR GOAL 3 LIMITED01/09/201801/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    GOAL ACQUISITIONS (HOLDINGS) LIMITED07/12/201701/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE HOLDINGS LIMITED07/12/201701/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    PERNOD RICARD UK GROUP LIMITED31/03/201701/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ SPIRITS & WINE LIMITED26/06/201201/09/2020AtivaLegal CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ LIMITED16/02/201101/09/2020AtivaGeneral CounselDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    ALLIED DOMECQ (HOLDINGS) LIMITED29/02/200801/09/2020AtivaLawyerDiretor
    Montford Place
    Kennington
    SE11 5DE London
    20
    England
    EnglandBritish
    UNSEEN (UK)30/01/201606/10/2018AtivaGeneral Counsel & Company DirectorDiretor
    1-5 Lawrence Hill
    BS5 0BY Bristol
    103 First Floor, Deben House
    EnglandBritish
    STRATHLEVEN REGENERATION C.I.C.12/10/201610/09/2018AtivaLawyerDiretor
    Renfrew Road
    PA3 4DY Paisley
    111-113
    Scotland
    EnglandBritish
    AD WESTPORT LIMITED07/12/201731/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Chivas House
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    EnglandBritish
    CHIVAS BROTHERS (HOLDINGS) LIMITED07/12/201731/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Chivas House
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    EnglandBritish
    THE GIN HUB LIMITED28/11/201731/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    Chivas House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CLAN CAMPBELL (WHISKY) LIMITED14/07/201631/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Renfrew Road
    PA3 4DY Paisley
    111-113
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish
    PASSPORT (WHISKY) LIMITED14/07/201631/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Renfrew Road
    PA3 4DY Paisley
    111-113
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish
    SOMETHING SPECIAL (WHISKY) LIMITED14/07/201631/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Renfrew Road
    PA3 4DY Paisley
    111-113
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish
    PR NEWCO 7 LIMITED14/07/201631/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Renfrew Road
    PA3 4DY Paisley
    111-113
    Renfrewshire
    Scotland
    EnglandBritish
    HILL, THOMSON & CO., LIMITED17/12/201431/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    111/113 Renfrew Road
    Paisley
    PA3 4DY
    EnglandBritish
    CHIVAS HOLDINGS (IP) LIMITED17/12/201431/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    111-113 Renfrew Road
    Paisley
    PA3 4DY Renfrewshire
    EnglandBritish
    THE GLENLIVET DISTILLERS LIMITED17/11/201431/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Chivas House
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    EnglandBritish
    PR SHELFCO 2 2023 LIMITED02/06/201431/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    111/113 Renfrew Road
    Paisley
    PA3 4DY Renfrewshire
    EnglandBritish
    AD ATLANTIC FINANCE LIMITED26/10/201131/08/2018AtivaGeneral CounselDiretor
    Chivas House
    72 Chancellors Road
    W6 9RS London
    EnglandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0