John Chapman DALLEY
Pessoa Física
Título | Mr |
---|---|
Primeiro Nome | John |
Segundo Nome | Chapman |
Último Nome | DALLEY |
Data de Nascimento | |
É Executivo Corporativo | Não |
Nomeações | |
Ativo | 3 |
Inativo | 0 |
Renunciado | 14 |
Total | 17 |
Nomeações
Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOTLAND FOOD & DRINK | 30/10/2024 | Ativa | Non-Executive Director | Diretor | Ratho Park One, 88 Glasgow Road Newbridge EH28 8PP Edinburgh 1f1, United Kingdom | Scotland | British | |
EDINBURGH INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE LIMITED | 30/05/2023 | Ativa | Chartered Accountant | Diretor | 150 Morrison Street EH3 8EE Edinburgh The Exchange United Kingdom | Scotland | British | |
EDINBURGH INTERNATIONAL CONFERENCE CENTRE HOTELS LIMITED | 30/05/2023 | Ativa | Chartered Accountant | Diretor | 150 Morrison Street EH3 8EE Edinburgh The Exchange United Kingdom | Scotland | British | |
TRADE SMART MARKETING LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | c/o Anderson Strathern Llp Rutland Court EH3 8EY Edinburgh 1 | British | ||
SEMI-CHEM LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
MORNING NOON & NIGHT LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
SEMI-CHEM (STORES) LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
BEAUTY CONCESSIONS LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
MORNING NOON & NIGHT HOLDINGS LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
THE EDINBURGH GRANARY COMPANY LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest House Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
THOMAS BROWN & SONS (FUNERAL DIRECTORS) LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
DUNDAS FYFE LIMITED | 09/06/2005 | 12/05/2023 | Ativa | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
WEST LOTHIAN WAREHOUSING LTD | 09/06/2005 | 24/01/2023 | Dissolvida | Secretário | Hillwood House 2 Harvest Drive Newbridge EH28 8QJ Edinburgh | British | ||
BOTTERILLS CONVENIENCE STORES LIMITED | 06/11/2010 | 06/11/2010 | Ativa | Company Secretary | Diretor | Block Nine South Avenue G72 0XB Blantyre Industrial Estate Blantyre | Scotland | British |
M. & S. TOILETRIES LIMITED | 09/06/2005 | 08/09/2008 | Dissolvida | Secretário | Crichton Cottage Strathearn Road EH39 5BZ North Berwick East Lothian | British | ||
CORONATION INNS LIMITED | 26/06/2000 | 25/06/2004 | Dissolvida | Finance Director | Diretor | Crichton Cottage Strathearn Road EH39 5BZ North Berwick East Lothian | Scotland | British |
SCOTTISH & NEWCASTLE INTERNATIONAL LIMITED | 31/01/2000 | 25/06/2004 | Dissolvida | Finance Director | Diretor | Crichton Cottage Strathearn Road EH39 5BZ North Berwick East Lothian | Scotland | British |
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido
O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros. - Licença: CC0