Stuart David TURNER
Pessoa Física
| Título | Mr | 
|---|---|
| Primeiro Nome | Stuart | 
| Segundo Nome | David | 
| Último Nome | TURNER | 
| Data de Nascimento | |
| É Executivo Corporativo | Não | 
| Nomeações | |
| Ativo | 13 | 
| Inativo | 2 | 
| Renunciado | 4 | 
| Total | 19 | 
Nomeações
| Nomeado para | Data de Nomeação | Data de Renúncia | Situação da Empresa | Ocupação | Função | Endereço | País de Residência | Nacionalidade | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALTON 5 PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 17/12/2024 | Ativa | Company Director | Diretor | Brunel Close Harworth DN11 8QA  Doncaster C/O Allsigns International Ltd United Kingdom | United Kingdom | British | |
| HALTON 5 MANAGEMENT COMPANY LIMITED | 13/09/2024 | Ativa | Director | Diretor | Brunel Close Harworth DN11 8QA  Doncaster C/O Allsigns Int. Ltd, Brunel Industrial Estate United Kingdom | United Kingdom | British | |
| UNIQUE CORNWALL LIMITED | 19/06/2024 | Ativa | Director | Diretor | Brunel Close Harworth DN11 8QA  Doncaster C/O Allsigns Int. Ltd, Brunel Industrial Estate United Kingdom | United Kingdom | British | |
| RENRUT INTERNATIONAL LIMITED | 12/06/2023 | Ativa | Director | Diretor | Blyth Road Harworth DN11 8QA  Doncaster C/O Allsigns Int. Ltd, Brunel Industrial Estate United Kingdom | United Kingdom | British | |
| ASTON HOMES (YORKSHIRE) LIMITED | 13/07/2017 | Ativa | Director | Diretor | Brunel Industrial Estate Blyth Road, Harworth DN11 8QA  Doncaster C/O Allsigns International Ltd South Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | |
| SPEED BUMPS LIMITED | 31/12/2016 | Dissolvida | Company Director | Diretor | Brunel Close Harworth DN11 8QA  Doncaster Allsigns Int Ltd England | United Kingdom | British | |
| HEALTH AND SAFETY SIGN ASSOCIATION LIMITED | 12/12/2013 | Ativa | Director | Diretor | Haxey Lane DN9 2NE  Doncaster 112 United Kingdom | United Kingdom | British | |
| SIGNSYSTEMS LIMITED | 26/03/2009 | Ativa | Director | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| SIGN SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | 19/03/2009 | Ativa | Director | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| M.E.C. SIGNS LIMITED | 15/12/2005 | Ativa | Director | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| PRYOR SIGNS LIMITED | 12/12/2005 | Ativa | Director | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| GAULEY LIMITED | 28/11/2003 | Ativa | Company Partner | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| ROSECRAN | 28/11/2003 | Ativa | Company Partner | Diretor | C/O Allsigns International Ltd Brunel Industrial Estate DN11 8QA  Blyth Road Harworth Doncaster | United Kingdom | British | |
| CREATIVE KITCHENWARE LIMITED | 06/08/1999 | Dissolvida | Company Director | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| ALLSIGNS INTERNATIONAL LIMITED | 24/06/1999 | Ativa | Company Director | Diretor | 112 Haxey Lane Graizelound DN9 2NE  Doncaster | United Kingdom | British | |
| APCO SIGN SYSTEMS INTERNATIONAL LIMITED | 16/04/2014 | 01/01/2015 | Ativa | Director | Diretor | Unit 3a Denby Way S66 8HR  Rotherham C/O Pryor Sign United Kingdom | United Kingdom | British | 
| APCO SIGN SYSTEMS LIMITED | 17/04/2014 | 30/06/2014 | Ativa | Director | Diretor | Unit 3a Denby Way S66 8HR  Rotherham C/O Pryor Sign United Kingdom | United Kingdom | British | 
| PHOTOLUMINESCENT SAFETY PRODUCTS ASSOCIATION | 23/05/2001 | 14/05/2013 | Ativa | Sign Manufacturer | Diretor | 44 Farnborough Drive DN4 6PR  Doncaster South Yorkshire | United Kingdom | British | 
| BURLINGFACT LIMITED | 05/06/2003 | 01/12/2006 | Ativa | Director | Diretor | 6 Dunniwood Reach Bessacarr DN4 7AS  Doncaster | British | 
Fonte de Dados
- Companies House do Reino Unido 
 O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
- Licença: CC0