Gareth Michael CADWALLADER
  • Dados
  • Grã-Bretanha
  • Empresas
  • Pesquisar empresas
  • Sanções
  • Pesquisar sanções
  • Gareth Michael CADWALLADER

    Pessoa Física

    TítuloMr
    Primeiro NomeGareth
    Segundo NomeMichael
    Último NomeCADWALLADER
    Data de Nascimento
    É Executivo CorporativoNão
    Nomeações
    Ativo0
    Inativo10
    Renunciado18
    Total28

    Nomeações

    Oficiais Nomeados
    Nomeado paraData de NomeaçãoData de RenúnciaSituação da EmpresaOcupaçãoFunçãoEndereçoPaís de ResidênciaNacionalidade
    AI-LONDON INSURTECH LTD12/08/2020DissolvidaBusiness ConsultantDiretor
    Vicarage Lane
    E15 4HF Stratford
    1
    London
    England
    EnglandBritish
    CONDUCTECH LIMITED22/06/2017DissolvidaDirectorDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    HUGHENDEN VINEYARD LIMITED05/05/2017DissolvidaDirectorDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    BETCLEARER LIMITED28/08/2012DissolvidaNoneDiretor
    Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    The White House
    Bucks
    United Kingdom
    EnglandBritish
    APOLLO LEGACY LIMITED05/11/2010DissolvidaBusiness ManagerDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brand House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    SCIDOX LIMITED05/11/2010DissolvidaBusiness ManagerDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    SOPHROSYNE VENTURES LLP23/04/2009DissolvidaMembro designado da LLP
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    England
    AIRAS INTERSOFT LIMITED16/12/2005DissolvidaSecretário
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    British
    AIRAS INTERSOFT LIMITED16/12/2005DissolvidaDirectorDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    THE OBLONG OFFICE LIMITED01/10/2002DissolvidaCompany DirectorDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    DOX PRODUCTIONS LIMITED01/10/199830/01/2025AtivaBusiness ManagerDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    LUMERA LTD30/10/200631/10/2024AtivaBusiness ConsultantDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    LUMERA LTD10/01/200631/10/2024AtivaBusiness ConsultantSecretário
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    British
    R M P ENTERPRISE LIMITED01/08/201221/12/2022AtivaInvestment ManagerDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    PRECISIONPOINT SOFTWARE LIMITED12/04/201012/07/2022AtivaCompany DirectorDiretor
    Four Ashes
    HP15 6LH Hughenden
    Brands House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    AKKROO SOLUTIONS LIMITED01/03/201812/04/2019AtivaDirectorDiretor
    Brighton Terrace
    SW9 8DJ London
    Unit 3.01 Piano House
    United Kingdom
    EnglandBritish
    DACAST LIMITED01/11/201012/03/2019AtivaCompany DirectorDiretor
    31-33 Bondway Vauxhall
    SW8 1SJ London
    3rd Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish
    AKKROO SOLUTIONS LIMITED01/07/201628/11/2016AtivaInvestment ManagerDiretor
    Kingshill Road
    Four Ashes
    HP15 6LH High Wycombe
    Brands House
    Buckinghamshire
    England
    EnglandBritish
    NATURAL NEUTRACEUTICALS LIMITED30/11/201117/10/2013DissolvidaCompany DirectorDiretor
    45-47 Tower Street
    Edinburgh
    EH6 7BN
    EnglandBritish
    PULSANT LIMITED29/10/200530/09/2011AtivaDirectorDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    APPSENSE HOLDINGS LIMITED04/01/201023/03/2011LiquidaçãoCompany DirectorDiretor
    Daresbury Park
    Daresbury
    WA4 4HS Warrington
    3300
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritish
    CLOSER PARTNERS LLP17/03/200519/04/2010DissolvidaMembro designado da LLP
    The White House
    Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont
    England
    SECTOR SKILLS DEVELOPMENT AGENCY LIMITED29/04/200228/04/2008DissolvidaCompany DirectorDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    APPSENSE HOLDINGS LIMITED18/11/200525/03/2008LiquidaçãoDirectorDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    THE TECH PARTNERSHIP16/06/200027/02/2004DissolvidaBusiness ManagerDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    ENTERPRISE SERVICES INFORMATION SECURITY UK LIMITED04/01/200124/10/2002AtivaCompany ManagerDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    ZOOM ENTERPRISES LIMITED22/03/199411/02/2000AtivaGeneral MangerDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish
    CABLE & WIRELESS WORLDWIDE VOICE MESSAGING LIMITED20/03/199512/09/1995DissolvidaManaging DirectorDiretor
    The White House Cokes Lane
    HP8 4TZ Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish

    Fonte de Dados

    • Companies House do Reino Unido
      O registro oficial de empresas no Reino Unido, fornecendo acesso público a informações sobre empresas, como nomes, endereços, diretores e registros financeiros.
    • Licença: CC0