THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTHE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00046374
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Elsley Court
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ০৯ আগ, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    4 পৃষ্ঠাCS01

    ৩১ জুল, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Forde এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২০ জানু, ২০২০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1.00
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE1

    legacy

    2 পৃষ্ঠাAGREEMENT1

    legacy

    79 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    ০৯ আগ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৪ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Sean Michael Paterson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে David James Tannahill এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ২৪ আগ, ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৯ আগ, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 000463740009 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 8 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১৯ আগ, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৪ সেপ, ২০১৭ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Punch Taverns (Rh) Limited এর বিবরণের পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাPSC05

    ০৮ সেপ, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Jubilee House Second Avenue Burton upon Trent Staffordshire DE14 2WF থেকে Elsley Court 20-22 Great Titchfield Street London W1W 8BEপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৯ আগ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Edward Michael Bashforth এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MOORE, Christopher John
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish136853310001
    MOUNTSTEVENS, Lawson John Wembridge
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritish112375050001
    PATERSON, Sean Michael
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    পরিচালক
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4 Broadway Park
    Scotland
    ScotlandBritish257892140001
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191636580001
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    সচিব
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175489820001
    RUDD, Susan Clare
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    সচিব
    17 Thacker Drive
    WS13 6NS Lichfield
    Staffordshire
    British81789210004
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    British117216940001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161609300001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    BELL, Richard Edgar, Llb Solicitor
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    13 Harbury Street
    DE13 0RX Burton On Trent
    Staffordshire
    British637110001
    CONSTANTINE, Peter Anthony
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    পরিচালক
    83 South Rise
    CF14 0RG Cardiff
    South Glamorgan
    WalesBritish114160540001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    FORDE, David
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    United KingdomIrish180590780001
    JONES, Bruce Abbott
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    পরিচালক
    1 Hall Drive
    DE13 8TF Hanbury
    Staffordshire
    British29595900002
    KEMP, Deborah Jane
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    পরিচালক
    6 Station Road
    Hampton In Arden
    B92 0BJ Solihull
    United KingdomBritish79388130005
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    TANNAHILL, David James
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    3-4 Broadway Park
    EH12 9JZ Edinburgh
    Heineken Uk Limited
    United Kingdom
    ScotlandBritish237381690001
    WHITEHEAD, Gordon William George
    Rosedale
    24 Jacks Lane
    ST14 8LW Marchington
    Staffordshire
    পরিচালক
    Rosedale
    24 Jacks Lane
    ST14 8LW Marchington
    Staffordshire
    British13507460001
    WILFORD, Nicholas James
    The Virgate Church Street
    Swepstone Coalville
    LE6 7SA Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    The Virgate Church Street
    Swepstone Coalville
    LE6 7SA Leicester
    Leicestershire
    British33328990001
    WILKINSON, Anthony Eric
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    Bupton Grange
    Longford Lane Longford
    DE6 3DT Ashbourne
    Derbyshire
    British4656080002

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    ২৯ আগ, ২০১৭
    Broadway Park
    South Gyle Broadway
    EH12 9JZ Edinburgh
    3-4
    Scotland
    Scotland
    না
    আইনি ফর্মCorporate
    নিবন্ধিত দেশScotland
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom (Scotland)
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বরSc065527
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।
    Punch Taverns (Rh) Limited
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    20-22 Great Titchfield Street
    W1W 8BE London
    Elsley Court
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    THE AYLESBURY BREWERY COMPANY,LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ অক্টো, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Trustee Company Limited as Security Trustee for the Punch Taverns Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ অক্টো, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Third supplemental deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other punch taverns secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage all right, title, interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the f/h or l/h property comprising the further punch taverns mortgaged properties; and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures. By way of fixed security the whole right, title, interest and benefit in and to the whole of the scottish trust property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Trustee Company Limited (Or Such Other Person Acting as Security Trustee Under Thepunch Taverns First Priority Deed of Charge) (the "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other pr secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of assignment all of the company's right, title, interest and benefit, present and future in, to and under the master amendment deed.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other spirit secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest in to and under the f/h or l/h property comprising in the spirit mortgaged properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge; and all estates or interests in such property and allbuildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Trustee Company Limited as Trustee for the Spirit Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ০৮ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company, or any other charging company and/or guarantor to the chargee whether for its own account or as trustee for the pr secured parties or any of the other pr secured parties under or in respect of the issuer/borrower facility agreement, the charge and/or any other transaction documents to which it is a party (all as defined therein)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All right title and interest and benefit, in, to and under the f/h and l/h properties owned by it and described in part 1 of schedule 2 to the charge, and all estates or interests in such property and all buildings, trade and other fixtures, fiall right title interest and benefit, in, to and under the f/h xed plant and machinery a floating charge over the undertaking of all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bankers Trustee Company Limited (For Itself and on Behalf of the Pr Secured Parties) "the Security Trustee" (as Defined Therein)
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ জানু, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৪ জানু, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ১৪ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of the obligors (as defined) to any transaction party under each transaction document (as defined) except for any obligation which, if it were so included, would result in the security agreement contravening section 151 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage the property defined as abbots way south drive sothway plymouth devon, alsager arms 4 sandbach rd south alsager stoke-on-trent staffs, anchor high st little paxton st neots huntingdon cambs (for full list of all property charged see schedule to form 395) together with fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital building fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Stanley & Co International Limited as Agent and Trustee for the Transaction Parties (The"Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,165,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee. Under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    117 the headrow and 72A and 74 upper basinghall street leeds west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Scottish Life Assurance Company
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ সেপ, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge by way of substituted security
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৫৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৫৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £200,000 debenture stock secured by a trust deed dated 28 dec 1987.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land adjoining the "old swan inn" cheddington. Bucks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • W L B Walker
    • J O Jones
    • H D Sowerby
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ১৯৫৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ জুন, ১৯৯০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Conveyance supplemental to a trust deed dated 28TH june 1897.
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৩১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৩১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £50,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land with the premises known as "the red lion" twyford ,county of buckingham ,.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • L.E. Walker, C.E.B. Bull, G.F. Parrott.
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৩১একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0