GREEN (T.P.) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGREEN (T.P.) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00049157
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GREEN (T.P.) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    GREEN (T.P.) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    KPMG
    8 Princes Parade
    L3 1QH Liverpool
    Merseyside
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GREEN (T.P.) LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TRAFFORD PARK ESTATES LIMITED১৭ আগ, ১৮৯৬১৭ আগ, ১৮৯৬

    GREEN (T.P.) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৬

    GREEN (T.P.) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    ১৭ জুন, ২০১১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১৭ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১৭ জুন, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ১৭ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    দেউলিয়া রেজোলিউশন

    Resolution insolvency:ordinary resolution "books,records.etc"
    2 পৃষ্ঠাLIQ MISC RES

    দেউলিয়া রেজোলিউশন

    Resolution insolvency:extraordinary resolution "in specie"
    2 পৃষ্ঠাLIQ MISC RES

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৮ ডিসে, ২০০৮ তারিখে

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    3 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    পৃষ্ঠা363(288)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    GREEN (T.P.) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MUNRO, Mark
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    সচিব
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    Irish88709730004
    CULHANE, Paul
    Ballyorney Road
    Enniskerry
    Killough House
    Wicklow
    Ireland
    পরিচালক
    Ballyorney Road
    Enniskerry
    Killough House
    Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish49388470004
    MCKENNA, James
    3 Kilteragh Road Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    পরিচালক
    3 Kilteragh Road Foxrock
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    IrelandIrish84380760001
    MUNRO, Mark
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    14 Longford Terrace
    Monkstown
    Co Dublin
    Ireland
    IrelandIrish88709730004
    VERNON, Stephen
    7 Winton Road
    Ranelagh
    Dublin 6
    Ireland
    পরিচালক
    7 Winton Road
    Ranelagh
    Dublin 6
    Ireland
    IrelandBritish6399990006
    BRIGGS, Richard Jonathan
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    সচিব
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    British9000960002
    MCDOWELL, David
    The Bungalow
    Silchester
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    সচিব
    The Bungalow
    Silchester
    IRISH Glenageary
    Co Dublin
    Ireland
    Irish85557670001
    WALKER, Andrew James
    240 Padgbury Lane
    CW12 4HU Congleton
    Cheshire
    সচিব
    240 Padgbury Lane
    CW12 4HU Congleton
    Cheshire
    British36424560001
    BRIGGS, Richard Jonathan
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    8 Greenway
    SK9 1LU Wilmslow
    Cheshire
    British9000960002
    CHERRY, Mark Edward
    Glebe House
    Chequers Lane Preston
    SG4 7TY Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Glebe House
    Chequers Lane Preston
    SG4 7TY Hitchin
    Hertfordshire
    EnglandBritish141619810001
    DAVIS, James Wilson
    The Stables, Smithy Fold
    Watling Street, Affetside
    BL8 3QS Bury
    Lancashire
    পরিচালক
    The Stables, Smithy Fold
    Watling Street, Affetside
    BL8 3QS Bury
    Lancashire
    EnglandBritish67445010001
    GERRARD, Raymond Ormesher
    12 Woodlea Walkden Road
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    12 Woodlea Walkden Road
    Worsley
    M28 2QJ Manchester
    Lancashire
    British63565710001
    HARRIS, Alan Joseph
    Brendon
    Catlins Lane Eastcote
    HA5 2EZ Pinner
    Middlesex
    পরিচালক
    Brendon
    Catlins Lane Eastcote
    HA5 2EZ Pinner
    Middlesex
    Irish141619800001
    HOWE, Robert Philip Graham
    60 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    পরিচালক
    60 Arthur Road
    Wimbledon
    SW19 7DS London
    British59138110008
    HUNT, Michelle Marie
    62 First Avenue
    CM1 1RU Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    62 First Avenue
    CM1 1RU Chelmsford
    Essex
    British68329820002
    KITCHEN, Daniel John
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    পরিচালক
    5 Torquay Wood
    IRISH Dublin 18
    Ireland
    United KingdomBritish153028260001
    LEADER, Thomas David
    Silvers
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Surrey
    পরিচালক
    Silvers
    Ridgway Pyrford
    GU22 8PN Surrey
    United KingdomBritish115424450002
    SIMPKIN, Andrew Gordon
    Chapel Lane House
    Chapel Lane, Mere
    WA16 6PP Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    Chapel Lane House
    Chapel Lane, Mere
    WA16 6PP Knutsford
    Cheshire
    British71318160001
    SMITH, Ian Fredric
    56 Sandown Crescent
    Cuddington
    CW8 2QW Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    56 Sandown Crescent
    Cuddington
    CW8 2QW Northwich
    Cheshire
    British18178840001
    TAPP, Michael Stuart
    132 Wymering Mansions
    Wymering Road
    W9 2NF London
    পরিচালক
    132 Wymering Mansions
    Wymering Road
    W9 2NF London
    British68137250003
    WESTBROOK, Fraser Gowanloch
    23 Lingfield Road
    SW19 4QD London
    পরিচালক
    23 Lingfield Road
    SW19 4QD London
    British22092430001
    WESTBROOK, Neil Gowanloch, Sir
    White Gables Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    পরিচালক
    White Gables Castle Hill
    SK10 4AR Prestbury
    Cheshire
    British19592890001

    GREEN (T.P.) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ নভে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the borrower to the finance parties (or any of them)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The mortgage property being the parkway shopping centre newham way coulby newham middlesborough t/n CE89343, 56 oxford street manchester t/n LA276480, 90 great bridgewater street & part of 56 oxford street manchester LA37145. For details of further properties charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Gmac Commercial Mortgage Bank Europe PLC (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In relation to each irish obligor (other than the company and green) prior to the whitewash completion date all present and future obligations and liabilities due or to become due from green and each other obligor (other than the company) to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the chargeand the company, gpm finance and each obligor incorporated in the U.K. or jersey; and from the whitewash completion date; each irish obligor other than green,all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ১৮ নভে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ আগ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property being or k/a the westbrook road industrial estate trafford park manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ আগ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Series of debentures
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৮৩
    বকেয়া
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Corporation PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Equitable charges
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৮৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £6,250,000 first mortgage debenture stock of trafford park estates PLC inclusive of £3,250,000 stock secured by a trust deed dated 13 oct 11965 and deeds supplemental thereto.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge on fixed charges on chief rents and f/hold properties as mentioned in the schedules attached to doc M289.. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Corporation PLC.
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Sixth supplemental trust deed.
    তৈরি করা হয়েছে ১২ ডিসে, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Securing 1,250,000 7 1/4 percent fixed mortgage debenture stock 1990/95 of the company & £2,000,000 9 percent first mortgage debenture stock 1991/96 of the company & other monies intended to the secured by the principal deed dated 13 october 1965 and the first supplemental trust deed dated 25 august 1969.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1.95 acres of land with building thereon known as laing national building situate between trafford park road and trafford wharf road, trafford park, manchester. Title no:- la 345299 with fixed plant & machinery & other fixtures, all buildings erections, structures & things constructed or in the course of construction thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ১৫ ডিসে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Debenture stock of the company £3,250,000 and all other moneys secured by a principal deed dated 13TH october, 1965, and the first supplemental trust deed dated 25TH august, 1969
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold, laing national building between trafford park road and trafford wharf road, trafford park, manchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Law Debenture Corporation Limited.
    ব্যবসায়
    • ২৯ মে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Series of debentures
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৬৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ আগ, ১৯৬৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See doc. 250 & attached schedules.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Baring Brothers & Co., Limited
    ব্যবসায়
    • ২৬ আগ, ১৯৬৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Series of debentures
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৬৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৬৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See rider attached to doc. 236.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Baring Brothers & Co., Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ১৯৬৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৯ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    • ০৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GREEN (T.P.) LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৭ ডিসে, ২০১১ভেঙে গেছে
    ১৮ ডিসে, ২০০৮ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John Hansen
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast
    অভ্যাসকারী
    Stokes House 17-25 College Square East
    BT1 6DH Belfast

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0