ESTATES & GENERAL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামESTATES & GENERAL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00050072
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7011) /

    ESTATES & GENERAL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ESTATES & GENERAL PLC১৮ জুন, ১৯৯০১৮ জুন, ১৯৯০
    ESTATES & GENERAL INVESTMENTS PLC১৪ জুল, ১৯৮৭১৪ জুল, ১৯৮৭
    ESTATES AND GENERAL INVESTMENTS PLC১১ নভে, ১৮৯৬১১ নভে, ১৮৯৬

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৯

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    20 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১০ অক্টো, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Maurice Moses Benady এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২০ জানু, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২০ জানু, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২০ জানু, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৭ ফেব, ২০১৮ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠাLIQ03

    ০৮ আগ, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে F & C Reit (Corporate Services) Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ০৭ ফেব, ২০১৭ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৭ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠা4.68

    ২৬ সেপ, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Hill House 1 Little New Street London EC4A 3TR থেকে 31St Floor 40 Bank Street London E14 5NRপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রিসিভার বা ম্যানেজারের নিযুক্তি

    4 পৃষ্ঠাRM01

    রিসিভার বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাRM02

    ০৭ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ ফেব, ২০১৪ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ২০ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    22 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৭ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    FOREIGN Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    পরিচালক
    Line Wall Road
    FOREIGN Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish80132540001
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর6745658
    135316290001
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    সচিব
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    সচিব
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    British163838050001
    JACOBS, Adrian Mark
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    সচিব
    13 Beaufort Gardens
    Hendon
    NW4 3QN London
    British59392140001
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Wigmore Street
    W1U 1PB London
    5
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3143222
    79571870006
    ANAHORY, Moshe Jaacov
    608 Eurotowers
    Europort
    Gibraltar
    পরিচালক
    608 Eurotowers
    Europort
    Gibraltar
    United KingdomBritish88548180001
    BENADY, Maurice Moses
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    পরিচালক
    57/63 Line Wall Road
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    BENADY, Maurice Moses
    Bishop Rapallo's Ramp
    Gibraltar
    1b
    পরিচালক
    Bishop Rapallo's Ramp
    Gibraltar
    1b
    GibraltarBritish69435160001
    BLOOMFIELD, David William
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    Hillcroft
    The Drive Harefield Place
    UB10 8AQ Ickenham
    Middlesex
    British7927670001
    CLEGG, Barry Stuart
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    The Gate House
    18a Ducks Hill Road
    HA6 2NR Northwood
    Middlesex
    United KingdomBritish11296610002
    CULL, David Geoffrey Maurice
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    8 Centennial Court
    High Street
    WD3 1AW Rickmansworth
    Hertfordshire
    British84076630001
    DOSSETT, Roger John
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Charlecote
    Harewood Road
    HP8 4UA Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116927100001
    HOLLAND, Philip John
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    পরিচালক
    61 Badgers Gate
    LU6 2BF Dunstable
    Bedfordshire
    EnglandBritish163838050001
    LLOYD, David Griffith
    Edenbridge House
    TN8 6SJ Edenbridge
    Kent
    পরিচালক
    Edenbridge House
    TN8 6SJ Edenbridge
    Kent
    British40639900001
    MCGRATH, Kevin David
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    পরিচালক
    19 Elm Avenue
    W5 3XA London
    EnglandBritish83872490002
    PROWTING, Peter Brian
    Old Farm House
    SL3 6HU Fulmer
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Old Farm House
    SL3 6HU Fulmer
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish11296620003
    SHEPPARD, Martin Paul
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    পরিচালক
    53 Etchingham Park Road
    N3 2EB London
    United KingdomBritish127658820001
    SMITH, Ivor
    3 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    পরিচালক
    3 Shirehall Lane
    NW4 2PE London
    United KingdomBritish21120940002
    WHITE, Christopher George
    9
    4 Naval Hospital Hill
    Gibraltar
    পরিচালক
    9
    4 Naval Hospital Hill
    Gibraltar
    British99490560001
    WILSON, Thomas Frederick
    Myton House Manor Fields
    Putney Heath Putney
    SW15 3NJ London
    পরিচালক
    Myton House Manor Fields
    Putney Heath Putney
    SW15 3NJ London
    British35556920001
    REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    79571870001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Eleventh supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ আগ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land and buildings k/a tontines hanley stoke on trent t/n SF414169 together with all buildings and erections and fixtures and fittings and fixed plant and machinery for the time being thereon belonging to it and all improvements and additions thereto subject to and with the benefit of all leases underleases tenancies agreements for lease rights covenants and conditions affecting the same but otherwise free from encumberances. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Irg Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ আগ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Ninth supplemental trust
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ২০০৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First specific security the capital sum of £13,750,000 and the investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capita Irg Trustees Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all of the chargor's rights to and title and interest from time to time in the real properties specified in part iii of schedule 2. by way of floating charge (I) the whole of its assets, present and future and (ii) the whole of its assets situated in scotland.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hypo Real Estate Bank International (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ২৯ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Sixth supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ২০০৩
    আংশিক পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £3,500,000 and the investments from time to time representing the same.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Axa Insurance PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ২০০০
    আংশিক পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock of estates & general PLC and all other monies intended to be secured by the deed and deeds supplemental thereto
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land at lower end chorleywood t/n HD190157 together with all buildings and erections fixtures and fittings fixed plant and machinery and all improvements and additions thereto.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Axa Insurance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as security trustee for the secured parties (as defined in the composite guarantee and mortgage debenture), the payment and discharge of which are the subject of covenants, undertakings, guarnatees, and agreements contained in the composite guarantee and mortgage debenture and the supplemental debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (A) all moneys whether principal or interest owing now and/or from time to time on the security of the legal mortgage dated 24TH september 1991 between (1) ka-ar construction limited and (2) estates & general PLC ("the mortgage") and the benefit of the mortgage (unless the mortgage was effected by demise or sub-demise) and any other securities at any time held by the mortgagor for the mortgage debt to hold to the security trustee absolutely subject to the proviso for redemption contained in the supplemental debenture;. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ মে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release and substitution
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The principal of and interest on the £3,000,000 12.4 per cent. First mortgage debenture stock 2008 and on the £18,000,000 11.25 per cent. First mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and deeds dated 21.12.83, 23.8.85, 10.9.85, 14.5.86, 27.4.87, 28.4.87, 22.2.89, 26.6.91, 12.7.91, 11.11.91, 15.1.93, 10.8.93, 13.8.93, 15.9.93, 3.3.95, 23.6.95 and 26.11.97 to which it is supplemental
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Freehold 25 to 35 (odd numbers) castle way, southampton title number hp 101820; leasehold the tontines shopping centre hanley title number sf 286975; freehold manfield park guildford road cranleigh title number sy 488061; freehold land at lower end chorleywood title number hd 190157; freehold 69/70 high street, thame title number on 59401; freehold property at prebendal court oxford road aylesbury buckinghamshire and all buildings, erections, fixtures, fittings, fixed plant and machinery, all improvements, additions, benefit of all leases, underleases, tenancies, agreements for lease, rights, covenants, and conditions.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Letter of pledge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fourth supplemental trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £3,000,000 12.4% first mortgage debenture stock 2008 and the £18,000,000 11.25% first mortgage debenture stock 2018 of estates & general PLC and all other moneys intended to be secured by the above deed and the existing deeds (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395. undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assurance PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ১৯৯৬বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • 2১০ ফেব, ২০১১একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (LQ01)
    • 2১০ জুন, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (RM02)
    • 2১০ জুন, ২০১৪একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (RM01)
      • মামলা নম্বর 2
    Composite guarantee and mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture and the security constituted thereby
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details of charge see form 395 and contd sheets for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC as Security Trustee for Itself as a Secured Party and for the Banks (All as Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৯ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Prebendal court, oxford road, aylesbury, bucks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank Ag
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Sub-mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    17 high street, thame t/n-DN126205.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Sub-mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    40 lower icknield way, chinnor t/n-ON112789.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Sub-mortgae
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    "Troutbeck", 31 wyatts road, choleywood, t/n-HD184877.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Sub-mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    10/12 temple end, high wycombe t/n-BM123266.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Sub-mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ফেব, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from crosstyle PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 1, triangle business park, wendover road, stock mandeville, buckinghamshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Subcharge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    40 lower icknield way chinnor oxfordshire t/n-ON112789.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Subcharge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    17 high street, thame oxfordshire t/n ON126205.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Subcharge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a "troutbeck", 31 wyatts road chorleywood hertfordshire t/n-HD184877.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Subcharge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    10-12 temple end, high wycombe, buckinghamshire t/n-BM123266.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release & substitution
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জুল, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £1,200,000 & the investments from time to time.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assuarance PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of release & substitution
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুন, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £1,104,000 & the investments for the timebeing.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Guardian Royal Exchange Assuarance PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter confirming deposit of deeds by way of equitable mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০২ নভে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Prebendal court, oxford road, alesbury, buckinghamshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Commerzbank A.G
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Equitable charge without written instrument
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a letter dated 14/2/90
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1) fund lying to teh south-west of sunderland avenue bowerhill melksham wilkshire title no wt 72820 2) all that estate right title and interest as is owned by by county & surburbon properties limited in the land at outmarsh railway farm semington trowbridge wiltshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ জুন, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    General charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific equitable charge ovoer all the company's estates or interests in any f/h or l/h property now or at any time belonging to or charged to the company and/or the proceedsd of sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ ফেব, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ESTATES & GENERAL LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২১ জানু, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৬ জুন, ২০২২ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Kirstie Jane Provan
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    অভ্যাসকারী
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    Mark Robert Fry
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    অভ্যাসকারী
    Begbies Traynor Central Llp
    32 Cornhill
    EC3V 3BT London
    2প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Nicholas Guy Edwards
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Deloitte Llp Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Louise Mary Brittain
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    রিসিভার ম্যানেজার
    Po Box 810 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Lee Antony Manning
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London
    প্রশাসনিক রিসিভার
    Athene Place 66 Shoe Lane
    EC4A 3BQ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0