HENDRIX BACON UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHENDRIX BACON UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00091083
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5139) /

    HENDRIX BACON UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Bank Chambers 1
    Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Kent
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    BP CLYDE TANKER COMPANY LIMITED ০৪ ডিসে, ১৯০৬০৪ ডিসে, ১৯০৬

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৮

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    11 পৃষ্ঠা4.71

    ০৬ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    13 পৃষ্ঠা4.68

    ৩০ সেপ, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Mawlaw Secretaries Limited এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ০৬ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Pellipar House 1st Floor 9 Cloak Lane London EC4R 2RU United Kingdom থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    4 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা 201 Bishopsgate London EC2M 3AF থেকে পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০১ জুল, ২০১০

    ০১ জুল, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 400,000
    SH01

    accounts-with-accounts-type-

    6 পৃষ্ঠাAA

    একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Antonius Matheus Maria Lammers-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Mr Louis Antoine Maria Vernaus-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD02

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CHRISTIAANSE, Anthony Martin
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    পরিচালক
    3065 Sc Rotterdam
    's-Gravenweg 551
    The Netherlands
    Dutch129239540002
    VERNAUS, Louis Antoine Maria
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    পরিচালক
    Bain Square
    Kirkton Campus
    EH54 7DQ Livingston
    7
    United Kingdom
    NetherlandsDutch146206430001
    DAVISON, Stuart
    12 Speedwell Road
    CT5 3RD Whitstable
    Kent
    সচিব
    12 Speedwell Road
    CT5 3RD Whitstable
    Kent
    British123365010001
    EDMONDS, Alan Eric
    Westways 19 Washington Lane
    Euxton
    PR7 6DE Chorley
    Lancashire
    সচিব
    Westways 19 Washington Lane
    Euxton
    PR7 6DE Chorley
    Lancashire
    British1202430002
    STRINGER, Michael Gerald William
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    সচিব
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    British2093720001
    SUBNEL, Bob
    Bergkwartier 37
    Venray
    5801 Pt
    Netherlands
    সচিব
    Bergkwartier 37
    Venray
    5801 Pt
    Netherlands
    Dutch105535470001
    MAWLAW SECRETARIES LIMITED
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    কর্পোরেট সচিব
    Bishopsgate
    EC2M 3AF London
    201
    39182980003
    ABBITT, Leon Barry
    4 Hartswood Road
    CM14 5AA Brentwood
    Essex
    পরিচালক
    4 Hartswood Road
    CM14 5AA Brentwood
    Essex
    EnglandBritish153119640001
    BAKKER, Hendrix
    Vlagberg 12
    Sint Anthonis
    5845ec
    The Netherlands
    পরিচালক
    Vlagberg 12
    Sint Anthonis
    5845ec
    The Netherlands
    Dutch42560370001
    BARGEMAN, Gerrit Theodoor
    7 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    পরিচালক
    7 Seagrave Close
    CW9 8UR Northwich
    Cheshire
    Dutch92548260001
    BUZZACOTT, Michael Charles
    6 Dalkeith Road
    AL5 5PW Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Dalkeith Road
    AL5 5PW Harpenden
    Hertfordshire
    English32087340001
    COLENSO, John
    551 Crewe Road
    Wistaston
    CW2 6PU Crewe
    Cheshire
    পরিচালক
    551 Crewe Road
    Wistaston
    CW2 6PU Crewe
    Cheshire
    EnglandBritish77538060001
    HELDENS, Pierre Gerard Joseph Marie
    Stadryk 135
    5403 NH Uden
    The Netherlands
    পরিচালক
    Stadryk 135
    5403 NH Uden
    The Netherlands
    Dutch42560650001
    LAMMERS, Antonius Matheus Maria
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    পরিচালক
    7005-7023
    5692 Hb Son En Breugel
    Ekkersrijt
    The Netherlands
    Dutch126350570004
    LESTER, Stephen Kingsley
    Roslin Villa
    Ashfield Crescent Ross On Wye
    HR9 5PH Hereford
    পরিচালক
    Roslin Villa
    Ashfield Crescent Ross On Wye
    HR9 5PH Hereford
    EnglandBritish96661160001
    PHILLIPS, Perry
    Brookside Bedwells Heath
    Boars Hill
    OX1 5DE Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Brookside Bedwells Heath
    Boars Hill
    OX1 5DE Oxford
    Oxfordshire
    British25027510001
    ROELOFS, Johannes Henricus Wilhelmus
    Geslotten Stad 23
    Amersfoort
    3823 Dp
    The Netherlands
    পরিচালক
    Geslotten Stad 23
    Amersfoort
    3823 Dp
    The Netherlands
    Dutch74600510001
    SNEPVANGERS, Ronald Sudoviais Johannes Corinelis
    B Manderslaan 56a
    Zundent
    4861 Ek
    Netherlands
    পরিচালক
    B Manderslaan 56a
    Zundent
    4861 Ek
    Netherlands
    Dutch121536140001
    STRINGER, Michael Gerald William
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    পরিচালক
    The White House Clovelly Road
    CT5 4NR Whitstable
    Kent
    EnglandBritish2093720001
    SUBNEL, Andre Peter Dos
    Bergkwartter 37
    Venray
    5801 Pt
    The Netherlands
    পরিচালক
    Bergkwartter 37
    Venray
    5801 Pt
    The Netherlands
    Dutch104745250001
    THURSTON, William
    9a Chapel Road
    PE28 3PU Earith
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    9a Chapel Road
    PE28 3PU Earith
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish71902510002
    VAN DER VEN, Johannes Bastiaan
    Ryenberghof 18
    Dieren
    6952 Hr
    The Netherlands
    পরিচালক
    Ryenberghof 18
    Dieren
    6952 Hr
    The Netherlands
    Dutch74155000001
    VAN WEL, Martinus Franciscus Lambertus Marina
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    পরিচালক
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    Dutch44739910001
    VAN WEL, Martinus Franciscus Lambertus Marina
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    পরিচালক
    Langenakker 232
    5731KA Mierlo
    Netherlands
    Dutch44739910001
    VION FRESH MEAT WEST BV
    Boseind
    10
    5281 Rm Boxtel
    Holland
    কর্পোরেট পরিচালক
    Boseind
    10
    5281 Rm Boxtel
    Holland
    74110400008

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ জানু, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the lenders under each of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. as Agent and Trustee for Itself and Eachof the Lenders (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ৩১ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুন, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the senior finance documents and the mezzanine finance documents (the "secured liabilities")
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Union Bank of Switzerlandthe "Security Agent"
    ব্যবসায়
    • ১৭ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    HENDRIX BACON UK LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৫ ফেব, ২০১৫ভেঙে গেছে
    ০৭ অক্টো, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    David Jenner Cork
    Bank Chambers
    1 Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Kent
    অভ্যাসকারী
    Bank Chambers
    1 Central Avenue
    ME10 4AE Sittingbourne
    Kent

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0