MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00100620
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Aurum House 2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    MAPPIN & WEBB LIMITED১০ ডিসে, ১৯০৮১০ ডিসে, ১৯০৮

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জানু, ২০১০

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    A90JWNG1

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ জুল, ২০১০

    ১৩ জুল, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,264,248
    SH01
    XXW7NLNS

    মোট ছাড় ছোট কোম্পানির হিসাব ৩১ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    XH4N5KA4

    পূর্ণ হিসাব ০১ ফেব, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA
    AJFNKGSN

    ০৫ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Richard Edwin Gerrard-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XK2VADZ0

    ০৫ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Justin Paul David Stead-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XK2VGDZ6

    ০৫ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Stephen Clive Sargent-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XK2VEDZ4

    ০৫ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Anthony John Broderick-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XK2V8DZY

    ০৫ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mrs Gillian Oliff-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03
    XK2V3DZT

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b
    X0PQXC5Q

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a
    XSPQDBF7

    পূর্ণ হিসাব ০৩ ফেব, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA
    A3V593RG

    legacy

    5 পৃষ্ঠা363a
    XCUU01A8

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287
    XCUTW1A3

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c
    XCUTX1A4

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c
    XCUTZ1A6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c
    XCUTY1A5

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ২৭ জানু, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    OLIFF, Gillian
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    সচিব
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    British128108960001
    BRODERICK, Anthony John
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    পরিচালক
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishSales Director98431500001
    GERRARD, Richard Edwin
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    পরিচালক
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishCommercial Director124068680001
    SARGENT, Stephen Clive
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    পরিচালক
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandBritishFinance Director16905350005
    STEAD, Justin Paul David
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    পরিচালক
    2 Elland Road
    Braunstone
    LE3 1TT Leicester
    Aurum House
    EnglandAustralianChief Executive116638810003
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    সচিব
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishDirector61931900002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    সচিব
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishHead Of Operations61931900002
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    সচিব
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    British64357220001
    HARRINGTON, Nicholas Joseph
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    সচিব
    9 Kingsmead Avenue
    KT4 8XB Worcester Park
    Surrey
    British1273670001
    LOBB, Andrew Mark
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    সচিব
    33 Lyndhurst Avenue
    NW7 2AD London
    British74760630002
    PAGE, Elizabeth
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    সচিব
    Flat 3
    5 St Leonards Road, Ealing
    W13 8PN London
    British34006010001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    সচিব
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    Irish950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    সচিব
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    BritishFinance Director62321110002
    ADAMS, David Alexander Robertson
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    Applegarth Three Elm Lane
    Hadlow
    TN11 0AB Tonbridge
    Kent
    EnglandBritishGroup Finance Dir55757700003
    ASPREY, John Rolls
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    পরিচালক
    166 New Bond Street
    W1Y 0AR London
    United KingdomBritishJeweller Goldsmith S68034280002
    ATTALLAH, Naim Ibrahim
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    পরিচালক
    Flat 15
    51 South Street
    W1Y 5PA London
    United KingdomBritishBusiness Executive25646240001
    BERKMEN, Gillian
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    পরিচালক
    Orchard View 27 Woodhill Avenue
    SL9 8DP Gerrards Cross
    South Buckinghamshire
    GbBritishDirector92154270001
    BROWN, Andrew Saville
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    পরিচালক
    123 Edenfield Gardens
    KT4 7DX Worcester Park
    Surrey
    United KingdomBritishDirector69874610002
    COOPER, Caroline
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    পরিচালক
    222 Caraway 2 Cayenne Court
    32 Shad Thames
    SE1 2PP London
    BritishDirector92733900001
    DAHL, Ian Xavier
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    পরিচালক
    2 Heathfield Lodge
    Carron Lane
    GU29 9LD Midhurst
    West Sussex
    BritishGroup Chief Executive66486140001
    EVANS, Nicholas David
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    পরিচালক
    6 Raddington Road
    W10 5TF London
    United KingdomBritishDirector57490310002
    FISHER, Mark
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Cottage
    London Road
    SG8 9LT Royston
    Hertfordshire
    BritishGroup Retail Operations Direct61931900002
    GREEN, Edward Maurice
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    পরিচালক
    82 Portland Place
    W1N 3DH London
    BritishDirector47989150001
    GREGG, Terence Michael
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    পরিচালক
    6 Chilterns End Close
    RG9 1SQ Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishCompany Director64357220001
    LOWDEN, David Soutar
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    The Squirrels
    Riversdale
    SL8 5EB Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director54836190001
    MCCLOSKEY, Ciaran
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Whitehouse Farm
    PE12 0HE Sutton St James
    Lincolnshire
    BritishDirector88312080001
    PIASECKI, Jerzy Stanislaw
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    পরিচালক
    Mill Lane
    Lower Shiplake
    RG9 3ND Henley On Thames
    Lockend House
    Oxon
    EnglandBritishDirector129561330001
    PILKINGTON, Judith Mary
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    পরিচালক
    43 The Nautilus Building
    3 Myddleton Passage
    EC1R 1XW London
    United KingdomBritishChief Executive106791670001
    REID, Michael John
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    পরিচালক
    49 Waldemar Avenue
    W13 9PZ London
    EnglandIrishChartered Accountant950490001
    RIVERS, Paul Edward
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Fox Cottage 1a Abingdon Road
    Tubney
    OX13 5QL Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishFinance Director62321110002
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    পরিচালক
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandicDirector114179720001
    SUMMERS, Jeffrey
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    5 Ashley Road
    Stoke Albany
    LE16 8PL Market Harborough
    Leicestershire
    BritishMerchandise Director127606650001
    WEST, James Edward
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    4 Church Lane
    Stanford On Avon
    NN6 6JP Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director14107350002

    MAPPIN & WEBB HOLDINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Deed of debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Landsbanki Islands Hf
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০০৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of debenture made between the company and others as chargors and burdale financial limited as agent and trustee for itself and each of the finance parties
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জুন, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the finance parties (or any of them) under the finance documents (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ জুন, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জানু, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture under the tranche b loan agreement dated 24TH december 1998 between the company and the agent
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জানু, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bankboston N.A.(As Agent and Trustee for the Lenders)
    ব্যবসায়
    • ০২ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুন, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জানু, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the loan documents (and each of them) which shall for the avoidance of doubt include the debenture and the guarantee set out therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bankboston N.A. (As Agent for the Lenders)
    ব্যবসায়
    • ০২ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the companies right title and interest in "the real property" as defined in form 395 together with fixed charge all of each charging companys right title and interest in and to the "investments" (as defined in the security agreement) any rights or assets belonging to the company deriving from such investments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank Plcas Trustee for the Secured Creditors
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ফেব, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Demise supplemental to trust deed of 15 jan 1909 registered pursuant to an order of court dated 10 december 1915
    তৈরি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ডিসে, ১৯১৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    An issue of £250,000 debenture stock
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets at the time of the registration of the said debenture issue being both the present demise is in substitution of certain property in norfolk street sheffield for property no 220 regent street london present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • W.J. Mappin
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    • E.W. Grimwade
    ব্যবসায়
    • ১৫ ডিসে, ১৯১৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Land registry charge supplemental to trust deed dated 15 january 1909
    তৈরি করা হয়েছে ২২ অক্টো, ১৯০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £250,000 debenture stock
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Mansion house buildings queen victoria street the land comprised in land registry title no 120242 city of london. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • W.J. Mappin
    • E.W. Grimwade
    • V. Alexander
    • C.H. Passingham
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯০৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Instrument of charge under land transfer acts 1875 & 1897
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ১৯০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ১৯০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £250,000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    158, 160 & 162 oxford street and 1 & 2 winsley street and land comprised in the title no 88368 district london parish st.marylebone.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • E.W.Grimwade
    • V.Alexander
    • W.J.Mappin
    • C.H. Passingham
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ১৯০৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0