SUTER ESTATES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSUTER ESTATES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00107150
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SUTER ESTATES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7020) /

    SUTER ESTATES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SUTER ESTATES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HERMETIC SECURITIES LIMITED২৬ জানু, ১৯১০২৬ জানু, ১৯১০

    SUTER ESTATES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১১

    SUTER ESTATES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    2 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২৮ ফেব, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    ২১ ডিসে, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Vinod Bachulal Vaghela এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৩ মে, ২০১১

    ০৩ মে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100,000
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Philip Warner এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    SUTER ESTATES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    সচিব
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    পরিচালক
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    পরিচালক
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    BLYTHE-TINKER, Nigel Edwin
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    সচিব
    Top Farm
    High Street
    PE19 6RX Toseland
    Cambs
    British63851130001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    সচিব
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    HENSON, Mark Richard
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    সচিব
    5 Hazeland Steading
    PE10 0PW Morton
    Lincolnshire
    British104630800001
    LOWES, Richard Phillip
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    সচিব
    2 Westcott Keep
    RH6 9US Horley
    Surrey
    British5785520001
    PATON WALSH, Antony Edmund
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    সচিব
    60 Mount Ararat Road
    TW10 6PJ Richmond
    Surrey
    British43425770001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    সচিব
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    কর্পোরেট সচিব
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    69324550001
    ABELL, John David
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    The Old Rectory Main Street
    Branston By Belvoir
    NG32 1RU Grantham
    Lincolnshire
    United KingdomBritish71975220001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    EDWARDS, John Nigel
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    পরিচালক
    8b Avery Row
    Mayfair
    W1K 4AL London
    United KingdomBritish37742270003
    EDWARDS, John Nigel
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    পরিচালক
    976b Garratt Lane
    SW17 0ND London
    British37742270001
    FERGUSON, Daniel
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    33 The Avenue
    EN6 1EG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish29071630001
    FIRTH, Arthur Gregory
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Westridge House
    Belvoir Close
    Colsterworth
    Lincolnshire
    British17118450001
    FOLGER, Susan
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    পরিচালক
    12 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    British36525980001
    GRANT, John Albert Martin
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Malthouse Manor Lane
    Claverdon
    CV35 8NH Warwick
    Warwickshire
    EnglandBritish55161940001
    HEATHWOOD, Derek Kevin
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    পরিচালক
    47 Fullarton Crescent
    KA10 6LL Troon
    South Ayrshire
    British85468580002
    HEWITT, Alan
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    The White House Casthorpe Road
    Barrowby
    NG32 1DW Grantham
    Lincolnshire
    British572100002
    HOARE, Brian David
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    পরিচালক
    The Old Barn 32 High Street
    LE14 4AH Waltham On The Wolds
    Leicestershire
    British28340230001
    JONES, Morgan Lewis
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    পরিচালক
    4 Camden Close
    BR7 5PH Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish10146340003
    MEADE, Karl Robert
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Holly Mount
    Penn Road
    HP9 2TS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish118074370001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    REYNOLDS, Malcolm Stanley
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    পরিচালক
    74 Scatterdells Lane
    Chipperfield
    WD4 9EX Kings Langley
    Hertfordshire
    British10865710001
    RIDER, Stuart Granville
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    পরিচালক
    3 Kesteven Court
    North Parade
    NG31 8FP Grantham
    Lincolnshire
    British36675890002
    RILEY, Michael James
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    পরিচালক
    16 Ladbroke Road
    W11 3NJ London
    British3055390001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    পরিচালক
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    পরিচালক
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    পরিচালক
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001
    WATSON, Ian Richard
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Old Dove House
    Annables Lane
    AL5 3PR Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish68256540001
    WILLIAMS, John Benedict Alan
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    পরিচালক
    16 Oakwood Road
    Golders Green
    NW11 6QY London
    British79419360001
    ASCOT CORPORATE DIRECTORS LIMIYED
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    কর্পোরেট পরিচালক
    2 Heathrow Boulevard
    284 Bath Road
    UB7 0DQ West Drayton
    Middlesex
    67372750003

    SUTER ESTATES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Agent") as Agent and Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০৪ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুল, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mezzanine security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুল, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ আগ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each mezzanine obligor to the lender on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge all estates or interest in any f/h or l/h property now or subsequently owned by it, by way of fixed charge its interests in all investments now or subsequently held by it. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Warner Estate, Limited
    ব্যবসায়
    • ০১ আগ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুল, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed of debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property 2/22 yorkshire street, burnley t/n LA809118. F/h property the new inn roundabout, pontypool t/n WA583381, f/h property 15 fir tree road hastings t/n HT18815.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ আগ, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৯ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC,as Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of admission
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Omnibus debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ জুন, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ ফেব, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floaitng charges over undertaking and all property including property listed in schedule attached to doc M139 and assets present and future inlcuding uncalled capital with all buildings fixtures (including trade fixtures) fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মার্চ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৫ জুন, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of set-off
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ মে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ মে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Special omnibus letter of set off
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জুল, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum of sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জুল, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Special omnibus letter of set off
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জানু, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৭৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any present or future account of the company with lloyds bank limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৪ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    SUTER ESTATES LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৯ নভে, ২০১২ভেঙে গেছে
    ২৮ ফেব, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Stephen Gordon Franklin
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London
    অভ্যাসকারী
    Panos Eliades Franklin & Co Olympia House
    Armitage Road
    NW11 8RQ London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0