ADARE PILLINGS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামADARE PILLINGS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00120184
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ADARE PILLINGS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য প্রিন্টিং (18129) / উৎপাদন

    ADARE PILLINGS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Co Bdo Llp 1 Bridgewater Place
    Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ADARE PILLINGS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PILLINGS PRINTING COMPANY LIMITED১৫ আগ, ১৯৮৩১৫ আগ, ১৯৮৩
    MARMADUKE PILLING & SONS,LIMITED১০ ফেব, ১৯১২১০ ফেব, ১৯১২

    ADARE PILLINGS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ অক্টো, ২০১০

    ADARE PILLINGS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    14 পৃষ্ঠা4.72
    A5AMQT1U

    ০৮ মে, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    21 পৃষ্ঠা4.68
    A4B5PUQY

    ০৮ মে, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    16 পৃষ্ঠা4.68
    A3BPBY6B

    ০৮ মে, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    20 পৃষ্ঠা4.68
    A2C0FZXT

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01
    S1BH2Q8O

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ 4.19

    6 পৃষ্ঠা4.20
    A19FXLKI

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600
    Q190QEW2

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য অসামান্য রেজোলিউশন ০৯ মে, ২০১২ তারিখে

    LRESEX

    ০৪ নভে, ২০১১ তারিখে Kevin Arthur Herbert-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X165Q8FC

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ জানু, ২০১২

    ০৪ জানু, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,202
    SH01
    X0ZUEXA8

    পূর্ণ হিসাব ৩১ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA
    A8FGNROF

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    XK0FTR2I

    পূর্ণ হিসাব ৩১ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA
    AEISLJ68

    বার্ষিক রিটার্ন ০৪ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    XZCMNGFC

    ০৬ জানু, ২০১০ তারিখে Marrons Consultancies Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04
    XZCMMGFB

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225
    PG11EA0V

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a
    XH2YE6CA

    পূর্ণ হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    22 পৃষ্ঠাAA
    A28V85KC

    পূর্ণ হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    24 পৃষ্ঠাAA
    AX3UTXJD

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    পূর্ণ হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    26 পৃষ্ঠাAA

    ADARE PILLINGS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MARRONS CONSULTANCIES LIMITED
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Meridian South
    Meridian Business Park
    LE19 1WY Leicester
    1
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর01708508
    65475060002
    HERBERT, Kevin Arthur
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    পরিচালক
    Southfield Close
    Rufforth
    YO23 3RE York
    28
    EnglandBritishAccountant167011610001
    WHITESIDE, Robert
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    পরিচালক
    23 Millbeck Green
    LS22 5AJ Collingham
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director81547240001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    সচিব
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrishAccountant96288470001
    PILLING, Muriel Joyce
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    সচিব
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    British22257260002
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishCompany Director51120160001
    COLL, James Joseph
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    7 Elkwood
    Rathfarmham
    16 Dublin
    Ireland
    IrishPrinter51120160001
    CREAN, Patrick James
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    পরিচালক
    The Beeches Enniskerry Demense
    Enniskerry
    County Wicklow Eire
    IrelandIrishAccountant54812330001
    EVERARD, Clinton Edwin
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    পরিচালক
    Ballymoss
    Thursley Road Elstead
    GU8 6EB Godalming
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director\99667360001
    HARRIS, Robert Stanley
    2 Woodlands Close
    PR9 9PN Southport
    Merseyside
    পরিচালক
    2 Woodlands Close
    PR9 9PN Southport
    Merseyside
    United KingdomBritishSenior Executive113919560001
    HOYLE, James Herbert
    12 Guildway
    HX2 7RR Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    12 Guildway
    HX2 7RR Halifax
    West Yorkshire
    BritishWorks Director105124940001
    LACEY, Janice Clare
    121 Commercial Road
    Skelmanthorpe
    HD8 9DX Huddersfield
    পরিচালক
    121 Commercial Road
    Skelmanthorpe
    HD8 9DX Huddersfield
    BritishSales Director34941350001
    LOANE, Beaufort Nelson
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    পরিচালক
    1 Rathdown Crescent
    IRISH Terenure
    Dublin 6
    Ireland
    IrishAccountant78428900001
    LYNCH, Peter Eugene
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    পরিচালক
    45 Holmwood,
    Brennastown Road
    IRISH Dublin 18
    Republic Of Ireland
    IrelandIrishAccountant96288470001
    MARSH, Edward William
    1 Cornwall Crescent
    Diggle
    OL3 5PW Oldham
    Lancashire
    পরিচালক
    1 Cornwall Crescent
    Diggle
    OL3 5PW Oldham
    Lancashire
    BritishCommercial Director40368550001
    O TIGHEARNAIGH, Cormac
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    পরিচালক
    56 Hillside
    IRISH Dalkey
    County Dublin
    Ireland
    IrishAccountant84690240001
    PILLING, Derek Frank Marmaduke
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    BritishDirector7143260002
    PILLING, John Edgar
    70 Meadowvale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    70 Meadowvale
    Outwood
    WF1 3TD Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDirector22257290002
    PILLING, Kenneth Marmaduke
    100 Green Lane
    Greetland
    HX4 8BL Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    100 Green Lane
    Greetland
    HX4 8BL Halifax
    West Yorkshire
    BritishTaxi Business Proprietor22257270001
    PILLING, Marmaduke
    67 Victoria Road
    HX5 0QA Elland
    West Yorkshire
    পরিচালক
    67 Victoria Road
    HX5 0QA Elland
    West Yorkshire
    BritishRetired22257330001
    PILLING, Muriel Joyce
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    26 Grange Park
    Skircoat Moor Road
    HX3 0JS Halifax
    West Yorkshire
    BritishSecretary22257260002
    PILLING, Richard David
    Water Hill Springs Water Hill Lane
    Warley
    HX2 7SG Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Water Hill Springs Water Hill Lane
    Warley
    HX2 7SG Halifax
    West Yorkshire
    BritishManaging Director22257310002
    STANLEY, Richard
    8/9 Cockhill Lane
    Shelf
    HX3 7LP Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    8/9 Cockhill Lane
    Shelf
    HX3 7LP Halifax
    West Yorkshire
    BritishSales Director Creative22257300001
    WADSWORTH, John David
    211 Oakwood Lane
    Roundhay
    LS8 2PE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    211 Oakwood Lane
    Roundhay
    LS8 2PE Leeds
    West Yorkshire
    BritishSales Director-Printing22257320001

    ADARE PILLINGS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee (as security trustee for the security beneficiaries (as defined)) (the "security trustee") under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior loan agreement and /or the senior note documents (all as defined) to which such charging company is a party on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings k/a pillings printing premises being land on the north side of elland lane elland west yorkshire t/no: WYK417419.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of accession to a composite guarantee and debenture dated 14 july 2000
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each charging company (as defined) to the chargee and the security beneficiaries (as defined) under the banking documents, the mezzanine loan agreement and/or the senior note documents (all as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland, as Security Trustee for the Securitybeneficiaries
    ব্যবসায়
    • ০৮ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattles mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 used heidelberg web-8 five unit press manufactured in 1987 serial no 402 103.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Forward Trust Group Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee and to the beneficiaries (as defined) or any of them on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks Plcsin It's Capacity as Trustee for the Beneficiarie
    ব্যবসায়
    • ০৯ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ মে, ২০০৩বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৬ জুল, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge supplemental to a debenture dated 31ST july 1992 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ সেপ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the aforesaid debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all rights,title and interest in a factoring or invoice discounting deed dated 1/8/95...................all book/other debts. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ সেপ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge over book debts
    তৈরি করা হয়েছে ০১ আগ, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under a factoring agreement leasing agreement or otherwise in any manner whatsoever including all liabilities in connection with or under guarantees indemnities documentary or other credits or any instruments whatsoever from time to time assumed or entered into
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First the ultimate balance due or owing to the company by tih under any factoring agreement providing for the purchase by tih of book debts of the company and the balance due or owing to the company by tih under a factoring agreement dated 1 august 1995 and secondly all other book and other debts due or owing. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Trade Indemnity-Heller Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Corporate mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities for the time being owing or incurred by the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 5TH april 1994 including any modification or replacement thereof
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    8 unit didde machine serial no. 450-0025. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ সেপ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,487.98 under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights title interest in and to all sums payable under the insurances.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ জুন, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC.
    ব্যবসায়
    • ০৭ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩১ জুল, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of land situate near to the cross elland west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of land situate near to westgate elland west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of land with the petrol store on part thereof situate of northgate elland west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of land and premises situate off westgate elland west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of land with the two garages on part thereof situate off northgate elland west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and building on the north side of westgate elland west yorkshire t/n wyk 247044.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ ডিসে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north west side of westgate elland west yorkshire t/n wyk 149637.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plot of land of elland lane, elland west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ অক্টো, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £720
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and premises known as the london house, the cross, elland, yorks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Halifax Equitable Benefit Building Society
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯১২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ সেপ, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    ADARE PILLINGS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৯ মে, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১২ অক্টো, ২০১৬ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Francis Graham Newton
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    1 Bridgewater Place Water Lane
    LS11 5RU Leeds
    West Yorkshire
    Mark James Shaw
    55 Baker Street
    W1U 7EU London
    অভ্যাসকারী
    55 Baker Street
    W1U 7EU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0