TERMINUS 45 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTERMINUS 45 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00129931
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TERMINUS 45 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2224) /

    TERMINUS 45 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TERMINUS 45 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    POLESTAR DIGITAL WATFORD LIMITED০৬ নভে, ১৯৯৮০৬ নভে, ১৯৯৮
    BPC DIGITAL WATFORD LTD৩১ অক্টো, ১৯৯৬৩১ অক্টো, ১৯৯৬
    BPC DIGITAL MAGAZINES (WATFORD) LTD২৪ মে, ১৯৯৬২৪ মে, ১৯৯৬
    BPC WEST LONDON STUDIO LTD১৮ জানু, ১৯৯৪১৮ জানু, ১৯৯৪
    BPCC WEST LONDON STUDIO LTD০৪ মে, ১৯৮৯০৪ মে, ১৯৮৯
    LONDON TYPESETTING CENTRE LIMITED২৯ আগ, ১৯৮৪২৯ আগ, ১৯৮৪
    TOM BROWNE ESTATES LIMITED০৩ জুল, ১৯১৩০৩ জুল, ১৯১৩

    TERMINUS 45 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৯

    TERMINUS 45 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১০ থেকে ৩০ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১০ মে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ অক্টো, ২০১০

    ২০ অক্টো, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 6,576
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৪ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    TERMINUS 45 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    সচিব
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    পরিচালক
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    পরিচালক
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    HEYES, Jeffrey Andrew
    31 Sunny Bank
    S81 0BH Worksop
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    31 Sunny Bank
    S81 0BH Worksop
    Nottinghamshire
    BritishGeneral Manager48115220002
    HOLLORAN, Peter John
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Southmoor Farmhouse
    Stonehill Lane Southmoor
    OX13 5HU Abingdon
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive61418710001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    পরিচালক
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    PRUE, Paul Roy
    4 Grieg Close
    SG17 5SE Shefford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    4 Grieg Close
    SG17 5SE Shefford
    Bedfordshire
    BritishPrinter73094850001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive44908110001
    THOMAS, Gregory Barrie
    86 Barnehurst Road
    DA7 6HB Bexleyheath
    Kent
    পরিচালক
    86 Barnehurst Road
    DA7 6HB Bexleyheath
    Kent
    BritishStudio Director50399460001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    পরিচালক
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003

    TERMINUS 45 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Restated amendment of and accession to the composite guarantee & debenture dated 19/06/98
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) or Such Otherperson as May from Time to Time Be Appointed Security Agent and Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and all liabilities now or hereafter due owing or incurred by the company to the security parties (as defined) or any of them under the terms of the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 2 the courtyards (unit 3B) phoenix square wyncolls road colchester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and discharging of all liabilities now or hereafter due, owing or incurred by the company and/or all or any of the other companies named therein (the "original UK charging subsidiaries") to the chargee in its capacity as security trustee for the banks, the agent, the security trustee, the arranger, the ancillary banks and the hedge counterparties (all as defined therein) or any of them including, without limitation, all moneys, liabilities due, owing or incurred under or pursuant to the facilities agreement, the debenture, the ancillary documents and/or any of the other finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 5 culley way maidenhead t/n BK111256, f/h 71 portlock road maidenhead t/n BK30684, 2 fielding road maidenhead t/n BK130387, for details of the further properties in england and the l/h property in scotland charged please refer to form M395, fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery, see ch microfiche for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See charge particulars form for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chemical Investment Bank Limitedas Security Agent (As Defined Therein)
    ব্যবসায়
    • ০৮ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ডিসে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the british printing company LTD to the chargee under the terms of the restated facilities (as defined therein) and this deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Charged under the security documents (as defined) to which the company is a party. Undertaking and all property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bank Therein)as Agent and Trustee for the Lenders (As Defined
    ব্যবসায়
    • ০৫ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from bucksmere limited under a facilities agreement dated 21ST dec 1988. all moneys due from the company under the facilities agreement in respect of the overdraft facilities as defined in the deed and all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.Raft Bankas Agent and Trustee for the Banks and the Overd
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from bucksmere limited under the terms of the mezzanine facilities agreement dated 21ST dec 1988 all monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee as agent and trustee for the lenders as defined in the deed.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form O95 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Standard Chartered Bankas Agent and Trustee for the Lenders
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৬ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ এপ্রি, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মে, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all f/h & l/h properties fixed & floating charge over the undertaking & all property & assets both present & future including goodwill book debts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ মে, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from bpc limited to the chargee not exceeding ukp 13,000,000 under the terms of a deed 18 dec 1967 & deeds supplemental thereto.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0