MORRISFLEX LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMORRISFLEX LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00134022
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MORRISFLEX LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম পণ্য উৎপাদন (23910) / উৎপাদন

    MORRISFLEX LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Spring Road
    Ibstock
    LE67 6LR Leicestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MORRISFLEX LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HOLBORN ENGINEERS LIMITED১৭ ফেব, ১৯১৪১৭ ফেব, ১৯১৪

    MORRISFLEX LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    MORRISFLEX LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ২৫ এপ্রি, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    9 পৃষ্ঠা4.68

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    8 পৃষ্ঠা4.71

    ২১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠা4.68

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    দেউলিয়া রেজোলিউশন

    Resolution INSOLVENCY:resolution re. Powers of liquidator
    1 পৃষ্ঠাLIQ MISC RES

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ২২ ডিসে, ২০১৫ তারিখে

    LRESSP

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ আগ, ২০১৫

    ২৬ আগ, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 84,908
    SH01

    ০৪ ফেব, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 99 Commercial Square Freemens Common Leicester Leicestershire LE2 7SR থেকে Spring Road Ibstock Leicestershire LE67 6LRপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ আগ, ২০১৪

    ০৬ আগ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 84,908
    SH01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৫ আগ, ২০১৩

    ০৫ আগ, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    শেয়ার শ্রেণীর নাম বা পদবী পরিবর্তন

    2 পৃষ্ঠাSH08

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    44 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    শেয়ারের অধিকার বা নাম পরিবর্তনের রেজুলেশন

    RES12
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    পরিচালক হিসাবে Richard Mayers এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    legacy

    16 পৃষ্ঠাMG01

    পরিচালক হিসাবে Richard Mayers-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Paul Moore-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Peter Crowley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    MORRISFLEX LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GARLAND, Anne
    Kileshandra
    Druminiskill
    Cavan
    Ireland
    সচিব
    Kileshandra
    Druminiskill
    Cavan
    Ireland
    Irish137648650001
    COSGROVE, Peter
    Fortfield Drive
    Terenure
    Dublin
    31
    Ireland
    পরিচালক
    Fortfield Drive
    Terenure
    Dublin
    31
    Ireland
    IrelandIrishDirector129613430001
    MOORE, Paul Gerard
    Simmonstown Park
    Celbridge
    3
    Kildare
    Ireland
    পরিচালক
    Simmonstown Park
    Celbridge
    3
    Kildare
    Ireland
    IrelandIrishFinance Director53224850001
    HOBDAY, Alan Arthur
    69 Tilehouse Green Lane
    Knowle
    B93 9EU Solihull
    West Midlands
    সচিব
    69 Tilehouse Green Lane
    Knowle
    B93 9EU Solihull
    West Midlands
    British33984620001
    LEMOND, Brian Hugh
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    সচিব
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    BritishDirector490160004
    LYNCH, Carmel
    Virginia
    County Cavan
    Rahardrum
    Ireland
    সচিব
    Virginia
    County Cavan
    Rahardrum
    Ireland
    BritishNone130841320001
    MCGOWAN, Neil
    Killeen Road
    Rathmines
    37
    Dublin 6
    Ireland
    সচিব
    Killeen Road
    Rathmines
    37
    Dublin 6
    Ireland
    British128891990001
    THEAKER, Jeremy Robert
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    সচিব
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    British65284290001
    THEAKER, Jeremy Robert
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    সচিব
    16 Collingwood Avenue
    Bilton
    CV22 7EX Rugby
    Warwickshire
    British65284290001
    AGNEW, Paul Raymond Barratt
    19 Druids Court
    Newtown Mount Kennedy
    Co. Wicklow
    Eire
    পরিচালক
    19 Druids Court
    Newtown Mount Kennedy
    Co. Wicklow
    Eire
    GermanyBritishDirector94248530001
    CROWLEY, Peter Magner
    Sloperton Lodge
    Sloperton
    IRISH Monkstown
    Co. Dublin
    পরিচালক
    Sloperton Lodge
    Sloperton
    IRISH Monkstown
    Co. Dublin
    IrelandIrishDirector122150210001
    EVANS, Richard Anthony
    11 Home Farm Close
    Witherley
    CV9 3SP Atherstone
    Warwickshire
    পরিচালক
    11 Home Farm Close
    Witherley
    CV9 3SP Atherstone
    Warwickshire
    BritishMarketing Director16187070001
    GATHERCOLE, John Robert
    30 Wolsey Road
    CV22 6LW Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    30 Wolsey Road
    CV22 6LW Rugby
    Warwickshire
    BritishEngineering Director16187050001
    GOULD, Ian David
    101 Frobisher Road
    CV3 6LZ Coventry
    West Midlands
    পরিচালক
    101 Frobisher Road
    CV3 6LZ Coventry
    West Midlands
    BritishOperations Director82574090001
    GRAINGER, Laurence Douglas
    Mid Balfunning Farm
    Balfron Station Balfron
    G33 0NF Glasgow
    পরিচালক
    Mid Balfunning Farm
    Balfron Station Balfron
    G33 0NF Glasgow
    ScotlandBritishDirector52231560001
    LEMOND, Brian Hugh
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    18 Thorn Road
    Bearsden
    G61 4PP Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritishDirector490160004
    LIBBY, Terence Allan
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManaging Director16187060001
    LIBBY, Terence Allan
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Snorscomb Mill
    Everdon
    NN11 3BJ Daventry
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManaging Director16187060001
    MAYERS, Richard Daniel
    Allfarthing Lane
    SW18 6PQ London
    14
    England
    পরিচালক
    Allfarthing Lane
    SW18 6PQ London
    14
    England
    EnglandBritishChartered Accountant183644580001
    MCGARRY, Nicholas Scott
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomEnglishDirector130841260002
    MCGARRY, Nicholas Scott
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Glenfield Frith Drive
    Glenfield
    LE3 8PQ Leicester
    6a
    Leicestershire
    United Kingdom
    United KingdomEnglishSales Director130841260002
    WILSON, William Stuart
    M/S Oilfields Supply Centre
    Jebel Ali Building No 24 PO BOX 1518
    Dubai
    United Arab Emirates
    পরিচালক
    M/S Oilfields Supply Centre
    Jebel Ali Building No 24 PO BOX 1518
    Dubai
    United Arab Emirates
    United Arab EmiratesBritishDirector78390007

    MORRISFLEX LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ২০১৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargors
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Grand building 1-3 strand london fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mml Capital Europe V Sa
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ২০১৩একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ অক্টো, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the chargor or any of them to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Allied Irish Banks PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ অক্টো, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ এপ্রি, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £100,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Used unison 2600 fgs mini tool grinder serial number 138.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lombard North Central PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The following property :- unison model 8,000 cnc flute grinding machine serial no 059 and the proceeds and produects thereof. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royscot Trust PLC Together with Royscot's Successors (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Stage payment agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ জুন, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of this agreement being a maximum of £168,619.00 plus interest thereon
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge all the company's right title and interest from time to time in the following goods and each part thereof: the goods being unison model 8,000 cnc flute grinding machine, serial no. 059.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royscot Trust PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ জুন, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unison model 8000 cnc flute grinding machine serial N0 048. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royscot Trust PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Stage payment agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the companys rights title and interest in the following goods and each part thereof:- unison model 8,000 cnc flute grinding machine serial no 048. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royscot Trust PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Brown & ward model af-874A1 (please see 395 M317 for details of further plant machinery & chattels) together with all additions alterations accessories replacements and renewals.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    One new model 8000-5 axis burr grinder (nc tool & cutter) serial number 8000-010.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Forward Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s) of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ জুল, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All property detailed on form 395 relevant to this charge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২২ জুল, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Guarantee &
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুন, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুন, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুন, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Supplemental legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over book debts and other debts due and owing to the company both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুন, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ মে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee &
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জুন, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or flexwheel limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জুন, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital with all buildings, fixtures, fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation LTD
    ব্যবসায়
    • ২৪ অক্টো, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ নভে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    MORRISFLEX LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২২ ডিসে, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৫ আগ, ২০১৭ভেঙে গেছে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Brigid Daly
    One Spenser Dock North Wall Quay
    Dublin
    Ireland
    অভ্যাসকারী
    One Spenser Dock North Wall Quay
    Dublin
    Ireland

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0