SHOE ZONE RETAIL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSHOE ZONE RETAIL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00148038
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বিশেষায়িত স্টোরগুলিতে জুতার খুচরা বিক্রয় (47721) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SHOE ZONE LIMITED২২ জানু, ২০০১২২ জানু, ২০০১
    BENSON SHOE LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১
    BENSON SHOE COMPANY,LIMITED২১ জুল, ১৯১৭২১ জুল, ১৯১৭

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০২৩

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ জুন, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৫ জুন, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ জুন, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    53 পৃষ্ঠাAA
    AD52CQKK

    ০১ জুন, ২০২৪ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01
    XD4GGDSP

    ৩০ নভে, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Steven David Orr এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    XCHCT183

    ১২ সেপ, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Zoe Black-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    XCBYCSVV

    পূর্ণ হিসাব ০১ অক্টো, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    57 পৃষ্ঠাAA
    AC4U9IOI

    ০১ জুন, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01
    XC4QAOJT

    ১৩ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে Mr John Charles Pennington Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XC1DF9P7

    ০৫ আগ, ২০২২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Clare Alison Howes এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    XB9XKOYR

    ২৭ জুল, ২০২২ তারিখে Mrs Catherine Anne Bowen-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XB945THT

    ১৯ জুল, ২০২২ তারিখে Mr Terry Michael Boot-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XB8LEZD7

    ০১ জুন, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01
    XB58OY9T

    পূর্ণ হিসাব ০২ অক্টো, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    59 পৃষ্ঠাAA
    AB4MBYAA

    ০৪ জানু, ২০২২ তারিখে Mr Anthony Edward Pennington Smith-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    XAUY5Z0R

    পূর্ণ হিসাব ০৩ অক্টো, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    56 পৃষ্ঠাAA
    AA7P0DIZ

    ০১ জুন, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01
    XA65Z716

    ০১ এপ্রি, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Catherine Anne Bowen-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    XA1J9997

    ০৮ মার্চ, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Terry Michael Boot-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X9ZVCQWG

    ১৯ ফেব, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter John Lewis Foot এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    X9YWJ92B

    ৩১ জুল, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Lee Fearn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    X9AQ0HO1

    ০৬ জুল, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Peter John Lewis Foot-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X99C0JOP

    ০১ জুন, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01
    X96AOYM8

    চার্জ 74 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04
    X94YXXFL

    চার্জ নিবন্ধন 001480380075, ২৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    10 পৃষ্ঠাMR01
    X91W6MMX

    পূর্ণ হিসাব ০৫ অক্টো, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    41 পৃষ্ঠাAA
    A90BZITV

    ০৯ ডিসে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Steven David Orr-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X8JYCS69

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BOWEN, Catherine Anne
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    262122010001
    BLACK, Zoe
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishBuying Director313465430001
    BOOT, Terry Michael
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector67041160002
    BOWEN, Catherine Anne
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandWelshSolicitor281601560002
    SMITH, Anthony Edward Pennington
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    United KingdomEnglishChairman51176590003
    SMITH, John Charles Pennington
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer72832190017
    BROWN, Gary
    Swallow Rise
    4 Dunsmore Heath
    CV22 6TR Dunchurch
    Warwickshire
    সচিব
    Swallow Rise
    4 Dunsmore Heath
    CV22 6TR Dunchurch
    Warwickshire
    British94339190001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    সচিব
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    HENNELL, Lee Spencer
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    220079950001
    PHILLIPS, Keith Richard
    19 Pepper Drive
    Quorn
    LE12 8TT Loughborough
    Leicestershire
    সচিব
    19 Pepper Drive
    Quorn
    LE12 8TT Loughborough
    Leicestershire
    BritishAccountant66040790001
    ZANKER, David John
    17 Elm Tree Avenue
    Glenfield
    LE3 8QA Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    17 Elm Tree Avenue
    Glenfield
    LE3 8QA Leicester
    Leicestershire
    British15872820001
    BLOOR, Charles Richard
    The Beeches
    Uppingham
    LE15 9PG Oakham
    31
    Rutland
    England
    পরিচালক
    The Beeches
    Uppingham
    LE15 9PG Oakham
    31
    Rutland
    England
    United KingdomBritishOperaition Director135309610002
    BLOOR, Charles Richard
    1 Hogg Lane
    Hallaton
    LE16 8UE Market Harborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    1 Hogg Lane
    Hallaton
    LE16 8UE Market Harborough
    Leicestershire
    BritishAccountant125077830001
    BOWER, Richard Guy
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishMerchandise Director126483050001
    BOWER, Richard Guy
    15 Forresters Road
    Burbage
    LE10 2RU Hinckley
    Leicestershire
    পরিচালক
    15 Forresters Road
    Burbage
    LE10 2RU Hinckley
    Leicestershire
    BritishMerchandise Director59506180001
    BROWN, Gary
    Swallow Rise
    4 Dunsmore Heath
    CV22 6TR Dunchurch
    Warwickshire
    পরিচালক
    Swallow Rise
    4 Dunsmore Heath
    CV22 6TR Dunchurch
    Warwickshire
    BritishFinance Director94339190001
    BROWN, Steven David Russell
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 3XW Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    2 Wheathill Grove
    Littleover
    DE23 3XW Derby
    Derbyshire
    BritishFinance Director86874590001
    DAVIS, Nicholas John
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishChief Executive Officer117313030003
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    পরিচালক
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    BritishManaging Director52124910001
    FEARN, Jonathan Lee
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishAccountant211402560002
    FOOT, Peter John Lewis
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishFinancial Director272018690001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    BritishFinance Director51176110002
    FRENCH, Brian Blake
    15 Granary Close
    LE8 0LP Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    পরিচালক
    15 Granary Close
    LE8 0LP Kibworth Beauchamp
    Leicestershire
    BritishJoint Managing Director17261670001
    HOWES, Clare Alison
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishBuying Director88780970002
    LEWIS, Wendy
    1 Chandlers Croft
    LE67 6PR Ibstock
    Leicestershire
    পরিচালক
    1 Chandlers Croft
    LE67 6PR Ibstock
    Leicestershire
    BritishMarketing Director72832320003
    MURPHY, Daniel Louis
    Flat 3 8 Oxford Road North
    Chiswick
    W4 4DN London
    পরিচালক
    Flat 3 8 Oxford Road North
    Chiswick
    W4 4DN London
    BritishBuying & Merchandising Directo51176380001
    ORR, Steven David
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishOperations Director265153550001
    ORR, Steven David
    Bates Close
    LE1 2LH Market Harborough
    10
    Leicestershire
    পরিচালক
    Bates Close
    LE1 2LH Market Harborough
    10
    Leicestershire
    United KingdomBritishDirector265153550001
    PHILLIPS, Keith Richard
    19 Pepper Drive
    Quorn
    LE12 8TT Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    19 Pepper Drive
    Quorn
    LE12 8TT Loughborough
    Leicestershire
    BritishCommercial Director66040790001
    PORTER, Derek Charles
    43 Main Street
    Fleckney
    LE8 8AP Leicester
    পরিচালক
    43 Main Street
    Fleckney
    LE8 8AP Leicester
    BritishProperty Director69696190001
    SHEFFORD-THOMAS, Naomi Tamar
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    Haramead Business Centre
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishMarketing Director124834810002
    SMITH, Christopher James
    Crackbottle Lodge
    Keythorpe
    LE7 9XG Leicester
    পরিচালক
    Crackbottle Lodge
    Keythorpe
    LE7 9XG Leicester
    BritishManaging Director15872840001
    SMITH, Michael John
    Old Mill House
    Swingbridge Street Foxton
    LE16 7RH Market Harborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    Old Mill House
    Swingbridge Street Foxton
    LE16 7RH Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritishChairman17286290002
    WASSALL, Graham Wainwright
    Manor Cottage Manor Lane
    Somerby
    LE14 2QD Melton Mowbray
    Leicestershire
    পরিচালক
    Manor Cottage Manor Lane
    Somerby
    LE14 2QD Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritishJoint Managing Director48454540001

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Haramead Business Centre
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Humberstone Road
    LE1 2LH Leicester
    Haramead Business Centre
    England
    না
    আইনি ফর্মPlc
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Acts
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর8961190
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    SHOE ZONE RETAIL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০২০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ২০২০
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ মার্চ, ২০২০একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৩ মে, ২০২০একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £32,934.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a 33/35 clayton street newcastle upon tyne.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Council of the City of Newcastle upon Tyne
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ এপ্রি, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of michael smith to the value of £157,175.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of richard bower to the value of £100,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of anthony smith to the value of £500,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of keith phillips to the value of £100,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage of life policy
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The policy in respect of charles smith to the value of £100,000.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    179 high street tunstall stoke on trent staffs. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    17 wide bargate boston. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ জুন, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    59-61 cape hill smethwick warley east midlands B66 4SF. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Messurage dwellinghouse at retail shop situate at no.66 High street mablethorpe. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    66 high street mablethorpe lincolnshire; 59 and 61 cape hill smethwick warley west midlands t/no: WM5933; 17 wide bargate boston (including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • M.J. Smith
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 17 wide bar gate boston lincs. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 66 high street mablethorpe lincs. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 59 & 61 cape hill smethwick warley t/n WM5933. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ ফেব, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 22 connswater shopping centre townland of ballyhackamore parish of holywood barony of castlereagh lower and county borough of belfast under a lease dated 1/4/93 (as DEFINED0; all rights,licences,guarantees,etc; the goodwill of business. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 2 ards shopping centre,newtownards,county down under a lease dated 21/7/94 (as defined); all rights,licences,guarantees,contract deeds,warranties,etc; the goodwill of business. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the east side of albion street, leeds t/no. WYK560495 with the benefit of all rights etc., any goodwill of any business, any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    47 southwater (formerly unit 39) the telford centre with the benefit of all rights etc., any goodwill of any business, any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    8 long wyre street colchester and goodwill of any business. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Unit 46 (23 town wall) the st david's centre cardiff.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    8 union street swansea t/n-WA155204 with the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property;.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0