L.R.RUSSELL LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামL.R.RUSSELL LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00156981
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    L.R.RUSSELL LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    L.R.RUSSELL LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Wyevale Garden Centres Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Middlesex
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    L.R.RUSSELL LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৭ ডিসে, ২০১৫

    L.R.RUSSELL LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Justin Matthew King এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৭ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    Nils Olin Steinmeyer কে পরিচালক হিসাবে অবসানের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    4 পৃষ্ঠাRP04TM01

    Kevin Michael Bradshaw কে পরিচালক হিসাবে অবসানের জন্য দ্বিতীয় দাখিল

    4 পৃষ্ঠাRP04TM01

    ১৮ আগ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Justin Matthew King-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১৮ আগ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Thomas Murphy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২২ জুল, ২০১৬ তারিখে Mr Anthony Gerald Jones-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ মে, ২০১৬

    ১৮ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Stephen Thomas Murphy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Roger Mclaughlan-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Nils Olin Steinmeyer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২২ সেপ, ২০১৬Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016

    ০৬ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Anthony Gerald Jones-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১০ মার্চ, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Michael Bradshaw এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01
    অ্যানোটেশন
    তারিখঅ্যানোটেশন
    ২২ সেপ, ২০১৬Clarification A second filed TM01 was registered on 22/09/2016.

    ২৩ ফেব, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JF থেকে Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JFপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২২ মে, ২০১৫

    ২২ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    ২২ মে, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা The Garden Centre Group Syon Park Brentford Middlesex TW8 8JF থেকে Wyevale Garden Centres Syon Park London Road Brentford Middlesex TW8 8JFপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৯ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ মে, ২০১৪

    ১৯ মে, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr Kevin Michael Bradshaw-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    L.R.RUSSELL LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    JONES, Anthony Gerald
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCfo212265950001
    MCLAUGHLAN, Roger
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCeo206428840001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    সচিব
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    British50457500001
    JONES, Anthony David
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    সচিব
    14 Brownhill Crescent
    LE7 7LA Rothley
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant73622510001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    সচিব
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    PEARCE, Patrick John
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    সচিব
    Blue Cedars Bunces Lane
    Burghfield Common
    RG7 3DL Reading
    Berkshire
    British28975060001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    সচিব
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    BritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    সচিব
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    British1470160001
    BRADSHAW, Kevin Michael
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    EnglandBritishCompany Director124019940001
    BRIGDEN, Peter
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    পরিচালক
    16 Woodstock Gardens
    Appleton
    WA4 5HN Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishDirector Of Retail Operation195802400001
    CAUNCE, John Geoffrey
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    পরিচালক
    16 Beaconsfield Road
    Claygate
    KT10 0PW Esher
    Surrey
    BritishCompany Director1470170001
    FAVELL, Gary Alan
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    পরিচালক
    Yates House Foldshaw Lane
    Braithwaite
    HG3 4AN Harrogate
    Yorks
    United KingdomBritishChief Executive107699240001
    FORREST, David Mervyn
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    পরিচালক
    Clouds Farm
    Drayton
    TA10 0JT Langport
    Somerset
    BritishCompany Director50457500001
    HEWITT, Robert John
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    পরিচালক
    The Old Cider Mill 2 Cotts Farm
    Cotts Lane
    HR1 3ND Lugwardine
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director15486070002
    HODKINSON, James Clifford
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    পরিচালক
    29b Western Avenue
    Branksome Park
    BH13 7AN Poole
    Dorset
    EnglandBritishCompany Director606430001
    JENKINSON, Antonia Scarlett
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishInvestment Banker72128340003
    KING, Justin Matthew
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishDirector213157990001
    KOZLOWSKI, Richard Leon
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    34 Stubbs Wood
    HP6 6EX Amersham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector124967710001
    LIVINGSTON, William Andrew
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    পরিচালক
    3 Barnes Close
    St Cross
    SO23 9QX Winchester
    Hampshire
    EnglandBritishCommercial Director111439220001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    TW8 8JF Brentford
    The Garden Centre Group
    Middlesex
    England
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MARSHALL, Nicholas Charles Gilmour
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    পরিচালক
    Glan Honddu House
    Llandefaelog Fach
    LD3 9PP Brecon
    Powys
    WalesBritishCompany Director1470180001
    MURFIN, Stephen
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    পরিচালক
    The Kymin
    Westhide
    HR1 3RG Hereford
    Herefordshire
    BritishCompany Director8690590001
    MURPHY, Stephen Thomas
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishChairman207509410001
    PRICE, Glyn John
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    পরিচালক
    Mill End
    Ash Ingen Mews Bridstow
    HR9 6QA Ross On Wye
    Herefordshire
    United KingdomBritishCompany Director73470720001
    RATCLIFFE, Sarah Elizabeth
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    পরিচালক
    59b Grange Road
    SM2 6SP Sutton
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director76162020001
    SPENCER SMITH, Thomas Peter
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Llanvetherine
    NP7 8RG Abergavenny
    Gwent
    BritishCompany Director1470160001
    STEINMEYER, Nils Olin
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Syon Park
    London Road
    TW8 8JF Brentford
    Wyevale Garden Centres
    Middlesex
    England
    United KingdomGermanFinancial Director126422100002
    STEVENSON, Barry John
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Cherry Trees
    Cane End
    RG4 9HG Reading
    Berkshire
    EnglandBritishCompany Director102595670001
    VAUGHAN, David John
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    পরিচালক
    Bryn Cain
    Penpergwm
    NP7 9AE Abergavenny
    Gwent
    United KingdomBritishSolicitor44521810001

    L.R.RUSSELL LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ ফেব, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All of its mortgaged property,investments,plant and machinery,credit balances see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bank of Scotland PLC (The “Security Agent”)
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মে, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জানু, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property descrided as land on the north west side of london road windlesham surrey t/n SY252220 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ জানু, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property described as lavershot court north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জানু, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property described as land adjoining lavershot hall on the north west side of london road windlesham surrey and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জানু, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a lavershot court on the north west side of london road (formerly k/a high road) windlesham surrey tog with fixed plant machinery and other fixtures title no SY252220 and the goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to national westminster bank PLC as security trustee for itself and the secured parties (as defined) on any account whatsoever under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please see doc M3 for further details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on north west side of london road windlesham, surrey heath, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within bills of sale acts 1878-1882) of the goodwill of the business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel & Co Limited.
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ নভে, ১৯৯১বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or country gardens PLC to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north west side of london road windlesham and 1 & 2 homestead cottages london road, together with floating charge over all plant machinery & other fixtures (not being personal chattels within the bills of sale acts 1878-1882) and the goodwill of the business.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hill Samuel & Co Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ নভে, ১৯৯১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H richmond nurseries london road, windlesham, surrey title no sy 252220.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on N.W. side of london road, windlesham, surrey tog with land on the N.W. side of the basingstoke to staines road, windlesham surrey. Title nos: sy 252220 sy 220671.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ নভে, ১৯৭২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৭২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets and present and future including goodwill uncalled capital by way of first fixed & floating charge. See doc 99.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ১৯৭২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Inst of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ ফেব, ১৯৫৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৫৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due etc.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land in parish of windlesham surrey, on n/w side of load leading from basingstoke to staines formerly forming part of property comprised in title no sy 208127 known as elsinore estate.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Westminster Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৫৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Series of debentures
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৩৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ১৯৩৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ১৯৩৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0