SELECTA REFRESHMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSELECTA REFRESHMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00157122
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Finway Road Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SELECTA UK LIMITED২০ জানু, ২০০৩২০ জানু, ২০০৩
    VENDEPAC LIMITED০১ মে, ১৯৯৮০১ মে, ১৯৯৮
    TM GROUP LIMITED১২ মে, ১৯৮৬১২ মে, ১৯৮৬
    MAYFAIR GROUP LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১
    STANDARD TOBACCO COMPANY LIMITED১৬ জুল, ১৯১৯১৬ জুল, ১৯১৯

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২২

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ মার্চ, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৫ নভে, ২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Apollo House, Odyssey Business Park West End Road Ruislip HA4 6QD England থেকে 1 Finway Road Finway Road Hemel Hempstead Industrial Estate Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 7PTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ২৮ মার্চ, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ মার্চ, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ এপ্রি, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Anthony Michael Leon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ এপ্রি, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Paul Nathaniel Ian Hearne-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    68 পৃষ্ঠাPARENT_ACC

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2

    ২০ অক্টো, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Anthony Michael Leon-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২০ অক্টো, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Marta Schwartz এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৮ মার্চ, ২০২০ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ সেপ, ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    25 পৃষ্ঠাAA

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ০১ সেপ, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Marta Schwartz-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HEARNE, Paul Nathaniel Ian
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritishDirector124527170003
    VRIJLANDT, Jan Marck
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Finway Road
    Hemel Hempstead Industrial Estate
    HP2 7PT Hemel Hempstead
    1 Finway Road
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutchManaging Director201873380001
    BAKER, Roger Owen
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    সচিব
    Ampfield House
    Blackheath
    GU4 8RD Guildford
    Surrey
    BritishFinance Director18801330003
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    সচিব
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    সচিব
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    BritishDirector32104690001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    সচিব
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    British12314170002
    MERCER, Roderick
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    সচিব
    Charvil Lane
    Sonning
    RG4 6TH Reading
    Slipe
    Berkshire
    BritishFinance Director129465490001
    MILLER, Simon Jonathan
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    সচিব
    Crabtrees
    CB11 3BH Saffron Walden
    12
    Essex
    British88269280001
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    সচিব
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Selecta Uk Ltd
    Hampshire
    British147336500001
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    সচিব
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    ABRAHAMS, Daniel Henry
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    পরিচালক
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector183822370001
    BATE, David Martin
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    পরিচালক
    9 Harptree Close
    BS48 4YT Nailsea
    Morgan's View
    North Somerset
    United Kingdom
    BritishDirector130717000002
    BUCKNALL, Christopher David
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    পরিচালক
    51 Brackendale Road
    GU15 2JS Camberley
    Surrey
    BritishDirector32104690001
    BULPITT, Nigel Peter
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    পরিচালক
    The Old School
    Upper Froyle
    GU34 4LB Alton
    Hampshire
    EnglandBritishChartered Accountant451080002
    BURCHELL, Philip Raymond
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    পরিচালক
    123 Tolmers Road
    EN6 4JW Cuffley Potters Bar
    Hertfordshire
    BritishDirector36622820001
    BURROWS, Helen
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    পরিচালক
    Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Unit 2
    Hampshire
    England
    EnglandBritishHr Director171865220001
    COWING, Helen
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    পরিচালক
    c/o Selecta Management Ag
    Hinterbergstrasse
    6330 Cham
    20
    Switzerland
    NetherlandsBritishChief Financial Officer156849560001
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritishDirector31500810002
    CULLENS, Alan
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    পরিচালক
    Candleford
    Colville Gardens
    GU18 5QQ Lightwater
    Surrey
    BritishDirector6875310001
    HUGHES, Geraint
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    পরিচালক
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    SwitzerlandBritishGroup Financial Controller169470320001
    JONES, Dylan Glynn
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    পরিচালক
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritishCompany Director153523810001
    KEEN, David John
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    33 Richmond Drive
    Mapperley
    NG3 5EL Nottingham
    Nottinghamshire
    BritishDirector56997350002
    LANCASTER, James
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    পরিচালক
    Upper Childown
    Accomodation Road
    KT16 0EJ Longcross
    Surrey
    EnglandBritishExecutive Director147052660001
    LEON, Anthony Michael
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    পরিচালক
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    EnglandBritishDirector242255050001
    MASON, Timothy Charles
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    231 Station Road
    Knowle
    B93 0PU Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Secretary12314170002
    MAUGUY, Philippe Francis Robert
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    পরিচালক
    Lime Tree Way, Hampshire Int Business Park
    Chineham
    RG24 8GG Basingstoke
    1st Floor Spinnaker House
    Hampshire
    England
    EnglandBritish, FrenchCompany Director179402830001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    পরিচালক
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    BritishDirector130747750001
    MEE, Andy Edward
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    পরিচালক
    Loughglynn
    Bunstrux
    HP23 4HT Tring
    Herts
    EnglandBritishManaging Director177086470001
    MITCHELL, Philip
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    3 White House Drive
    Merrow
    GU1 2SU Guildford
    Surrey
    BritishDirector6907290001
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    BritishFinance Director47770480002
    MORTIMER, David Grant
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    86 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    BritishFinance Director47770480002
    PAYNE, Michael John
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    পরিচালক
    Unit 2 Cartel Business Centre
    Wade Road
    RG24 8FW Basingstoke
    Hampshire
    EnglandBritishFinance & Supply Chain Director124498400001
    PORTER, Andrew Graham
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    পরিচালক
    16 Alderwood Avenue
    Chandlers Ford
    SO53 4TH Eastleigh
    Hampshire
    EnglandBritishCompany Director64331540001
    SCHWAB, Martin
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    পরিচালক
    Eebrunnestrasse 26
    Hausen Bei Brugg
    5212
    Switzerland
    SwitzerlandSwissCfo Selecta Group123132130001
    SCHWARTZ, Marta
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    পরিচালক
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House, Odyssey Business Park
    England
    United KingdomPolishFinance Director262359470001

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    ১৯ ডিসে, ২০১৭
    Odyssey Business Park
    West End Road
    HA4 6QD Ruislip
    Apollo House
    Middlesex
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Limited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland & Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষUnited Kingdom
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর00209116
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    Kkr & Co.L.P
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    West 57th Street
    Suite 4200
    NY10019 New York
    9
    New York
    United States
    হ্যাঁ
    আইনি ফর্মLimited Partnership
    নিবন্ধিত দেশDelaware
    আইনি কর্তৃপক্ষDelaware
    নিবন্ধিত স্থানRegistered In Delaware
    নিবন্ধন নম্বরState File No. 4378294
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    SELECTA REFRESHMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মার্চ, ২০১৭
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Factofrance
    ব্যবসায়
    • ০১ মার্চ, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ জুন, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Leasehold property k/a unit J6 forge lane minworth industrial estate sutton coldfield west midlands title no WM947521. Certain intellectual property listed in schedule 1 of the instrument for more details please see the image.
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    ব্যবসায়
    • ২৬ জুন, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০৭ ফেব, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জানু, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জানু, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The sum of £72,000 the interest accrued and any sums deposited in respect of value added tax see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wgtc Nominees Limited
    • British Overseas Bank Nominees Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ জানু, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Fixed and floating secuirty document
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ অক্টো, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns all its present and future right,title and interest in and to the assigned contract,all insurance and all proceeds in respect of insurance and all benef. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank Pls as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ১০ অক্টো, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১০ জানু, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge over deposit
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and or all or any of the other companies named therein to the chargee under or pursuant to the financing documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1), the consideration payable to mayfair vending limited pursuant to the offer letter and the advertising panel agreement and 2). the consideration payable to the company and the other chargors pursuant to the property sale agreement deposited by the company and the other chargors with the agent together with all interest accrued and accruing thereon and all other rights of the company and the other chargors in relation to such deposit in whichever account such deposit may, from time to time, be held.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ ডিসে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ নভে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge over deposit account
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the credit agreement (as defined) in relation to or arising out of any target 3 vendor loan stock guarantee (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The monies from time to time standing to the credit of the charged account (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC; As Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24TH july 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland P.L.C.; As Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ২৭ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the guarantee and debenture dated 24 july 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assigns all rights title and interest in and to the target 4 acquisition agreement (as defined) and proceeds of any claim or action under the target 4 acquisition agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৩ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) which obligations are more particularly contained in the debenture dated 24TH july 1995
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a unit 7 stockton close, minworth industrial park, sutton coldfield, west midlands t/no: WM350132. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ ডিসে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Share pledge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any and all rights deriving from the 20,993 shares of a nominal value of 100 francs I.E. 99.96% of the company's capital and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Share pledge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ আগ, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the borrowers (as defined) to the chargee and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any and all rights deriving from 2,493 shares of nominal value of a 100 francs I.E. 99.72% of the company's capital or any and all rights that may arise. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC(As Agent and Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ০২ আগ, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ জুল, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জুল, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to any of the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a unit A4 nugent industrial estate cray avenue st mary cray orpington kent l/h property k/a units E7,E8 and E9 central park trading estate trafford park manchester (and various other properties please see form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ এপ্রি, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0