TWINLOCK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTWINLOCK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00162422
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TWINLOCK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    TWINLOCK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TWINLOCK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৮

    TWINLOCK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    ২৭ মে, ২০২০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    5 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    2 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ০৯ মে, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৯ মে, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    মাইক্রো এন্ট্রিটি হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৯ মে, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ৩০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Christopher Neil Hopkinson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Robert Michael Grimes-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    ৩০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Richard Mark Geddie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ এপ্রি, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Richard Mark Geddie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৯ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    ০৭ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Dr Walter Joe Thomas-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০২ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ মে, ২০১৬

    ১০ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,679,791.6
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ০৭ জুল, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew Stephen Page এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৭ জুল, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr. Christopher Neil Hopkinson-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01
    capital

    প্রাক-স্বীকৃতি অধিকার বাতিলের রেজুলেশন

    RES11

    TWINLOCK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GRIMES, Robert Michael
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    245929880001
    THOMAS, Walter Joe, Dr
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishSolicitor217919870001
    BUCKINGHAM, Norman James
    19 Rugosa Road
    West End
    GU24 9PA Woking
    Surrey
    সচিব
    19 Rugosa Road
    West End
    GU24 9PA Woking
    Surrey
    British10762580002
    GEDDIE, Richard Mark
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    British80783870001
    O REILLY, Patrick John
    15 Delisle Road
    Gallions Reach
    SE28 0JD Thamesmead
    London
    সচিব
    15 Delisle Road
    Gallions Reach
    SE28 0JD Thamesmead
    London
    British66078790002
    PAGE, Andrew Stephen
    47 Town Acres
    TN10 4NG Tonbridge
    Kent
    সচিব
    47 Town Acres
    TN10 4NG Tonbridge
    Kent
    British47978190001
    WILSON, Kenneth Young
    71 Fyne Drive
    LU7 2YG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    সচিব
    71 Fyne Drive
    LU7 2YG Leighton Buzzard
    Bedfordshire
    British110645860001
    BUCKINGHAM, Norman James
    19 Rugosa Road
    West End
    GU24 9PA Woking
    Surrey
    পরিচালক
    19 Rugosa Road
    West End
    GU24 9PA Woking
    Surrey
    BritishDirector/Co Secretary10762580002
    CHAPMAN, Paul Guy
    51 Tempest Mead
    North Weald
    CM16 6DY Epping
    Essex
    পরিচালক
    51 Tempest Mead
    North Weald
    CM16 6DY Epping
    Essex
    EnglandBritishAccountant159719730001
    COX, Michael Neill
    44 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    পরিচালক
    44 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritishDirector10600400003
    COX, Michael Neill
    21 Ackmar Road
    Fulham
    SW6 4UP London
    পরিচালক
    21 Ackmar Road
    Fulham
    SW6 4UP London
    BritishDirector10600400002
    DAVIES, Emma Susan
    OX17 1ET Claydon
    Lawn Hill Cottage
    Oxfordshire
    পরিচালক
    OX17 1ET Claydon
    Lawn Hill Cottage
    Oxfordshire
    United KingdomBritishVp Finance Europe126575640001
    FENWICK, Neal Vernon
    29 Meare Close
    KT20 5RZ Tadworth
    Surrey
    পরিচালক
    29 Meare Close
    KT20 5RZ Tadworth
    Surrey
    BritishCompany Director39156650001
    FORREST, Robert James
    5 Hambye Close
    HP27 0QZ Lacey Green
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    5 Hambye Close
    HP27 0QZ Lacey Green
    Buckinghamshire
    BritishDirector14058760002
    GEDDIE, Richard Mark
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    15 Pine Grove
    Bricket Wood
    AL2 3ST St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritishAccountant80783870001
    GUEST, Richard Hamilton
    7 Townshend Road
    TW9 1XH Richmond
    পরিচালক
    7 Townshend Road
    TW9 1XH Richmond
    EnglandBritishVp European Finance122869580001
    HOPKINSON, Christopher Neil, Mr.
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Oxford House
    Oxford Road
    HP21 8SZ Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector270498480001
    MOODIE, Gordon Murray
    1 Forest Lodge
    Epsom Road
    KT21 1JX Ashtead
    Surrey
    পরিচালক
    1 Forest Lodge
    Epsom Road
    KT21 1JX Ashtead
    Surrey
    BritishCompany Director66078560001
    MUNK, Peter
    58 Geffers Ride
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    58 Geffers Ride
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    United KingdomDanishDirector112581070001
    PAGE, Andrew Stephen
    Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    29
    Bedfordshire
    England
    পরিচালক
    Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    29
    Bedfordshire
    England
    EnglandBritishDirector86557080001
    PAGE, Andrew Stephen
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector86557080001
    PAGE, Andrew Stephen
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    29 Russell Avenue
    MK40 3TD Bedford
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector86557080001
    PAGE, Andrew Stephen
    47 Town Acres
    TN10 4NG Tonbridge
    Kent
    পরিচালক
    47 Town Acres
    TN10 4NG Tonbridge
    Kent
    BritishDirector47978190001
    PETTICAN, Charles William
    136 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    136 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector52934940001
    SLATER, Stephen John
    Netherwood
    32 Green End
    MK18 3NT Granborough
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Netherwood
    32 Green End
    MK18 3NT Granborough
    Buckinghamshire
    BritishDirector30137660002
    TRUSSLER, Gary John
    5 Pilgrims Lakes Church Road
    Harrietsham
    ME17 1BY Maidstone
    Kent
    পরিচালক
    5 Pilgrims Lakes Church Road
    Harrietsham
    ME17 1BY Maidstone
    Kent
    United KingdomBritishDirector13973300002

    TWINLOCK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিদের বিষয়ে সর্বশেষ বিবৃতিগুলি কী কী?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি বিবৃতি
    জানানো হয়েছেবন্ধ হয়েছেবিবৃতি
    ০৯ মে, ২০১৭কোম্পানি জানে বা বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে কোম্পানির সাথে সম্পর্কিত কোন নিবন্ধনযোগ্য ব্যক্তি বা নিবন্ধনযোগ্য প্রাসঙ্গিক আইনি সত্তা নেই

    TWINLOCK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee on a loan account and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H office block and port factory on the south side of st. Margarets road, beckenham kent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £1,500,000 dur or to become due from the company to the chargee on a loan account and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H propety known as 1-3, 6-15, 18-29 st. Margarets road, beckenham, kent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee on a loan account and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H factory and anciliary premises at 4, 5, 16 & 17 and 31 st. Margarets road, beckenham, kent title nos. Sgl 7178, k 224460, sgl 3695 sgl 27640.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £1,500,000 due or to become due from the company to the chargee on a loan account and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property known as pedigree works, bearwood road, smethwick, and 82 and 84 beanwood road, smethwick, west midlands.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £1,500,000 due or to become dur froim the company to the chargee on a loan account and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H factory and office premises at new road, sheerness, isle of b sheppey kent title no. K 94472 and k 141365.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ মে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For securing £1,500,000 dur from the company to the chargee on a loan account and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H factory on the south side of st. Margarets road, beckenham kent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property known as 82 and 84 bearwood road smethwick county of west midlands & f/h property known as pedigree works bearwood road, aforesaid. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • County Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0