CROWN PACKAGING UK LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCROWN PACKAGING UK LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00178090
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হালকা ধাতু প্যাকেজিং উত্পাদন (25920) / উৎপাদন

    CROWN PACKAGING UK LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Crown Packaging Uk Limited Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Cumbria
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CROWN PACKAGING UK PLC১৬ ডিসে, ২০০৩১৬ ডিসে, ২০০৩
    CARNAUDMETALBOX PLC০১ নভে, ১৯৯২০১ নভে, ১৯৯২
    CMB FOODCAN PLC০১ মে, ১৯৯০০১ মে, ১৯৯০
    CMB PACKAGING (UK) LIMITED২৫ এপ্রি, ১৯৮৯২৫ এপ্রি, ১৯৮৯
    MB GROUP PLC৩০ সেপ, ১৯৮৮৩০ সেপ, ১৯৮৮
    METAL BOX PUBLIC LIMITED COMPANY২৯ নভে, ১৯২১২৯ নভে, ১৯২১

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১৭
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০১৮
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৬

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ মে, ২০১৮
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৫ মে, ২০১৮
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ মে, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ০১ এপ্রি, ২০২৫ তারিখে সচিব হিসাবে Jennifer Patricia Simpson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ১৮ জুল, ২০২৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ জুল, ২০২৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ জুল, ২০২২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ৩১ আগ, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jean-Francois Lelouch-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ আগ, ২০২১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Laurent Watteaux এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৮ জুল, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ জুল, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    7 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ জুল, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    8 পৃষ্ঠাLIQ03

    ৩০ আগ, ২০১৯ তারিখে Mr Laurent Watteaux-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৮ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    11 পৃষ্ঠাLIQ03

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    7 পৃষ্ঠাLIQ01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৯ জুল, ২০১৭ তারিখে

    LRESSP

    ০১ মে, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01

    চার্জ 12 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 11 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 001780900014 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Didier Michel Sourisseau এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mehmet Ziya Ozay এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে John Clinton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৬ মার্চ, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul William Browett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    35 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠাSH20

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    LELOUCH, Jean-Francois
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Borland Avenue
    Cumbria
    United Kingdom
    পরিচালক
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Borland Avenue
    Cumbria
    United Kingdom
    FranceFrenchChief Legal Officer248293870001
    DEWSBURY, Malcolm Geoffrey
    11 Glebe Close
    Bidford On Avon
    B50 4BL Alcester
    Warwickshire
    সচিব
    11 Glebe Close
    Bidford On Avon
    B50 4BL Alcester
    Warwickshire
    British2436310001
    SIMPSON, Jennifer Patricia
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Limited
    Cumbria
    England
    সচিব
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Limited
    Cumbria
    England
    British77042940001
    ALAIN, De Mas Latrie
    30 Rue Gardenat Capostol
    92 150 Suresnes
    France
    পরিচালক
    30 Rue Gardenat Capostol
    92 150 Suresnes
    France
    FrenchDirector47292020001
    ANTHON, Nicolas Hugo
    41 Rue Antoine Labarre
    B1050 Brussels
    Belgium
    পরিচালক
    41 Rue Antoine Labarre
    B1050 Brussels
    Belgium
    BelgiumDanishVp Director107751820002
    BROWETT, Paul William
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Limited
    Cumbria
    England
    পরিচালক
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Limited
    Cumbria
    England
    EnglandBritishVp/Treasurer157242310001
    CALDER, Jonathan Peter
    Chemin Groison
    77123 Noisy Sur Ecole
    4
    France
    পরিচালক
    Chemin Groison
    77123 Noisy Sur Ecole
    4
    France
    FranceBritishSvp Hr & Comms45119850003
    CARTWRIGHT, Terence
    Quai Branly
    Paris 75007
    71
    France
    পরিচালক
    Quai Branly
    Paris 75007
    71
    France
    FranceBritishS Vice President108120770004
    CLINTON, John
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Limited
    Cumbria
    England
    পরিচালক
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Limited
    Cumbria
    England
    SwitzerlandBritishSenior Vice President94519350002
    COLLIER, Peter Charles
    12 Rue Des Cheverrures
    Le Mesnil Le Roi
    78600
    France
    পরিচালক
    12 Rue Des Cheverrures
    Le Mesnil Le Roi
    78600
    France
    FranceBritishBusiness Development58873360002
    CURTIS, Brian William
    16 The Briars
    Westwood Close
    WR9 0BD Droitwich
    পরিচালক
    16 The Briars
    Westwood Close
    WR9 0BD Droitwich
    BritishVice President36502150001
    DACHS, Roland Charles Joachim
    112 B D Pereire
    Paris
    75017
    France
    পরিচালক
    112 B D Pereire
    Paris
    75017
    France
    FrenchVp Logistics75390480001
    DAVIDSON, John
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Plc
    Cumbria
    England
    পরিচালক
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Plc
    Cumbria
    England
    EnglandBritishCompany Director50615350001
    DE WENDEL, Francois
    21 Rue Galan
    Paris
    75014
    France
    পরিচালক
    21 Rue Galan
    Paris
    75014
    France
    FrenchSenior Vice President60450140001
    DRIEBEEK, Patrick
    6 Rve Andre Colledeboeuf
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    পরিচালক
    6 Rve Andre Colledeboeuf
    FOREIGN 75016 Paris
    France
    DutchVp General Counsel53310170002
    ETIENNE, Jean-Michel Michel
    35 Avenue Alfred Belmontet
    92210 Saint Cloud
    92210
    France
    পরিচালক
    35 Avenue Alfred Belmontet
    92210 Saint Cloud
    92210
    France
    FranceFrenchVice President171031220001
    FAYET, Arnaud Philippe
    36 Rue Michel Ange
    75016 Paris
    France
    পরিচালক
    36 Rue Michel Ange
    75016 Paris
    France
    FranceCompany Director39654570001
    FLORIS, Jean Pierre Eugene
    3 Route Du Grand Lac
    78110 Le Vesinet
    France
    পরিচালক
    3 Route Du Grand Lac
    78110 Le Vesinet
    France
    FrenchChairman51333030001
    FORD, David Ronald
    57 Sandy Lane
    GL53 9DG Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    57 Sandy Lane
    GL53 9DG Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishEngineer104100050001
    GILSON, Bruce Nigel
    Cold Norton Wood Lane
    Kidmore End
    RG4 9BE Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Cold Norton Wood Lane
    Kidmore End
    RG4 9BE Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant20779760002
    GILSON, Bruce Nigel
    Cold Norton Wood Lane
    Kidmore End
    RG4 9BE Reading
    Berkshire
    পরিচালক
    Cold Norton Wood Lane
    Kidmore End
    RG4 9BE Reading
    Berkshire
    BritishChartered Accountant20779760002
    GOODERICK, Robert Levison
    67 Southmoor Road
    OX2 6RE Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    67 Southmoor Road
    OX2 6RE Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant42206120001
    HIBBERT, Andrew
    5 Place Violet
    FOREIGN Paris
    75015
    France
    পরিচালক
    5 Place Violet
    FOREIGN Paris
    75015
    France
    BritishGeneral Secretary & General Co71470860001
    HOLDERITH, Paul
    22 Av Max De Nansouty
    Asnieres Seine
    92 600 France
    পরিচালক
    22 Av Max De Nansouty
    Asnieres Seine
    92 600 France
    FrenchManaging Director67456240001
    HOMFRAY, Christopher Charles
    22 Peachfield Road
    WR14 4AP Malvern
    Wood End
    Worcestershire
    পরিচালক
    22 Peachfield Road
    WR14 4AP Malvern
    Wood End
    Worcestershire
    EnglandBritishPresident110592530003
    JAMART, Jacques Edmond Victor
    2 Reculet
    Longvilliers 78730
    FOREIGN France
    পরিচালক
    2 Reculet
    Longvilliers 78730
    FOREIGN France
    FranceBelgianVice President Food/Ffa175396810001
    KARLSSON, Tommy Harry Vilhelm, Chief Operating Officer
    15 Rue Le Bouteux
    Paris
    FOREIGN France
    75017
    পরিচালক
    15 Rue Le Bouteux
    Paris
    FOREIGN France
    75017
    SwedishCoo Carnaudmetalbox43832780001
    LABBE, Francis Bernard Nicolas
    4 Bis Rue De Montesquiou
    92210
    St Cloud
    France
    পরিচালক
    4 Bis Rue De Montesquiou
    92210
    St Cloud
    France
    FranceFrenchManaging Director72426150007
    LAPILLONNE, Rodolphe Jean Hubert
    18 Thame Lane
    Culham
    OX14 3DS Abingdon
    Oxfordshire
    পরিচালক
    18 Thame Lane
    Culham
    OX14 3DS Abingdon
    Oxfordshire
    FrenchCompany Director69195030001
    LESER, Jacques
    49 Avenue De La Republique
    75011 Paris
    FOREIGN 75011 France
    পরিচালক
    49 Avenue De La Republique
    75011 Paris
    FOREIGN 75011 France
    FranceVice President Technology40237310001
    LEVI, Pierre
    14 Rue Charles Bernard Metman
    Neuilly Sur Seine
    FOREIGN 92200
    France
    পরিচালক
    14 Rue Charles Bernard Metman
    Neuilly Sur Seine
    FOREIGN 92200
    France
    FrenchManaging Director58629940001
    LIGET, Jacques
    1 Rue Du Bois De Boulogne
    92200 Neuilly Sur Seine
    France
    পরিচালক
    1 Rue Du Bois De Boulogne
    92200 Neuilly Sur Seine
    France
    FrenchGroup Vice President56947530002
    LOCKLEY, Peter William
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Plc
    Cumbria
    England
    পরিচালক
    Borland Avenue
    Botcherby
    CA1 2TL Carlisle
    Crown Packaging Uk Plc
    Cumbria
    England
    SwitzerlandBritishSenior Vice President165132650004
    LOMAX, Howard Charles
    Rue Angelique Verien
    Neuilly Sur Seine
    Paris
    3
    92200
    France
    পরিচালক
    Rue Angelique Verien
    Neuilly Sur Seine
    Paris
    3
    92200
    France
    FranceBritishFinance Director137338300001
    MARCO, Giovaivnini, Doctor
    77 B15 Avenue Bretevil
    FOREIGN 75015 Paris
    France
    পরিচালক
    77 B15 Avenue Bretevil
    FOREIGN 75015 Paris
    France
    ItalianGroup Managing Director39654710001

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Carnaudmetalbox Group Uk Limited
    Downsview Road
    OX12 9BP Wantage
    Carnaudmetalbox Group Uk Limited
    Oxon
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Downsview Road
    OX12 9BP Wantage
    Carnaudmetalbox Group Uk Limited
    Oxon
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষLaw Of England And Wales
    নিবন্ধিত স্থানCardiff Companies Registry
    নিবন্ধন নম্বর02319796
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০১৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Notification of addition to or amendment of charge.
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag New York Branch
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ মার্চ, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুন, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুন, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The real property,all plant machinery vehicle computers office and other equipment and chattels and all related rights,all account proceeds see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag, New York Branch
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুন, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০৮ জানু, ২০১৪সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    • ১৩ এপ্রি, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge by way of legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ফেব, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land at canal side mile end road neath; cym 44793; any rights buildings fixtures other structures fixed plant and machinery thereon; the proceeds of sale thereof or other disposal or grant of any interest receivable or payable and benefit of any covenants for title; all rents and other income arising; the goodwill of business and benefit of all contracts; floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Welsh Ministers
    ব্যবসায়
    • ২৬ ফেব, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ০১ এপ্রি, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Bank Ag, New York Branch
    ব্যবসায়
    • ০৬ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ ডিসে, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৮ জানু, ২০১৪সমস্ত সম্পত্তি বা উদ্যোগ চার্জ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে (MR05)
    • ৩০ মার্চ, ২০১৭একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The securities and all its rights, title, benefit and interest whatsoever, present and provided therein;.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ১৮ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৫ অক্টো, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৩ ডিসে, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ৩০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27 september 2004 and
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from or on behalf of euro borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Keirfield works with the field adjoining on the east in or near bridge of allan and the building at present used as a canteen and the subjects k/a keirfield house and farm with the gardens and two fields adjoining all situated near bridge of allan, for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited as Trustee for Itself and Each of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ০৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ সেপ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The real property all debts the shares all of its intellectual property rights all goodwill and uncalled capital by way of first floating cjarge all of the rights to and title and interest from time to time in the whole of the property assets rights and revenues whatsoever and wheresoever present and future. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৭ সেপ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৫ অক্টো, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৩ ডিসে, ২০০৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ৩০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture made between carnaudmetalbox PLC (existing chargor), massmould (holdings) limited (the new chargor) and citicorp trustee company limited (security trustee)
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The new f/h properties k/a massmould 3 & 4 maulden road, flintwick, t/n BD146481, and massmould 1, cosgrove way, luton, LU11XL t/n BD62810.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited (Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২০ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৩ জুল, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৫ অক্টো, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 17 march 2003
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Keirfield works with field adjoining stirling * please refer to form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited as Trustee for Itself and Each of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from euro borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Citicorp Trustee Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মে, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ০৯ সেপ, ২০০৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ ফেব, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৩ জুল, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৫ অক্টো, ২০০৫বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১০ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 6TH august 2001
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h land situate at milland road,neath,port talbot t/n WA134574 WA970126 and WA956870, with all additions thereto and all fixtures and fittings in the nature of fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Welsh Development Agency
    ব্যবসায়
    • ০১ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ৩০ মার্চ, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any other beneficiary under or pursuant to any loan document (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (The Security Trustee as Trustee Forthe Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Itl 10,000,000,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit of £5,000,000 related to the facility granted to superbox spa (see form m 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credito Italiano
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন

    CROWN PACKAGING UK LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৯ জুল, ২০১৭ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৩ জুল, ২০১৭দ্রাব্যতার ঘোষণা শপথ করে
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Robert Nicholas Lewis
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0