WILSON CONNOLLY LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWILSON CONNOLLY LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00244804
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    WILSON CONNOLLY LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Gate House
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Buckinghamshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    WILCON HOMES LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৭৩১ ডিসে, ১৯৭৭
    WILCON CONSTRUCTION LIMITED০২ জানু, ১৯৩০০২ জানু, ১৯৩০

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণনা
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ ডিসে, ২০২৪
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ সেপ, ২০২৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০২৩

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৩ এপ্রি, ২০২৫
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৭ এপ্রি, ২০২৫
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৩ এপ্রি, ২০২৪
    মেয়াদোত্তীর্ণনা

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ০৯ ডিসে, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Michael Andrew Lonnon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৯ ডিসে, ২০২৪ তারিখে সচিব হিসাবে Mr Sayed Suleiman Ashrafi-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP03

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২৩ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    ২৪ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Omolola Olutomilayo Adedoyin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৪ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jennifer Canty-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ এপ্রি, ২০২৪ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০৯ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Omolola Olutomilayo Adedoyin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৯ অক্টো, ২০২৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Katherine Elizabeth Hindmarsh এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২২ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ এপ্রি, ২০২৩ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২১ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    সম্পত্তি বা উদ্যোগের একটি অংশ মুক্ত করা হয়েছে এবং আর চার্জ 55 এর অংশ নয়

    2 পৃষ্ঠাMR05

    ০৩ এপ্রি, ২০২২ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০২০ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থান Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা Elder House St Georges Business Park 207 Brooklands Road Weybridge Surrey KT13 0TS United Kingdom থেকে Highdown House Yeoman Way Worthing West Sussex BN99 3HH এ পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ০৩ এপ্রি, ২০২১ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৯ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    ০৩ এপ্রি, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ৩১ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Colin Richard Clapham এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩১ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Miss Katherine Elizabeth Hindmarsh-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Ian Graham Connor-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৫ অক্টো, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Sarah Judith Thornley এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ২০ এপ্রি, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ASHRAFI, Sayed Suleiman
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    330347940001
    CANTY, Jennifer
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Secretary322288120001
    CONNOR, Ian Graham
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193626080001
    HASTINGS, Jonathan Philip
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    সচিব
    7 Hanger Court
    Hanger Green
    W5 3ER London
    British4733610001
    LAWTHER, Samuel David
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    সচিব
    Stow Cottage
    Spaldwick Road, Stow Longa
    PE18 0TL Huntingdon
    Cambridgeshire
    British41835460012
    LONNON, Michael Andrew, Mr.
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British34521340004
    NUNN, Carol Jayne
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    সচিব
    4 Juniper Close
    NN12 6XP Towcester
    Northamptonshire
    British116824870001
    STOTE, Tanya
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    সচিব
    Honeyburge
    The Fordrough
    B90 1PP Solihull
    West Midlands
    British113603590001
    ADEDOYIN, Omolola Olutomilayo
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3 NR High Wycombe
    Gate House
    Bucks
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director193735640001
    ANDREW, Peter Robert
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishRegional Managing Director113503830003
    BANNISTER, William Henry
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    পরিচালক
    28 Riverside Road
    West Moors
    BH22 0LQ Ferndown
    Dorset
    United KingdomBritishDirector58990140003
    BEAL, Ian Paul
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    পরিচালক
    Meadowbank
    10 Stagswood
    BH31 6PX Verwood
    Dorset
    BritishDirector71260780003
    BELL, Darren
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    পরিচালক
    5 Brookway
    Wrea Green
    PR4 2NU Preston
    United KingdomBritishManaging Director73256080001
    BENSON, Deborah Clare
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    পরিচালক
    30 Wardie Square
    EH5 1EU Edinburgh
    Lothian
    BritishManaging Director52845300004
    BLACK, Ian Craig
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    7 The Courtyard
    Ecton Hall
    NN6 0QE Ecton
    Northamptonshire
    BritishChartered Accountant4579780003
    BROOMFIELD, Matthew
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    3 Link Drive
    Brampton
    PE28 4FE Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishDirector80131820001
    BURGESS, Alan Robert
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    1 Pinetops
    Forest Road
    RH12 4HU Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishCompany Director79587600001
    CARNEY, Christopher
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director125216670001
    CHANDRAN, Vikranth
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    পরিচালক
    Carlton Avenue East
    Wembley
    HA9 8QB London
    227
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant139652640001
    CLAPHAM, Colin Richard
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary9684390001
    COKER, John Edwin
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Brambly Hedge 3 Somersall Willows
    S40 3SR Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishCompany Director100513680001
    DICKERSON, Graham Leslie
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    পরিচালক
    St Aubuns
    Cricketfield Lane
    CM23 2SR Bishops Stortford
    Herts
    EnglandBritishManaging Director127266390001
    EDGINGTON, Richard Alan
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    পরিচালক
    Ashleigh
    Main Road Great Haywood
    ST18 0SU Stafford
    EnglandBritishManaging Director81884240001
    FAULKNER, Jeffrey Dean
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    পরিচালক
    1 The Cherries
    Euxton
    PR7 6NG Chorley
    Lancashire
    BritishDirector77563410003
    FLOOD, Robert William
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    পরিচালক
    Cloisters Road
    Winterbourne
    BS33 1QP Bristol
    Brinksworth Leaze
    EnglandBritishManaging Director134877050001
    FOULKES, Christopher Andrew
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    পরিচালক
    76 Muirhill
    Limpley Stoke
    BA2 7FB Bath
    Avon
    United KingdomBritishNone33941280001
    FRAQUELLI, Lorenzo Giuseppe
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    17 Derwent Road
    AL5 3PA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishManaging Director48396030001
    GREEN, Robert David
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    পরিচালক
    11 Whitworth Lane
    Loughton
    MK5 8EB Milton Keynes
    EnglandBritishDirector76720550003
    GREENING, Malcolm David
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    181 Burley Lane
    Quarndon
    DE22 5JS Derby
    Derbyshire
    BritishCompany Director58648450001
    GRIFFITHS, Melvyn Robert
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Bethal House Pytchley Court
    Crown Lane
    NN6 7AL West Haddon
    Northamptonshire
    United KingdomBritishDirector113395580001
    HATCH, Christopher John
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    19 Welwyn Hall Gardens
    AL6 9LF Welwyn
    Hertfordshire
    BritishCompany Director50577850006
    HINDMARSH, Katherine Elizabeth
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Secretary257671040002
    HOLLAND-KAYE, William John
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    পরিচালক
    39 Britannia Road
    SW6 2HJ London
    BritishManaging Director110518040001
    JOHNSON, Peter Thomas
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    34 Homewood Road
    AL1 4BQ St Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritishAccountant8895880004
    KENRICK, Joanne Louise
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    পরিচালক
    Flat 9
    53 Rosslyn Hill Hampstead
    NW3 5UH London
    BritishDirector75636150002

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Turnpike Road
    HP12 3NR High Wycombe
    Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    না
    আইনি ফর্মLimited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland And Wales
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানCompanies House
    নিবন্ধন নম্বর832629
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    WILSON CONNOLLY LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জুল, ২০০৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ জুল, ২০০৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each guarantor or borrower or chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. Eldohouse farm being on the south side of mount road, bury st edmunds part t/no SK82666. 34 turnpike road, red lodge, freckenahm part t/no SK80912. Insurances and other contracts see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wilmington Trust (London) Limited (the Security Agent) as Agent and Trustee for the Secured Creditors
    ব্যবসায়
    • ১৬ জুল, ২০০৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ জুল, ২০১০বিবৃতি যে সম্পত্তির একটি অংশ বা সমস্ত চার্জ মুক্তি পেয়েছে (MG04)
    • ০১ জুল, ২০১০বিবৃতি যে সম্পত্তির একটি অংশ বা সমস্ত চার্জ মুক্তি পেয়েছে (MG04)
    • ০৪ ফেব, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £3,308,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land situated at upton rocks widnes chesire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Council of the Borough of Halton
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ অক্টো, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £2,450,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land and premises known as part of nunnery fields hospital nunnery fields canterbury kent.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • East Kent Hospitals National Health Service Trust
    ব্যবসায়
    • ৩০ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The whole of the l/h land being 146 orrell road, orrell t/no GM607707.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Steven John Burness and Rita Ann Burness
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at wychwood village, crewe, cheshire,.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Countryside Properties PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ অক্টো, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ আগ, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property situate and k/a coryton house 27 pendwyallt road coryton cardiff.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Royal Mail Group PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ আগ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ জুল, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জুল, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £5,908,750.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that f/h property situate at manor farm crescent off brook way bradley stoke south glos containing approx 7.6 acres.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • South Gloucestershire District Council
    ব্যবসায়
    • ০৯ জুল, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ জুন, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুন, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ জুন, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land known as and forming part of woodlands memorial ground blackpool road ansdell lytham st annes.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Fylde Rugby Union Football Club Limited
    ব্যবসায়
    • ২৪ জুন, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ জুল, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £3,429,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the east side of southend road hornchurch essex.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Maylands Green Estate Co Limited & Romford Construction Company Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land comprising old stowupland park stowmarket suffolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £1,897,500 due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land comprising old stowupland park, stowmarket, suffolk.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Crest Nicholson Residential (Eastern) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Scholes park farm and scholes lodge farm scholes leeds west yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Scholes Park Developments Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ জুল, ২০২২সম্পত্তির একটি অংশ বা উদ্যোগ মুক্তি দেওয়া হয়েছে এবং আর চার্জের অংশ নয় (MR05)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ মে, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    The sum of £2,400,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a the woodlands park hotel wellington road timperley cheshire t/no: GM171621.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Brian Norris Walker
    ব্যবসায়
    • ০১ মে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold property under t/n's CH423380 and CH423391 and the rights interest and estate in the land described in the statutory declarations of david stone and derek nuttall dated 25 march 2003. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Northwich Victoria Football Club Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ মে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ এপ্রি, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ এপ্রি, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the northwich victoria football club company limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold property known as or being the football stadium and land at the drill field northwich cheshire. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ আগ, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the land at medway trading estate hart street maidstone kent t/no K583305.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bernard Christopher Norman Roger Holmes
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    One million six hundred thousand pounds (£1,600,000) due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the south east side of hart street, maidstone, kent t/n K583305.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Cathedral Medway Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £21,660,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at orsett hospital rowley road basildon essex.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Basildon and Thurrock General Hospitals National Health Service Trust
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £750,000 due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land to the rear of tidings hill halstead essex.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • G E Cook & Sons Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ অক্টো, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ অক্টো, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The property k/a land to the south of clay lane, fishbourne, nr chichester, west sussex t/no. WSX257370.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Seaward Homes (South) Limited
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at county way, trowbridge, wiltshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Swan Hill Developments Limited
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at lee mill,ivybridge,devon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Peter Joseph Cane and William John Cane
    ব্যবসায়
    • ২২ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মে, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land lying to the south of codicote road, wheathampstead, hertfordshire. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sainsbury's Supermarkets Limited
    ব্যবসায়
    • ০২ মে, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north east side of carver street, birmingham, forming part of the land t/n WM467585.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland and City Limited, Baystone Associates Limited, and Lampol Developments Limited Togethertrading as Ppk Partnership
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ডিসে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জানু, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that freehold land lying to the south of codicote road wheathampstead hertfordshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Sainsburys Supermarkets Limited
    ব্যবসায়
    • ০৪ জানু, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0