JTB REALISATIONS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJTB REALISATIONS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00288766
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JTB REALISATIONS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বিশেষায়িত স্টোরগুলিতে জুতার খুচরা বিক্রয় (47721) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    JTB REALISATIONS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JTB REALISATIONS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    A. JONES & SONS LIMITED০৪ জুন, ১৯৩৪০৪ জুন, ১৯৩৪

    JTB REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৪

    JTB REALISATIONS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    32 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    32 পৃষ্ঠাAM23

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    28 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    31 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    36 পৃষ্ঠাAM10

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ AM02SOA

    12 পৃষ্ঠাAM02

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed A. jones & sons LIMITED\certificate issued on 03/05/17
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১৩ এপ্রি, ২০১৭

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    44 পৃষ্ঠা2.17B

    ০৯ এপ্রি, ২০১৭ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YG England থেকে 15 Canada Square London E14 5GLপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা2.12B

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩১ ডিসে, ২০১৬ থেকে ২৮ ফেব, ২০১৭ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ২৭ জানু, ২০১৭ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Edward Cook এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ ডিসে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr David John Riddiford-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৬ অক্টো, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে David Robert Short এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 002887660014 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ নিবন্ধন 002887660018, ২২ সেপ, ২০১৬ তারিখে তৈরি করা হয়েছে

    70 পৃষ্ঠাMR01

    ০৮ আগ, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা A Jones & Sons Limited Interlink Way West, Interlink Business Park Bardon Coalville Leicestershire LE67 1LD England থেকে Outersole House 1 Wheatfield Way Hinckley Leicestershire LE10 1YGপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    JTB REALISATIONS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    KILLICK, Michael David
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    WalesBritish75927820002
    RIDDIFORD, David John
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    পরিচালক
    Canada Square
    E14 5GL London
    15
    EnglandBritish220918310001
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    সচিব
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    British10571470001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    সচিব
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    British109143970003
    WHITE, Andrew Robert
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    সচিব
    18 Maple Road
    Eastbourne
    BN23 6NZ East Sussex
    British159789980001
    BARTLE, Kenneth
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    পরিচালক
    Mill Hill
    Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    The Smock Mill, Hitchcocks Mill
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish73909180007
    BARTLE, Kenneth
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    পরিচালক
    The Smock Mill Hitchcocks Mill
    Mill Hill Rattlesden
    IP30 0SQ Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish73909180007
    BOOT, Terry Michael
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    Interlink Way West, Interlink Business Park
    Bardon
    LE67 1LD Coalville
    A Jones & Sons Limited
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish67041160001
    CHURCH, John George
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Farthingstone
    NN12 8EZ Towcester
    Northamptonshire
    United KingdomBritish12963560001
    CLARK, Lancelot Pease
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    পরিচালক
    Apartment 142
    Archie Street
    SE1 London
    British28161570002
    COOK, Simon Edward
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish104673410002
    COORENS, Eric Maria Hendrikus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutch157586370001
    CRAWSHAW, John
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    পরিচালক
    2 Hyde Tynings Close
    BN20 7TQ Eastbourne
    East Sussex
    United KingdomBritish121560001
    DE MOOR, Frank Karel
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    BelgiumBelgian159745220001
    DUNCAN SMITH, Alastair David
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    পরিচালক
    94 Wakehurst Road
    SW11 6BT London
    British69076490001
    HUNEN, Peter Therese Antoon
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutch159744910001
    JELINEK, Vaclav
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    পরিচালক
    2 Avenue Place, Avenue Lane
    BN21 3RB Eastbourne
    East Sussex
    British109139210002
    JOHNSON, David Edward
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    20 Great Footway
    Langton Green
    TN3 0DT Tunbridge Wells
    Kent
    British10571470001
    KENNEDY, Iain Manning
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    3 Townsend Close
    NN6 9HP Hanging Houghton
    Northamptonshire
    EnglandBritish187882990001
    NOBLE, Alison Jane Bennett
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    পরিচালক
    82 Gayville Road
    SW11 6JP London
    United KingdomBritish103289830002
    PHILLIPS, Peter John
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Gibraltar Lane
    Cookham Dean
    SL6 9TR Maidenhead
    Gibraltar House
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandBritish51075400001
    PHILLIPS, Peter John
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    St. Peter Street
    SL7 1NQ Marlow
    The Minnows
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British51075400002
    SHORT, David Robert
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    পরিচালক
    1 Wheatfield Way
    LE10 1YG Hinckley
    Outersole House
    Leicestershire
    England
    EnglandBritish38957690003
    SHORTEN, Paul William
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    পরিচালক
    Kinell Windmill Green
    Stone Cross
    BN24 5DY Pevensey
    East Sussex
    British33661480001
    STRIJBOS, Theodorus Leonardus
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Interlink Way West,
    Interlink Business Park
    LE67 1LD Bardon, Coalville
    Macintosh Fashion Uk
    Leicestershire
    United Kingdom
    NetherlandsDutch157586510001
    TODD, Jeremy
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    পরিচালক
    West Street
    TN20 6DS Mayfield
    Knowle Way
    East Sussex
    United Kingdom
    EnglandBritish109143970003
    WALTON JONES, Howard
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    পরিচালক
    Robin Hill Tilley Lane
    Boreham Street
    BN27 4UT Hailsham
    East Sussex
    British20804560001
    WATKINSON, John Dudley
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    পরিচালক
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    EnglandBritish66949520004
    WHITE, Andrew Robert
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Highgate Drive
    Knighton
    LE2 6HJ Leicester
    31
    Leicestershire
    United Kingdom
    EnglandBritish146324190001

    JTB REALISATIONS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ সেপ, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ২০১৬
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe, L.P.
    ব্যবসায়
    • ২৮ সেপ, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ২০১৬
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe, L.P. (The Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৭ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০১৫
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe L.P. (As Secuirty Agent)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০১৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ নভে, ২০১৫
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Alteri Europe, L.P. (As Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ০২ নভে, ২০১৫একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Bank N.V. (The "Security Agent") as Trustee for Each of the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ২৮ সেপ, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ing Bank N.V., Acting in Its Capacity of Security Agent (The "Secured Party" Which Expression Includes Its Successors and Assigns)
    ব্যবসায়
    • ২৫ নভে, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ৩০ অক্টো, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ সেপ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ সেপ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২০ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ জানু, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৭ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১২ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental mortgage to a debenture dated 22 february 2001,
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities, whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever, of each obligor to the lender
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first legal mortgage the property being all that l/h premises k/a 53 west street horsham west sussex, all that l/h premises k/a number 30-32 the promenade cheltenham gloucestershire, all that l/h premises k/a 40 high street reigate surrey RH2 9AT, all that l/h premises k/a 103-105 terminus road eastbourne east sussex, together with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures) at any time thereon.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture to a debenture dated 22 february 2001 made between (amongst others) the chargor and burdale financial limited
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all of its right title and interest in and to the additional collection account and all monies standing to the credit of the additional collection account and the debts represented by them. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to or in connection with the facility agreement (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    In order to provide continuing security for the payment or performance of the obligation in the agreement the obligor vested possession of the certificates of title to the collateral in the secured party (or its agent) to the intent that the secured party should have a security interest or interests in the collateral in accordance with article 2 (3) of the 1983 law but so that the secured party should not in any circumstances incur any liability or be under any obligation whatsoever in connection with the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of debenture made between, amongst others, the company and the chargee
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of each obligor to the chargee (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৪ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ফেব, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মার্চ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the loan note instrument and in accordance with the terms of an agreement of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge. Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Church & Co PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ মার্চ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard security
    তৈরি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000 due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First floor office premises at 56 hanover street edinburgh.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Scottish Amicable Life Assurance Society Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    JTB REALISATIONS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৪ মার্চ, ২০১৭প্রশাসন শুরু
    ০৫ এপ্রি, ২০১৯প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Blair Carnegie Nimmo
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    William James Wright
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    অভ্যাসকারী
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0