HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00308512
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    133 Houndsditch
    London
    EC3A 7AH
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HEATH INSURANCE SERVICES LIMITED৩০ অক্টো, ১৯৯৬৩০ অক্টো, ১৯৯৬
    C E HEATH (INSURANCE SERVICES) LIMITED২৮ নভে, ১৯৯০২৮ নভে, ১৯৯০
    B & C INSURANCE BROKERS (UK) LIMITED০২ আগ, ১৯৮৯০২ আগ, ১৯৮৯
    B & C INSURANCE BROKERS LIMITED ০১ জুল, ১৯৮৮০১ জুল, ১৯৮৮
    CAYZER STEEL BOWATER (LONDON) LIMITED১৩ আগ, ১৯৮৫১৩ আগ, ১৯৮৫
    TENNANT BUDD LIMITED২১ ডিসে, ১৯৩৫২১ ডিসে, ১৯৩৫

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    ১০ অক্টো, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে William David Bloomer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ ফেব, ২০১১

    ১৫ ফেব, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 8,300,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ মার্চ, ২০১০ থেকে ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    29 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    1 পৃষ্ঠাCC04

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAR01

    শেয়ারের সাথে সংযুক্ত অধিকারের পরিবর্তনের বিবরণ

    2 পৃষ্ঠাSH10

    পরিচালক হিসাবে Mr Adrian Colosso-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Michael Bruce এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    পৃষ্ঠা363(288)

    legacy

    পৃষ্ঠা363(353)

    হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HL CORPORATE SERVICES LIMITED
    133 Houndsditch
    EC3A 7AH London
    কর্পোরেট সচিব
    133 Houndsditch
    EC3A 7AH London
    43700080007
    COLOSSO, Adrian
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    পরিচালক
    Burnham Road
    Woodham Mortimer
    CM9 6SP Maldon
    Hillside Farm
    Essex
    EnglandBritishGroup Chief Executive4555310002
    THOMAS, Robert Nigel
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    পরিচালক
    South West House
    Weston Road
    BA1 2XU Bath
    Avon
    United KindgomBritishAccountant40630840002
    SHARP, Pandora
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    সচিব
    Flat 9 Da Vinci Court
    1 Rossetti Road
    SE16 3EA London
    British64972020003
    WILKINSON, Sidney James
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    সচিব
    67 Chessfield Park
    Little Chalfont
    HP6 6RU Amersham
    Buckinghamshire
    British1138390001
    BAREHAM, Robert Edward
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    পরিচালক
    Squirrels
    33 Bidborough Ridge
    TN4 0UT Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant8522090001
    BARTLETT, Steven James
    10 Ash Meadow
    Willesborough
    TN24 0LW Ashford
    Kent
    পরিচালক
    10 Ash Meadow
    Willesborough
    TN24 0LW Ashford
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker47527700001
    BLOOMER, William David
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    পরিচালক
    Barry Road
    East Dulwich
    SE22 0JS London
    214
    United KingdomBritishCompany Solicitor72374560002
    BRUCE, Michael Andrew
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    Royston Manor St Peter's Lane
    Clayworth
    DN22 9AA Retford
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director61928170002
    CONSTABLE, Robert Mark
    9 Mount Road
    GU6 7LT Cranleigh
    Surrey
    পরিচালক
    9 Mount Road
    GU6 7LT Cranleigh
    Surrey
    BritishInsurance Broker115305700001
    DRUMMOND, Peter David
    Angel House
    Angel Street
    GU28 0BJ Petworth
    West Sussex
    পরিচালক
    Angel House
    Angel Street
    GU28 0BJ Petworth
    West Sussex
    BritishInsurance Broker34676460002
    GARNHAM, Jasper Meredydd
    Harewood Lodge Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Harewood Lodge Bulstrode Way
    SL9 7QT Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishInsurance Broker8522110001
    IRONMONGER, Richard Kenneth
    Briar Cottage
    Broadmore Lane
    IP25 6TE Carbrooke
    Norfolk
    পরিচালক
    Briar Cottage
    Broadmore Lane
    IP25 6TE Carbrooke
    Norfolk
    BritishInsurance Broker8852330004
    JERVIS, Ian Michael Peter
    1 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    East Sussex
    পরিচালক
    1 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    East Sussex
    BritishInsurance Broker77237610001
    KAUFMAN, John Banwell
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    পরিচালক
    6 Scotsdale Close
    BR5 1NU Petts Wood
    Kent
    EnglandBritishInsurance Broker147388510001
    KIER, Michael Hector
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    পরিচালক
    23 Belmont Road
    TW2 5DA Twickenham
    Middlesex
    DanishLloyds Broker8719670001
    MANSFIELD, Diane Frances
    Barton
    Crossways Park, West Chiltington
    RH20 2QZ Pulborough
    West Sussex
    পরিচালক
    Barton
    Crossways Park, West Chiltington
    RH20 2QZ Pulborough
    West Sussex
    BritishChartered Accountant64151360001
    MARGRETT, David Basil
    60 Deansway
    Finchley
    N2 0JE London
    পরিচালক
    60 Deansway
    Finchley
    N2 0JE London
    BritishInsurance Broker313150002
    ROWE, Nicholas
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Amberly House
    The Cleave
    OX11 0EL Harwell
    Oxfordshire
    BritishCompany Secretary33862660001
    RUNCIMAN, Jeffrey Keith
    7 Pinfold Close
    Hale Barns
    WA15 0SA Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    7 Pinfold Close
    Hale Barns
    WA15 0SA Altrincham
    Cheshire
    BritishInsurance Broker10020520001
    SANSOM, Richard James
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    পরিচালক
    12 Birch Mead
    Locksbottom
    BR6 8LT Orpington
    Kent
    United KingdomBritishChartered Accountant105966060001
    SIMPER, Anthony
    21 Lambourn Way
    Lords Wood
    ME5 8PU Chatham
    Kent
    পরিচালক
    21 Lambourn Way
    Lords Wood
    ME5 8PU Chatham
    Kent
    BritishInsurance Broker34987510001
    SMITH, Paul David
    Applegarth
    Faygate Lane, Rusper
    RH12 4RF Horsham
    West Sussex
    পরিচালক
    Applegarth
    Faygate Lane, Rusper
    RH12 4RF Horsham
    West Sussex
    EnglandBritishInsurance Broker8522160002
    SPRINGBETT, David John
    Abbey House Huntercombe Lane South
    Taplow
    SL6 0PQ Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    Abbey House Huntercombe Lane South
    Taplow
    SL6 0PQ Maidenhead
    Berkshire
    BritishInsurance Broker12798880001
    SUMMERS, Paul John
    14 Whorlton Road
    SE15 3PD London
    পরিচালক
    14 Whorlton Road
    SE15 3PD London
    BritishInsurance Broker28330910003
    WAKELING, Julian David
    18 Lightwater Meadow
    GU18 5XH Lightwater
    Surrey
    পরিচালক
    18 Lightwater Meadow
    GU18 5XH Lightwater
    Surrey
    EnglandBritishInsurance Broker34987520001
    WARBURTON, Brian
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Great Mead Standon Green End
    High Cross
    SG11 1BP Ware
    Hertfordshire
    BritishInsurance Broker8514310001
    WILKINSON, Ian Michael Colin
    Fuggles Oast Amber Lane
    Chart Sutton
    ME17 3SF Maidstone
    Kent
    পরিচালক
    Fuggles Oast Amber Lane
    Chart Sutton
    ME17 3SF Maidstone
    Kent
    BritishInsurance Broker28330920001

    HEATH LAMBERT INSURANCE SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ ফেব, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to any of the secured parties (as defined) pursuant to all or any of the secured documents (as defined), including the debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ মার্চ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of variation made in addition to and modifying the security and trust deed dated 18 september 1989 ("the principal deed") as modified by a deed of variation dated 1 november 1993 (the "first deed of variation")
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no.5 Of 1988) (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds
    ব্যবসায়
    • ০১ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Second guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the senior finance documents and the debenture as defined therein
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Security Trustee for the Beneficiaries
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of variation
    তৈরি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For varying the terms of the security trust deed dated 18 september 1989
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw required. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of a sum of sterling pounds 75,000 placed on call deposit with barclays de zoete wedd on 16-5-90 under deal reference no 495002, in name of barclays bank PLC re b & c insurance brokers (UK) limited.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Security and trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ সেপ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyds brokers byelaw (no. 5 of 1988) (see form 395 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds
    ব্যবসায়
    • ২৩ সেপ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৩ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Trust deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ মার্চ, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that the company's right title and interest in the monies standing to the credit of the company's "c" account at the date of the trust deed (see doc M135 for further details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Corporation of Lloyds
    ব্যবসায়
    • ০৪ মার্চ, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0