WESSEX TEXTILES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামWESSEX TEXTILES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00312129
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    WESSEX TEXTILES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • কর্মপরিধান উৎপাদন (14120) / উৎপাদন

    WESSEX TEXTILES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    3 Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    Derbyshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    WESSEX TEXTILES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    WESSEX TEXTILES 1988 LIMITED০৭ জুন, ১৯৮৮০৭ জুন, ১৯৮৮
    THOMAS MACK & COMPANY LIMITED২৬ মার্চ, ১৯৩৬২৬ মার্চ, ১৯৩৬

    WESSEX TEXTILES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জানু, ২০১২

    WESSEX TEXTILES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৮ ডিসে, ২০১২

    ২৮ ডিসে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 205,000
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জুল, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Neill Davis এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ২৯ ডিসে, ২০১১ তারিখে Diana Wilson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০৪ জানু, ২০১২ তারিখে Mr. Simon Ralph Hughes-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    ০৬ সেপ, ২০১১ তারিখে Neill Davis-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৬ সেপ, ২০১১ তারিখে Stuart William Graham-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    18 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Diana Wilson-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Neill Davis-এর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Michael Conlon-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে David Edwab-এর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Stuart William Graham-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Douglas Ewert-এর নিয়োগ

    4 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Richard Pearson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Richard Pearson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ২৭ ডিসে, ২০১০ থেকে ৩১ জানু, ২০১১ পর্যন্ত

    3 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    WESSEX TEXTILES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CONLON, Michael
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    সচিব
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    British153966220001
    EDWAB, David
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153964010001
    EWERT, Douglas
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153963360001
    GRAHAM, Stuart William
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    EnglandBritish125975700002
    HUGHES, Simon Ralph
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United KingdomBritish121914600001
    WILSON, Diana
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    United StatesAmerican153963440001
    PEARSON, Graham
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    সচিব
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    British95884040002
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    সচিব
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    British121732790001
    TRAVIS, Joan Marion
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    সচিব
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    British21610990001
    TRAVIS, Lesley Anne
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    সচিব
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British49692080001
    CLARK, Felicity Ann Sarah
    2 Newmans Place
    Sunningdale
    SL5 0HN Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    2 Newmans Place
    Sunningdale
    SL5 0HN Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish117788050001
    DAVIS, Neill
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    পরিচালক
    Long Acres
    Willow Farm
    DE74 2UG Castle Donington
    3
    Derbyshire
    UsaUnited States153966520002
    FOX, David Mark, Mr.
    By Canal Cottage
    Creech St Michael
    TA3 5QD Taunton
    Somerset
    পরিচালক
    By Canal Cottage
    Creech St Michael
    TA3 5QD Taunton
    Somerset
    United KingdomBritish21611010001
    PEARSON, Graham
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    21 The Orchards
    Pickmere
    WA16 0LS Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish95884040002
    PEARSON, Richard Barrett
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    পরিচালক
    20 Croft Road
    Edwalton
    NG12 4BW Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish121732790001
    SHANNON, Edward Anthony
    Barton Beeches
    683 Garstang Road, Barton
    PR3 5DQ Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    Barton Beeches
    683 Garstang Road, Barton
    PR3 5DQ Preston
    Lancashire
    British113624220002
    THOMAS, Adrian Peter Harrison
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    26 Hartley Road
    WA14 4AY Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritish26500450003
    TRAVIS, Joan Marion
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    পরিচালক
    Kessel
    9 Winston Gardens
    HP4 4NS Berkhamsted
    Herts
    British21610990001
    TRAVIS, Malcolm
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Heatherways Frithsden Copse
    Potten End
    HP4 2RQ Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish49692020001
    TRAVIS, Roland
    Kessel 9 Winston Gardens
    HP4 3NS Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Kessel 9 Winston Gardens
    HP4 3NS Berkhamsted
    Hertfordshire
    British21610980001

    WESSEX TEXTILES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. a specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ ডিসে, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0