CIM INVESTMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCIM INVESTMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00335867
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • হেড অফিসের কার্যক্রম (70100) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    CIM INVESTMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    S.ROBERTS (LEAD WASHERS) LIMITED১৫ জানু, ১৯৩৮১৫ জানু, ১৯৩৮

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মে, ২০১৩

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    চার্জ 2 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 3 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    4 পৃষ্ঠাMR04

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ৩১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ অক্টো, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    legacy

    28 পৃষ্ঠাMG01

    legacy

    28 পৃষ্ঠাMG01

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    39 পৃষ্ঠাMEM/ARTS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ অক্টো, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ অক্টো, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ মে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ অক্টো, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    ১২ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Mr Andrew David Livingstone Donald-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DONALD, Andrew David Livingstone
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    সচিব
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    BritishCompany Director41075700003
    DONALD, Andrew David Livingstone
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    পরিচালক
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    EnglandBritishCompany Director41075700003
    TRAVERS, Richard Benjamin
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    পরিচালক
    C/O Calder Industrial Materials
    Jupiter Drive
    CH1 4EX Chester
    EnglandBritishCompany Director103852650001
    HORROCKS, Raymond
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    সচিব
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Director20302800001
    PAPWORTH, Gordon Stanley
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    সচিব
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    British3464790001
    RISING, James Edward
    9 Stampley Close
    Winlaton
    NE21 6EW Blaydon
    Tyne & Wear
    সচিব
    9 Stampley Close
    Winlaton
    NE21 6EW Blaydon
    Tyne & Wear
    British77518230001
    WALKER, Jeffrey Ian
    Old Barn
    Whittingslow
    SY6 6PZ Church Stretton
    Shropshire
    সচিব
    Old Barn
    Whittingslow
    SY6 6PZ Church Stretton
    Shropshire
    British59308250001
    WITHERS, John Granville
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    সচিব
    36 Fern Avenue
    Jesmond
    NE2 2QX Newcastle Upon Tyne
    British43649100001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    কর্পোরেট সচিব
    200 Aldersgate Street
    EC1A 4JJ London
    38508390002
    ALLENZA, Antonino
    40 Alderbrook Road
    B91 1NW Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    40 Alderbrook Road
    B91 1NW Solihull
    West Midlands
    BritishCompany Director39237330001
    COOPER, James
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    পরিচালক
    7 Kirkstyle Avenue
    ML8 5AQ Carluke
    Lanarkshire
    ScotlandBritishCompany Director929150002
    DREW, Stephen
    2 The Oaks
    NE46 2PZ Hexham
    Northumberland
    পরিচালক
    2 The Oaks
    NE46 2PZ Hexham
    Northumberland
    BritishOperations Director40955050001
    HORROCKS, Raymond
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    পরিচালক
    1 Beechcroft
    Swarland
    NE65 9HA Morpeth
    Northumberland
    BritishDirector20302800001
    HUDSON, David John
    Pear Tree Cottage Lower Norgrove
    Alfrick
    WR6 5EX Worcester
    Worcestershire
    পরিচালক
    Pear Tree Cottage Lower Norgrove
    Alfrick
    WR6 5EX Worcester
    Worcestershire
    BritishCompany Director10531420001
    HUDSON, John Lewis
    Inishfree Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Inishfree Penn Lane
    Tanworth In Arden
    B94 5HH Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritishCompany Director12987100004
    LLEWELLYN, Andrew
    Cyfarthfa House
    Wroxton Lane Horley
    OX15 6BD Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Cyfarthfa House
    Wroxton Lane Horley
    OX15 6BD Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector96922350001
    MATHEVE, Jan (Josef Bertha Dymphna Alfons)
    Hermann Rede Machenstrasse 25
    17809 Krefeld
    Nrw
    Germany
    পরিচালক
    Hermann Rede Machenstrasse 25
    17809 Krefeld
    Nrw
    Germany
    BelgianDirector57793530001
    NOLAN, John Barry, Dr
    5 Springfield Park
    DH1 4LS Durham
    County Durham
    পরিচালক
    5 Springfield Park
    DH1 4LS Durham
    County Durham
    BritishGroup Health Safety & Environment Executive17465620001
    PAPWORTH, Gordon Stanley
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Birch
    Carbone Hill
    EN6 4PN Cuffley
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary3464790001
    THOMPSON, Alan Sydney
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    পরিচালক
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    BritishAccountant111389010001
    THOMPSON, Alan Sydney
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    পরিচালক
    39 Mile End Park
    YO42 2TH Pocklington
    North Yorkshire
    BritishAccountant111389010001
    WIGHTMAN, Timothy Redmayne
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Arden House 7 Rowley Crescent
    CV37 6UT Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishCompany Director8610650001

    CIM INVESTMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ আগ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Wells Fargo Bank International
    ব্যবসায়
    • ২৮ আগ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ৩০ মে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ আগ, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ আগ, ২০১২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery.. See image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited
    ব্যবসায়
    • ১৪ আগ, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ৩০ মে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as defined) to the lenders (as defined) under the terms of each or any of the senior finance documents(as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Grenfell & Co. Limited (The "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ জানু, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0