ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিরূপান্তরিত / বন্ধ
    আইনি ফর্মরূপান্তরিত / বন্ধ
    কোম্পানি নম্বর 00335888
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে১১ জানু, ২০১২

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বিবিধ

    Forms b & z - convert to i&ps
    2 পৃষ্ঠাMISC

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Convert to i&ps 14/08/2012
    RES13

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২১ আগ, ২০১২

    ২১ আগ, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১১ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Oldale-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Neil Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে David Hendry এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১১ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ৩১ জুল, ২০১০ তারিখে Mr Neil James Walker-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ জুল, ২০১০ তারিখে Mr George Murray Tinning-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ৩১ জুল, ২০১০ তারিখে Mr David Buchan Hendry-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১১ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mrs Caroline Jane Sellers-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Katherine Eldridge এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১০ জানু, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ১২ জানু, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SELLERS, Caroline Jane
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    সচিব
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    150262030001
    OLDALE, Andrew
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    পরিচালক
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    EnglandBritish167083200001
    TINNING, George Murray
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    পরিচালক
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    United KingdomBritish126913730001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    সচিব
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    British10084840001
    BEWLEY, Bernard
    8 Ash Rise
    ST17 9HE Stafford
    Staffordshire
    সচিব
    8 Ash Rise
    ST17 9HE Stafford
    Staffordshire
    British2087640001
    ELDRIDGE, Katherine Elizabeth
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Cheshire
    সচিব
    5 Stanley Avenue
    Hazel Grove
    SK7 4ED Stockport
    Cheshire
    British127361240001
    JONES, Philip Robert
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    সচিব
    10 Crowhurst Drive
    Whitley
    WN1 2QH Wigan
    Lancashire
    English43686960001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    সচিব
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    British84868550001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    সচিব
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    UCL SECRETARY LIMITED
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    কর্পোরেট সচিব
    United Co Operatives Limited
    Sandbrook Park Sandbrook Way
    OL11 1RY Rochdale
    Lancashire
    111685670001
    ASPRAY, Rodney George
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    Kambara 4 Green Lane
    Poynton
    SK12 1TJ Stockport
    Cheshire
    British2637360001
    BALL, Peter John
    Kimberley Links Drive
    Robin Lane High Bentham
    LA2 7BJ Lancaster
    Lancashire
    পরিচালক
    Kimberley Links Drive
    Robin Lane High Bentham
    LA2 7BJ Lancaster
    Lancashire
    British35323290001
    BEAUMONT, Martin Dudley
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    পরিচালক
    Hand Green House
    Hand Green
    CW6 9SN Tarporley
    Cheshire
    United KingdomBritish10084840001
    BROWN, Alan
    81 Harewood Close
    Norden
    OL11 5TJ Rochdale
    Lancashire
    পরিচালক
    81 Harewood Close
    Norden
    OL11 5TJ Rochdale
    Lancashire
    EnglandBritish31749420001
    DUGMORE, Peter Fawcett
    Woodview
    Boathouse Lane
    WF14 8HQ Mirfield
    Yorkshire
    পরিচালক
    Woodview
    Boathouse Lane
    WF14 8HQ Mirfield
    Yorkshire
    United KingdomBritish88084280001
    HENDRY, David Buchan
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    পরিচালক
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    ScotlandBritish128555100001
    KEW, Philip Anthony
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    পরিচালক
    31 Maypole Gardens
    Wistowgate
    YO8 3TG Cawood
    North Yorkshire
    EnglandBritish84868550001
    SALMONS, Raymond
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    পরিচালক
    Fox Hollow
    Sovereign Lane Ashley
    TF9 4LS Market Drayton
    Shropshire
    British33031700001
    THOMSON, John
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    পরিচালক
    Five Oaks 56 Parkway
    Dairyfields Trentham
    ST4 8AG Stoke On Trent
    Staffordshire
    British57103470001
    WALKER, Neil James
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    পরিচালক
    New Century House
    Corporation Street
    M60 4ES Manchester
    EnglandBritish126913860001
    WALKER, Neil James
    87 Woodsmoor Lane
    Woodsmoor
    SK2 7BD Stockport
    Cheshire
    পরিচালক
    87 Woodsmoor Lane
    Woodsmoor
    SK2 7BD Stockport
    Cheshire
    British98761120001
    WATES, Martyn James
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    পরিচালক
    3 Aylesby Close
    WA16 8AE Knutsford
    Cheshire
    United KingdomBritish60114700001
    YORATH, Delma Rose
    5 Holt Lane Mews
    Failsworth
    M35 9ND Greater Manchester
    পরিচালক
    5 Holt Lane Mews
    Failsworth
    M35 9ND Greater Manchester
    British41961000001
    UCL DIRECTOR 1 LIMITED
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    কর্পোরেট পরিচালক
    United Co-Operatives Limited
    Sandbrook Park
    OL11 1RY Rochdale
    110868260001

    ROBB'S FUNERAL SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ নভে, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    232-238, station road, pendlebury salford, greater manchester title no: gm 279745 and the proceeds of sale thereof together with. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ নভে, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জুন, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জুন, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill and bookdebts.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ জুন, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a land adjoining errwood road, levenshulme subject to mortgages dated 4.9.73. and 20.7.82.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1022 stockport road, lavenshulme, greater manchester title no la 14665. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ নভে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    22 errwood road, levenshulme greater manchester title no:- la 175671. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ নভে, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ নভে, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    230 market street hyde, greater manchester tameside. Title no:- gm 216073. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ নভে, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ অক্টো, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises k/a 1022 stockport road levenshulme manchester title no la 14665. tog with a right of way over the passageway at the back leading to york st and keireen street together with all fixtures attached to the said premises.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Forward Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ অক্টো, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৯ এপ্রি, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Further charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ জুল, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £20,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a legal charge dated 4TH sept 1973 and this charge.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property comprised in a legal charge dated 4-9-73 title no la 175671.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Norwich General Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ আগ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £15,250 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    114 mauldeth road, withington, manchester title no la 364087.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Provincial Life Assurance Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings known as 1022 stockport road, levenshulme, gtr. Manchester title no la 14665. together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ মে, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that plot of l/h land, dwellinghouse & shop known as 230 market street, hyde greater manchester. Together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • William & Glyn's Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ১৬ মে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0