ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামROANDO DEVELOPMENTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00349263
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    5 Wigmore Street
    London
    W1U 1PB
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ROANDO HOLDINGS LIMITED০৬ ফেব, ১৯৩৯০৬ ফেব, ১৯৩৯

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০১২

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    খালি সম্পত্তি দাবিত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাBONA

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    2 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৯ মার্চ, ২০১৩

    ১৯ মার্চ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 100,000
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    ০১ মে, ২০১০ তারিখে Christopher George White-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ মে, ২০১০ তারিখে Mr Maurice Moses Benady-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    3 পৃষ্ঠাCH01

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ২৮ ফেব, ২০১০ তারিখে Trafalgar Officers Limited-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH02

    ০৯ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Reit(Corporate Services) Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH04

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    4 পৃষ্ঠা288a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Section 175 quoted 10/11/2008
    RES13

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    F&C REIT (CORPORATE SERVICES) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট সচিব
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3143222
    79571870006
    BENADY, Maurice Moses
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    পরিচালক
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    Gibraltar
    GibraltarBritish69435160001
    WHITE, Christopher George
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    পরিচালক
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57/63
    GibraltarBritish80132540006
    TRAFALGAR OFFICERS LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    3rd Floor
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর6745658
    135316290001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    সচিব
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    GILBERT, Nicholas Jay
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    সচিব
    Woodville
    14 Carlton Park Avenue
    WF8 3HQ Pontefract
    West Yorkshire
    British81344240001
    JOBBINS, Stuart
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    সচিব
    16 Riverside Avenue
    LS21 2RT Otley
    West Yorkshire
    British108146440001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    সচিব
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    British58693930003
    BELL, John Drummond
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Gates Garth
    49 Rutland Drive
    HG1 2NX Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomBritish63940900001
    BEST, George Laidler
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Kiddall Hall Farm
    York Road Barwick In Elmet
    LS14 3AE Leeds
    West Yorkshire
    British2748600001
    CURTIS, Ernest Leonard
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Cedar Lodge
    Greenfield Lane Hawksworth Guiseley
    LS20 8HF Leeds
    West Yorkshire
    British19382660001
    EVANS, Andreas Frederick
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Leathley Grange
    LS21 2LA Leathley
    North Yorkshire
    United KingdomBritish9485290003
    EVANS, Dominic Redvers
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Pine Lodge
    9 Sandmoor Avenue
    LS17 7DW Leeds
    West Yorkshire
    British7095590001
    EVANS, Frederick Redvers
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    16 Sandmoor Drive
    LS17 7DG Leeds
    West Yorkshire
    British4409160001
    EVANS, Roderick Michael
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    পরিচালক
    Oakhill House
    Roundhay Park Lane
    LS17 8AR Leeds
    British40175270002
    GIBSON, William Mcaulay
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Ivy Bank
    1 Easby Drive
    LS29 9BE Ilkley
    West Yorkshire
    British5387660001
    HORSBROUGH, Pauline Elizabeth
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    30 The Orchard
    Wrenthorpe
    WF2 0LL Wakefield
    West Yorkshire
    United KingdomBritish4961270001
    MCKENDRICK, Charles
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    পরিচালক
    St Anns Main Street
    LS22 5EB Kirk Deighton
    North Yorkshire
    United KingdomBritish173983190001
    MILLINGTON, Paul Terence
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    পরিচালক
    2a Gilleyfield Avenue
    Dore
    S17 3NS Sheffield
    United KingdomBritish58693930003
    PARRISH, Trevor Lawton
    46 Congreve Way
    Bardsey
    LS17 9BG Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    46 Congreve Way
    Bardsey
    LS17 9BG Leeds
    West Yorkshire
    British15527330001
    TURNER, Philip Arthur
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Red Roofs 2 Mulberry Garth
    Thorp Arch
    LS23 7AF Wetherby
    West Yorkshire
    British66424440001
    REIT(CORPORATE DIRECTORS) LIMITED
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    কর্পোরেট পরিচালক
    5 Wigmore Street
    W1U 1PB London
    74030120002

    ROANDO DEVELOPMENTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage land and buildings on the west side of millshaw, beeston, leeds, west yorkshire t/nos. WYK488274 and WYK193393 and the goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ অক্টো, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০১ নভে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of legal mortgage:-all that f/h land and buildings k/as 22-30 (even) new york street and 13 & 15 harper street leeds west yorkshire.t/no.wyk 541898 the present or future goodwill of any business carried on at the property. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and the plant machinery fixtures and fittings furniture equipment implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০১ নভে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ ডিসে, ১৯৯৯বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related facility documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on east of tramway road irlam t/n GM259157 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever pursuant to the term loan facility letter dated 6TH june 1994 and/or any other related financial documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 6 tyrawley road london t/n LN103163 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ সেপ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due from evans (holdings) limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    44 to 60 (even) richarshaw lane pudsey t/n WYK420976 tog: with all fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ এপ্রি, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities which now are or at any time herafter may become due from the company to lloyds bank PLC ("the bank") under or in respect of such part of the company's guarantee liability to the bank as may arise from facilities granted to evans (holdings) limited pursuant to a loan agreement dated the 2ND april 1993 on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 10 manor street leeds together with all buildings and fixtures thereon and goods, by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on at the property aforesaid, by way of assignment the benefit of all guarantees or covenants (as defined).. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ এপ্রি, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due from the company and/or evans universal limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that the f/h land and premises k/a land and buildings on the south side of manor street leeds t/no.WYK315874.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Bank of Nova Scotia
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit of deeds
    তৈরি করা হয়েছে ২০ আগ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ আগ, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    6 tyrawley road fulham london.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ আগ, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit of deeds
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    44/160 (even numbers) richardshaw lane, pudsey title no wyk 420976.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deposit of deeds
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ ফেব, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Thames trading centre, fairbells road, irlam manchester title no gm 259157.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deeds & documents relating to the f/h property k/a land situate at millshaw beeston leeds.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ মার্চ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৩ অক্টো, ১৯৯২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১১ জুন, ২০০২বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৫ জুন, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Memorandum of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from evans universal limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All that property situate at rawdon with all fixtures fittings (other than trade fixtures and fittings) plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ মার্চ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ আগ, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৭৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn/harrogage limited and/or l hudson (yorks) limited
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    17, 18, 19 & 20 york place harrogate west yorks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mercantile Credit Company Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The west side of bredford road, batley, yorkshire together with all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn (barnsley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Three parcels of land fronting john street & thomas street, barnsley, yorkshire together with all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৪ ডিসে, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    17, 18, 19 & 20 york place, harrogate together with all fixtures.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ নভে, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ ডিসে, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    New street & john street, barnsley yorkshire, together with all fixtutes.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ ডিসে, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn (barusley) LTD and or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land situated in new street and john street, barusley, west riding, yorks. Together with all buildings erected thereon. (See doc 123 for full details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mercantile Credit Co LTD
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৭৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৭৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from rowland winn (batley) LTD and/or all or any of the other companies named therein. To the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the west side of bradford road, batley, west riding, yorkshire. With buildings erected thereon. (See doc 122 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mercantile Credit Co LTD
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ১৯৭৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৭২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৭২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on south side of santengley lane, crofton, yorks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ১৯৭২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Memo of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ নভে, ১৯৬৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ১৯৬৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at altofts, normanton. Title no. Yk 17464.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ১৯৬৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Instrument of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ১৯৬৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৬৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due etc
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, park grove, & joiners workshop & garage in park terraces for headingley, leeds.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৬৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge by deposit of deeds
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ১৯৬৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ফেব, ১৯৬৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due etc.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land at south and south west side of durkar low lane, durker, wakefield, yorks.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Yorkshire Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ২২ ফেব, ১৯৬৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Memorandum of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১১ আগ, ১৯৬৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ আগ, ১৯৬৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due etc.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land near broadowler lane, ossett.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ আগ, ১৯৬৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Instr of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৬৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মে, ১৯৬৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings on west side of boston road, aforesaid. Title no. Yk 3815.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মে, ১৯৬৬একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0