TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00349879
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    TAYLOR-BLOXHAM LIMITED২৩ ফেব, ১৯৩৯২৩ ফেব, ১৯৩৯

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১৮

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    প্রশাসন থেকে দ্রবণে স্থানান্তরের নোটিশ

    36 পৃষ্ঠাAM23

    বদলি বা অতিরিক্ত প্রশাসক নিয়োগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM11

    প্রশাসককে পদ থেকে অপসারণের আদেশের বিজ্ঞপ্তি

    17 পৃষ্ঠাAM16

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    29 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    33 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    35 পৃষ্ঠাAM10

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    65 পৃষ্ঠাAM03

    ১৪ ফেব, ২০২০ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 17-21 Tolwell Road Leicester Leicestershire LE4 1BR থেকে C/O Frp Advisory Llp 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4ABপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    29 পৃষ্ঠাAA

    ২৮ মে, ২০১৯ তারিখে Jacqueline Sharpless-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জুন, ২০১৯ তারিখে Mr Robert Charles Lockwood-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২০ মে, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mrs Teresa-Anne Dunleavy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ০১ অক্টো, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Graham John Farrell এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    চার্জ 24 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    চার্জ 003498790025 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    ০১ জুন, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Moss এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    3 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name০১ মে, ২০১৮

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ০১ মে, ২০১৮

    RES15

    ৩১ মার্চ, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ১৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে Ms April Jacqueline Sharpless-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৪ মার্চ, ২০১৮ তারিখে Mrs April Jacqueline Moss-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DUNLEAVY, Teresa-Anne
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    পরিচালক
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritishCompany Director137425310001
    LOCKWOOD, Robert Charles
    College Barn
    Thornborough Road Padbury
    MK18 2AH Buckingham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    College Barn
    Thornborough Road Padbury
    MK18 2AH Buckingham
    Buckinghamshire
    EnglandBritishFinance Director98046670002
    SHARPLESS, April Jacqueline
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    পরিচালক
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritishDirector150002490008
    SHARPLESS, Jacqueline
    Swinfield Road
    Quorn
    LE12 8RJ Loughborough
    10
    England
    পরিচালক
    Swinfield Road
    Quorn
    LE12 8RJ Loughborough
    10
    England
    EnglandBritishAdmin Assistant7436780002
    SYKES, Wesley Mark
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Co Frp Advisory Llp
    England
    পরিচালক
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Co Frp Advisory Llp
    England
    EnglandBritishProduction Director29975680002
    WENNINGTON, Matthew Robert
    23 Navigation Drive
    Glen Parva
    LE2 9TB Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    23 Navigation Drive
    Glen Parva
    LE2 9TB Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritishIt Director78232170002
    BERRY, David
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    সচিব
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    BritishAccountant30955700001
    SHARPLESS, Jacqueline
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    British7436780001
    BOWEN, Christopher Paul
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    পরিচালক
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    United KingdomBritishChief Executive71847370001
    FARRELL, Graham John
    6 Orlando Close
    CV22 6LT Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    6 Orlando Close
    CV22 6LT Rugby
    Warwickshire
    EnglandBritishSales Director126763280001
    FARRELL, Graham John
    24 Russell Avenue
    Dunchurch
    CV22 6PX Rugby
    Warwickshire
    পরিচালক
    24 Russell Avenue
    Dunchurch
    CV22 6PX Rugby
    Warwickshire
    BritishSales Director36128300002
    GRAHAM, David Stuart
    The Bungalow Bond Lane
    Heage
    DE56 2AH Belper
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Bungalow Bond Lane
    Heage
    DE56 2AH Belper
    Derbyshire
    BritishBusiness Develpment Director32018670001
    HAMMOND, Peter William
    7 Spinney Close
    Groby
    LE6 0BY Leicester
    পরিচালক
    7 Spinney Close
    Groby
    LE6 0BY Leicester
    BritishDirector7459650002
    HOLMES, Peter Stephen
    51 Dunton Road
    Broughton Astley
    LE9 6NA Leicester
    পরিচালক
    51 Dunton Road
    Broughton Astley
    LE9 6NA Leicester
    BritishDirector7674010002
    HOLOHAN, Paul Michael
    The New House, Church Farm
    Houghton-On-The-Hill
    LE7 9HE Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    The New House, Church Farm
    Houghton-On-The-Hill
    LE7 9HE Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishDirector69485900001
    LAKIN, James Michael Wilson
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    পরিচালক
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    EnglandEnglishCommercial Director29975670003
    LINDOP, Roger
    Portland Crescent
    HG1 2QS Harrogate
    18
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Portland Crescent
    HG1 2QS Harrogate
    18
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector142362320001
    MOSS, Kevin
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    পরিচালক
    17-21 Tolwell Road
    Leicester
    LE4 1BR Leicestershire
    Gb-EngBritishMarketing Director147463820001
    RICHARDSON, April Jacqueline
    1 Glebelands Road
    LE4 2WB Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    1 Glebelands Road
    LE4 2WB Leicester
    Leicestershire
    BritishHuman Resource Dir53165470003
    SHARPLESS, Frederick Bruce Cave
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    পরিচালক
    48 Main Street
    Barkby
    LE7 3QG Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritishPrinter7436790001
    WHITE, Kevin John
    12 Grove Gardens
    Woodland Grange
    B61 0UG Bromsgrove
    Worcestershire
    পরিচালক
    12 Grove Gardens
    Woodland Grange
    B61 0UG Bromsgrove
    Worcestershire
    BritishSales Director29975660002

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    The Print People Group Limited
    Tolwell Road
    LE4 1BR Leicester
    16-21 Tolwell Road
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Tolwell Road
    LE4 1BR Leicester
    16-21 Tolwell Road
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEnglish Law
    নিবন্ধিত স্থানEngland And Wales
    নিবন্ধন নম্বর03655511
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০১৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ২০১৭
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Close Brothers Limited (The “Security Trustee”)
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ২০১৭একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মে, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    বেয়ার ট্রাস্টি হিসাবে কাজ করা চার্জর: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC as Security Trustee for Each Group Member
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ১৯ জুন, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ এপ্রি, ২০১১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Santander UK PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ১৯ জুন, ২০১৮একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ ডিসে, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ge Commercial Finance Limited
    ব্যবসায়
    • ৩০ ডিসে, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৮ নভে, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Legal assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited ("the Security Holder")
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Floating charge (all assets)
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ মার্চ, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Invoice Finance (UK) Limited ("the Security Holder")
    ব্যবসায়
    • ১৩ মার্চ, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০১০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জানু, ২০১০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Heidelberg speedmaster 102 twelve colour press s/no 543874.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Equipment Finance(UK) LTD
    • Hsbc Asset Finance (UK) LTD
    ব্যবসায়
    • ৩০ জানু, ২০১০একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    • ২৫ আগ, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h usm house warren park enderby leicester t/n LT341693,. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ মে, ২০০৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings on the west side of tyrrell street and north west side of nugent street, leicester. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১১ মে, ২০০৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattels mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Heidelberg speedmaster 102FP 5 + 0 or 2 + 3 s/no: 533780.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৪ মে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under a lease of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £80000 deposit.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lenton Lane Estates (Leicester) Limited
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Chattel mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 'heidelberg' 102VP 72CM x 102CM four-colour/perfector offset lithographic printing machine no. 534295 with full pile suction feeder, (see continuation sheet to 395 for full details).. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Capital Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ সেপ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed equitable charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book and other debts subject to the factoring agreement. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Griffin Factors Limited
    ব্যবসায়
    • ৩১ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ নভে, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 23/10/68
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge on all goodwill uncalled capital all patents/applications inventions trade marks/names registered designs copyrights & all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & premises on the west side of tyrrell street leicester.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land hereditaments and premises being:- junction of tyrrell street and nugent street leicester title no:- LT137934.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ মার্চ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মার্চ, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & buildings to the north west of nugent road leicester title no LT79166.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মার্চ, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৬ নভে, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H lands & premises being factory at, nugent street leicester or the proceeds of sale thereof title no LT171745.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ নভে, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ নভে, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge a muller martini model 1509 minitman saddlesticker serial no 9906389 floating charge all contracts and all guarantees indemnities and other documents please see doc M92.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • British Credit Trust Limited
    ব্যবসায়
    • ০৮ নভে, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ জানু, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ মার্চ, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Factory & premises north west side nugent street leicester or the proceeds of the sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ২১ মার্চ, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৫ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Collateral mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from barkby thorpe press limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises to the north west side of nugent street leicester together with buildings & fixtures & space heating equipment title no lt 79166.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ১২ মার্চ, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৮২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All book debts & other debts due, owing or incurred to the company present & future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ জুল, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises to the north west side of nugent rd, leicester, tog with all buildings & fixtures & space heating equipment thereon title no lt 79166.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ০৫ ডিসে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন

    TAYLOR BLOXHAM GROUP LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ ফেব, ২০২০প্রশাসন শুরু
    ২৬ অক্টো, ২০২১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    John Anthony Lowe
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    অভ্যাসকারী
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Ben Woolrych
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    অভ্যাসকারী
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Anthony Collier
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    অভ্যাসকারী
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0