JACKSON PROPERTIES II LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামJACKSON PROPERTIES II LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00351965
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    JACKSON CONSTRUCTION LIMITED০১ সেপ, ২০০৬০১ সেপ, ২০০৬
    ISG JACKSON LIMITED১৩ জুল, ২০০৬১৩ জুল, ২০০৬
    JACKSON BUILDING LIMITED০৯ জানু, ২০০৩০৯ জানু, ২০০৩
    PEARSON BUILDING LIMITED২২ জুল, ১৯৮৭২২ জুল, ১৯৮৭
    FRED PEARSON & CO.LIMITED১৭ এপ্রি, ১৯৩৯১৭ এপ্রি, ১৯৩৯

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ জুন, ২০১১
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০১২
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১০

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৩ জুল, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৭ জুল, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    2 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ জুল, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ জুল, ২০১১

    ১৫ জুল, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed jackson construction LIMITED\certificate issued on 31/03/11
    2 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name৩১ মার্চ, ২০১১

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ৩০ মার্চ, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    11 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ জুল, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ১২ জুল, ২০১০ তারিখে Jared Stephen Philip Cranney-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ জুল, ২০১০ তারিখে Mr Samuel David Lawther-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ জুল, ২০১০ তারিখে Jared Stephen Philip Cranney-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    ২৯ জুন, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Share capital redemption reserve of the company cancelled and the aggregate amount arising in such reduction and cancellation to the profit and loss reserves of the company 29/06/2010
    RES13

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    সমিতির এবং সংবিধির নথি

    24 পৃষ্ঠাMEM/ARTS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    25 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জুন, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CRANNEY, Jared Stephen Philip
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    সচিব
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    British74806700006
    CRANNEY, Jared Stephen Philip
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    পরিচালক
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    United KingdomBritishChartered Secretary74806700006
    LAWTHER, Samuel David
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    পরিচালক
    C/O Interior Services Group Plc
    Aldgate House
    EC3N 1AG 33 Aldgate High Street
    London
    EnglandBritishCompany Director154579210001
    PALMER, Peter Edward
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    সচিব
    Hill Top Farm
    Asenby
    YO7 3QN Thirsk
    North Yorkshire
    British21105820001
    PAYNE, Lorraine Grace
    2 Huntington Crescent
    Headingley
    LS16 5RT Leeds
    সচিব
    2 Huntington Crescent
    Headingley
    LS16 5RT Leeds
    British52221890003
    WRIGHT, Arthur Desmond
    14 The Crescent
    Blaxton
    DN9 3AS Doncaster
    South Yorkshire
    সচিব
    14 The Crescent
    Blaxton
    DN9 3AS Doncaster
    South Yorkshire
    British2797880001
    BEST, David Martin
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    34 Vicarage Meadows
    WF14 9JL Mirfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector47892490001
    BRAMWELL, David Matthew
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Woodlands 2a Woodland Rise
    WF2 9DL Wakefield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector4250980001
    BRIERLEY, Philip
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Warren House The Ridge
    Linton
    LS22 4HJ Wetherby
    West Yorkshire
    BritishDirector54808010001
    BROWN, Neil
    23 Nab Wood Drive
    BD18 4HP Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    23 Nab Wood Drive
    BD18 4HP Shipley
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant15505750001
    JACKSON, David James
    41 Norwood Park
    Birkby
    HD2 2DU Huddersfield
    Yorkshire
    পরিচালক
    41 Norwood Park
    Birkby
    HD2 2DU Huddersfield
    Yorkshire
    BritishDirector62867720001
    JONES, Richard James
    Stonegarth
    Beech Lane
    HG3 1AN Spofforth
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Stonegarth
    Beech Lane
    HG3 1AN Spofforth
    West Yorkshire
    BritishCompany Director78917370001
    PORTER, John Robert
    31 Stonecross Gardens
    Cantley
    DN4 6QF Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    31 Stonecross Gardens
    Cantley
    DN4 6QF Doncaster
    South Yorkshire
    BritishSurveyor13565460001
    ROGAN, Anthony
    5 Winterburn Hill
    Warley
    HX2 7SQ Halifax
    West Yorkshire
    পরিচালক
    5 Winterburn Hill
    Warley
    HX2 7SQ Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector101989070001
    TOWN, John Edward
    2 Robin Hood Road
    Edenthorpe
    DN3 2JQ Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    2 Robin Hood Road
    Edenthorpe
    DN3 2JQ Doncaster
    South Yorkshire
    BritishSurveyor13565470001
    WRIGHT, Arthur Desmond
    14 The Crescent
    Blaxton
    DN9 3AS Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    14 The Crescent
    Blaxton
    DN9 3AS Doncaster
    South Yorkshire
    BritishSurveyor2797880001

    JACKSON PROPERTIES II LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a pearson building limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a phoenix warehouse high street hull t/n HS148089. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly k/a pearson building limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a land lying to the west of marshland road moorends doncaster south yorkshire t/n SYK454486. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৫ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ জানু, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ জানু, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money and liabilities in any manner whatsoever due or to become due from the company,formerly known as pearson building limited,to the senior lenders,mezzanine lenders,investor lenders and working capital bank under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১০ জানু, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৩ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings to south west of pipering lane bentley together with fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Phoenix warehouse high street kingston upon hull together with fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ ফেব, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land lying to the west of marshland road moorends together with fixtures and fittings. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ মে, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or P.S.rushworth limited. To the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital, with fixed plant machinery and fixtures (including trade fixtures) (see doc. M54 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Yorkshire Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ০৩ মে, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০২ এপ্রি, ১৯৯৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0