UNION PUMP LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামUNION PUMP LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00366985
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    UNION PUMP LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    UNION PUMP LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    . Green Road
    Penistone
    S36 6BJ Sheffield
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    UNION PUMP LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    DAVID BROWN UNION PUMPS LIMITED০৩ এপ্রি, ১৯৯৮০৩ এপ্রি, ১৯৯৮
    DAVID BROWN PUMPS LIMITED২৮ মার্চ, ১৯৮৯২৮ মার্চ, ১৯৮৯
    DAVID BROWN PUMPS & FABRICATIONS LIMITED২২ জুন, ১৯৮৮২২ জুন, ১৯৮৮
    DAVID BROWN ESTATES LIMITED০৭ মে, ১৯৪১০৭ মে, ১৯৪১

    UNION PUMP LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    UNION PUMP LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৬ মে, ২০১৬

    ১৬ মে, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 582,222
    SH01

    ২৬ সেপ, ২০১৫ তারিখে Jeremy Wade Smeltser-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২৬ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Balkar Sohal এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৬ সেপ, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Paul Andrew Cahill-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৭ মে, ২০১৫

    ২৭ মে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 582,222
    SH01

    ০৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Kevin Lucius Lilly এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stephen Tsoris-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২২ সেপ, ২০১৪ তারিখে Mr Balkar Sohal-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ২২ সেপ, ২০১৪ তারিখে Mark Edward Shanahan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ জুন, ২০১৪

    ১১ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 582,222
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Christopher Brown এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Thomas Brown এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৫ মে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে Mr Kevin Lucius Lilly-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ জানু, ২০১৩ তারিখে Jeremy Wade Smeltser-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১২ মে, ২০১৩ তারিখে Mr Balkar Sohal-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৫ মে, ২০১৩ তারিখে Mark Edward Shanahan-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    পরিচালক হিসাবে Allan Dowie এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    UNION PUMP LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    CAHILL, Paul Andrew
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    Spx International Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant202085370001
    SHANAHAN, Mark Edward
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    পরিচালক
    Ocean House, Towers Business Park
    Didsbury
    M20 2LY Manchester
    C/O Spx Europe Shared Services Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector165707440001
    SMELTSER, Jeremy Wade
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    পরিচালক
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanCfo, Spx Flow, Inc.163313000001
    TSORIS, Stephen
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    পরিচালক
    Ballantyne Corporate Place
    NC 28277 Charlotte
    13320
    North Carolina
    Usa
    United StatesAmericanDirector197069810001
    ASHMAN, Linda Margaret
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    সচিব
    Blue Fields
    421 Huddersfield Road, Shelley
    HD8 8NE Woodhouse Huddersfield
    West Yorkshire
    British86730910001
    BROWN, Thomas James
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    সচিব
    57 Randolph Road
    G11 7JJ Glasgow
    BritishCompany Secretary60773560001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    সচিব
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    British29591090001
    TULLEY, Karen Ann
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    সচিব
    Knottside Farm
    The Knott, Pateley Bridge
    HG3 5DQ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishSolicitor59112980002
    AINSCOUGH, Paul Wayne
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    পরিচালক
    Apartment 301 Valley Mill
    Cottonfields Eagley Brook
    BL7 9DY Bolton
    Lancashire
    EnglandBritishFinance Director1876370002
    ANDREWS, Alan
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    27 Hill Top Road
    Salendine Nook
    HD3 3SW Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishAftermarket Director52101720001
    BAILEY, Derek
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    26 Pennine Rise
    Scissett
    HD8 9JE Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishEngineering And Technical Serv29591110001
    BLACKWELL, Malcolm
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    পরিচালক
    Pogstone House 19 Cuckstool Road
    Denby Dale
    HD8 8RF Huddersfield
    United KingdomBritishManaging Director40752710001
    BRADWELL, Garth Jeffrey
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    পরিচালক
    5 Nightingale Croft
    Thorpe Hesley
    S61 2UB Rotherham
    South Yorkshire
    BritishFinance Director66587570001
    BROWN, Christopher John
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Grange Bent Lane
    Sutton In Craven
    BD20 7AL Keighley
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Managing Director1698880001
    COOK, Christopher David
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    পরিচালক
    Beauchamp House
    Church Road
    CV35 8AN Sherbourne
    Warwickshire
    United KingdomBritishGroup Managing Director1698890001
    COWAN, Jonathan Brandon
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    5 Warwick Avenue
    Hale
    WA15 9EA Altrincham
    Cheshire
    BritishFinance Director29591090001
    DOWIE, Allan Cameron
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    পরিচালক
    Arkaig Place
    Newton Mearns
    G77 5PH Glasgow
    7
    United KingdomBritishFinance Director132053460001
    ELSBORG, Anton Cecil
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Woodstock
    Thorpe Lane
    LS20 8LE Leeds
    West Yorkshire
    EnglandBritishGroup Finance Director93041580001
    GARNER, Philip Frank
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    পরিচালক
    83 Barrow Road
    Quorn
    LE12 8DH Loughborough
    Leicestershire
    BritishCompany Director48137730001
    HOBBS, David John
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    1a Towngate
    Highburton
    HD8 0QP Huddersfield
    West Yorkshire
    BritishFinance Dir48318550001
    HOLLAND, Mark Harry
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    পরিচালক
    219 Huddersfield Road
    Thongsbridge
    HD9 3TT Holmfirth
    West Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant98168130001
    LILLY, Kevin Lucius
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    পরিচালক
    Ballantyne Corporate Place
    NC28277 Charlotte
    13220
    North Carolina
    Usa
    UsaAmericanDirector165775730001
    LODGE, Christopher Martin
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    21 Birchland Drive
    Killamarsh
    S31 8GL Sheffield
    South Yorkshire
    BritishOperations Director48087890001
    O'LEARY, Patrick Joseph
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    পরিচালক
    Ballantyne
    Corporate Place
    Charlotte
    13515
    Nc 28277
    Usa
    United StatesAmericanBusiness Director61807850002
    PENNING, Graham Michael
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    36 Riley Park
    Kirkburton
    HD8 0SA Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishVice President Of Engineering12354670001
    ROWLEY, Stephen Nicholas
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    পরিচালক
    Pond Farm House Midway
    South Crosland
    HD4 7DA Huddersfield
    BritishCompany Director47869520001
    SCHREIBER, Gregory
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    পরিচালক
    6157 Bethany Circle
    Richland
    Michigan 49083
    Usa
    AmericanPresident71227450001
    SOHAL, Balkar
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Hambridge Road
    RG14 5TR Newbury
    C/O Spx Flow Technology Limited
    Berkshire
    United Kingdom
    EnglandEnglishChartered Accountant161546310001
    STRUDWICK, Tony
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    17 Broomleaf Road
    GU9 8DG Farnham
    Surrey
    BritishSales Director38754410001

    UNION PUMP LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ অক্টো, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All sums and liabilities (without limitation) due or to become due from the company and the obligors (as defined in the debenture) to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref m*92. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ অক্টো, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ আগ, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due frok each obligor to the chargee as agent & trustee for itself, the charges & for each b ank on any account whatsoever, under the terms of the financing documents (all terms as defined in a credit agreement dated 24.1.90)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (For full details refer no doc 395 ref M98). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Bankers Trust Company
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৪ জানু, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor as defined in the charge as agent & trustee for itself & for each lender (as defined in the charge) on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Please see doc m 44 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • First Britannia Mezzanine Capital Bv
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ নভে, ১৯৯২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুল, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুল, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ জুন, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including heritable property & assets in scotland.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ জুন, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ জানু, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See m 132). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ জানু, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over all f/h & l/h property all buildings, fixtures fixed plant & machinery all goodwill & un-called capital, all book & other debts. Floating charge over all undertaking and all property and assets present and future (see M131).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • First Wisconsin National Bank of Milwaukee
    ব্যবসায়
    • ২৮ অক্টো, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H chequers mann estate, carmore end, high wycombe buckinghamshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৬ অক্টো, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/L cobstone mill, ibstone bucks. As comprised in a conveyance dated 15/7/82.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Deposit of deeds without written instrument
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ আগ, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ সেপ, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Chequers manor estate cadmore end high wycombe buckinghamshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ সেপ, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0