PERSEVERANCE MILLS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPERSEVERANCE MILLS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00405667
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (1730) /

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Albion Mill
    Padiham
    BB12 7DY Lancs
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PERSEVERANCE MILL COMPANY LIMITED(THE)০৭ মার্চ, ১৯৪৬০৭ মার্চ, ১৯৪৬

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০০৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ জানু, ২০০৬
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ মার্চ, ২০০৪

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১১ আগ, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৫ আগ, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ২৬ ফেব, ২০২৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Lawrence Glasgow এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    legacy

    1 পৃষ্ঠাLQ02

    ০৭ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    ০৭ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    2 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    রিসিভারের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের সারসংক্ষেপ

    3 পৃষ্ঠা3.6

    legacy

    1 পৃষ্ঠা405(1)

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    annual-return২৮ আগ, ২০০৩

    legacy

    363(288)

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০২ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ মার্চ, ২০০১ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    8 পৃষ্ঠা363s
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    annual-return২৩ আগ, ২০০১

    legacy

    363(288)

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DEARDEN, Ian Stuart
    9 Ramsdenwood Road
    Walsden
    OL14 7UD Todmorden
    সচিব
    9 Ramsdenwood Road
    Walsden
    OL14 7UD Todmorden
    British95084170001
    BAINES, Garry
    137 Sale Lane
    M29 8PA Tyldesley
    Greater Manchester
    পরিচালক
    137 Sale Lane
    M29 8PA Tyldesley
    Greater Manchester
    BritishManaging Director52959160002
    HUGHES, Stephen John
    Clough Mill
    Higham Hall Road, Higham
    BB12 9EZ Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    Clough Mill
    Higham Hall Road, Higham
    BB12 9EZ Burnley
    Lancashire
    BritishDirector63900590001
    EAST, John Robert
    March House, The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HY Thatcham
    সচিব
    March House, The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HY Thatcham
    BritishCo Director95208130001
    HARGREAVES, Alan
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    সচিব
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    BritishFinancial Director13840020001
    HARGREAVES, Alan
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    সচিব
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director13840020001
    TOWNLEY, Simon
    11 Rothwell Court
    Leyland
    PR5 1NU Preston
    Lancashire
    সচিব
    11 Rothwell Court
    Leyland
    PR5 1NU Preston
    Lancashire
    British22186310001
    BAINES, Garry
    18 Debdale Lane
    Astley
    M29 7FL Tyldesley
    Gt Manchester
    পরিচালক
    18 Debdale Lane
    Astley
    M29 7FL Tyldesley
    Gt Manchester
    BritishDirector52959160001
    BOOTH, James Spencer
    1 Earnsdale Close
    BB3 1RG Darwen
    Lancashire
    পরিচালক
    1 Earnsdale Close
    BB3 1RG Darwen
    Lancashire
    BritishManufacturing Director30160380002
    BOOTH, James Spencer
    1 Earnsdale Close
    BB3 1RG Darwen
    Lancashire
    পরিচালক
    1 Earnsdale Close
    BB3 1RG Darwen
    Lancashire
    BritishDirector30160380002
    CHAPMAN, Keith Anthony
    Redbrook House
    29 Bollin Hill
    SK9 4AN Wilmslow
    Cheshire
    পরিচালক
    Redbrook House
    29 Bollin Hill
    SK9 4AN Wilmslow
    Cheshire
    EnglandBritishDirector29941940001
    COOPER, Ian
    3 Marsden Fold
    Coldweather Avenue
    BB9 0ET Nelson
    Lancashire
    পরিচালক
    3 Marsden Fold
    Coldweather Avenue
    BB9 0ET Nelson
    Lancashire
    BritishDirector41436690001
    EAST, John Robert
    March House, The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HY Thatcham
    পরিচালক
    March House, The Ridge, Cold Ash
    RG18 9HY Thatcham
    United KingdomBritishCo Director95208130001
    ELLIOTT, Jan
    33 Highfield Road
    Cheadle Hulme
    SK8 6EN Cheadle
    Cheshire
    পরিচালক
    33 Highfield Road
    Cheadle Hulme
    SK8 6EN Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritishManaging Director14902170001
    ELLIOTT, Jan
    33 Highfield Road
    Cheadle Hulme
    SK8 6EN Cheadle
    Cheshire
    পরিচালক
    33 Highfield Road
    Cheadle Hulme
    SK8 6EN Cheadle
    Cheshire
    EnglandBritishDirector14902170001
    GLASGOW, Simon Lawrence
    Chalet Pro Dzian
    CH1936 Chemin Damon
    Verbier Ch 1936
    Switzerland
    পরিচালক
    Chalet Pro Dzian
    CH1936 Chemin Damon
    Verbier Ch 1936
    Switzerland
    SwitzerlandBritishCompany Director75169830002
    HARGREAVES, Alan
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    BritishFinancial Director13840020001
    HARGREAVES, Alan
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    পরিচালক
    9 Springclough Drive
    Worsley
    M28 3HS Manchester
    Lancashire
    BritishCompany Director13840020001
    HOLMES, John
    Roseneath Whine Lane
    Simonstone
    BB12 7QU Padiham
    Lancashire
    পরিচালক
    Roseneath Whine Lane
    Simonstone
    BB12 7QU Padiham
    Lancashire
    BritishDirector30160350001
    INGLIS, Trevor
    126 Richmond Avenue
    BB10 4JL Cliviger
    Lancashire
    পরিচালক
    126 Richmond Avenue
    BB10 4JL Cliviger
    Lancashire
    BritishSales Marketing121315220001
    JAMES, Peter Stoyle
    7 Vicarage Close
    Station Road Wrea Green
    PR4 2PQ Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    7 Vicarage Close
    Station Road Wrea Green
    PR4 2PQ Preston
    Lancashire
    EnglandBritishDirector937840003
    MORRIS, David William
    74 Kiddrow Lane
    BB12 6LH Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    74 Kiddrow Lane
    BB12 6LH Burnley
    Lancashire
    BritishCompany Director30160360001
    MORRIS, David William
    74 Kiddrow Lane
    BB12 6LH Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    74 Kiddrow Lane
    BB12 6LH Burnley
    Lancashire
    BritishDirector30160360001
    TOWNLEY, Simon
    11 Rothwell Court
    Leyland
    PR5 1NU Preston
    Lancashire
    পরিচালক
    11 Rothwell Court
    Leyland
    PR5 1NU Preston
    Lancashire
    BritishDirector22186310001
    WATSON, Alexander Ernest
    Ridgemead
    Mill Lane
    HP8 4NR Chalfont-St-Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Ridgemead
    Mill Lane
    HP8 4NR Chalfont-St-Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director18239870001

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Second supplemental debenture supplemental to a debenture executed on 31ST january 1997
    তৈরি করা হয়েছে ১০ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৭ জুল, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting for itself and as trustee on behalf of the investors under the investment agreement which for the avoidance of doubt includes the lenders of the loan the lenders of the additional loan and the lenders of the second additional loan and their respective successors and assigns
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ১৭ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplememntal debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the investment agreement and the supplemental agreement (as defined in the debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a guarantee and indemnity of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All estates & interests in any l/h property and f/h land and buildings on the south side of abingdon street and on the west and east side of wytham street padiham burnley lancs t/no LA400650 with all buildings fixtures fixed plant & machinery and the proceeds of sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a guarantee and indemnity of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All interests in any l/h & f/h land and buildings on the west side of moorgate street blackburn lancs t/no la 569210 with all buildings & fixtures fixed plant & machinery and the proceeds of sale thereof.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities now due or to become due from the company to the chargees pursuant to the terms of a guarantee and indemnity of even date
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • 3I PLC for Itself and as Trustee for the Investors (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৩ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৬ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ এপ্রি, ২০০৫একজন প্রাপক বা ম্যানেজার নিয়োগ (405 (1))
    • 1২৪ মার্চ, ২০১০একজন প্রাপক বা ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা বন্ধ করার নোটিশ (LQ02)
      • মামলা নম্বর 1
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h land and buildings on the west side of moorgate street blackburn lancashire t/n LA569210 all buildings and other structures the goodwill relating to the property all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ জানু, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ১৯৯৭
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/a land and buildings on the south side of abingdon street and on the west and east sides of witham street padiham t/n LA400650 all buildings and other structures the goodwill relating to the property all plant machinery and other items thereon assigns the rental sums with the benefit of all rights and remedies. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    PERSEVERANCE MILLS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩১ জানু, ১৯৯৭যন্ত্রের তারিখ
    প্রশাসনিক রিসিভার নিযুক্ত
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Philip James Long
    Pkf
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Pkf
    Pannell House
    LS1 2TW 6 Queen Street
    Leeds
    Ian Christopher Schofield
    Pkf
    Pannell House
    LS1 2TW 8 Queen Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Pkf
    Pannell House
    LS1 2TW 8 Queen Street
    Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0