RLP OLD CO LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামRLP OLD CO LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00408816
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    RLP OLD CO LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য উৎপাদন (বিস্তারিত নির্দিষ্ট নয়) (32990) / উৎপাদন

    RLP OLD CO LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    RLP OLD CO LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ROBERTSON'S - LEDBURY PRESERVES LIMITED২২ এপ্রি, ১৯৯৯২২ এপ্রি, ১৯৯৯
    LEDBURY PRESERVES LIMITED১১ অক্টো, ১৯৯৬১১ অক্টো, ১৯৯৬
    INCHBROOK PENSION TRUSTEES LIMITED২২ জানু, ১৯৯৬২২ জানু, ১৯৯৬
    HEINZEL (LONDON & VIENNA) LIMITED২৩ এপ্রি, ১৯৪৬২৩ এপ্রি, ১৯৪৬

    RLP OLD CO LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    RLP OLD CO LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ২৩ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Andrew John Mcdonald এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ মে, ২০১৮ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Duncan Neil Leggett-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ১১ নভে, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Emmett Mcevoy এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    5 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ অক্টো, ২০১২

    ০২ অক্টো, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed robertson's - ledbury preserves LIMITED\certificate issued on 11/06/12
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১১ জুন, ২০১২

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১১ জুন, ২০১২

    RES15
    change-of-name১১ জুন, ২০১২

    রেজোলিউশন দ্বারা নাম পরিবর্তন

    NM01

    পরিচালক হিসাবে Antony Smith এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Emmett Mcevoy-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Andrew Mcdonald-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Suzanne Wise এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    34 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Delete mem 07/10/2011
    RES13
    capital

    সিকিউরিটিজ বরাদ্দের রেজুলেশন

    RES10

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    কোম্পানির আর্টিকেলগুলিতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCC02

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ সেপ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ আগ, ২০১১ তারিখে Ms Suzanne Elizabeth Wise-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ আগ, ২০১১ তারিখে Mr Simon Nicholas Wilbraham-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    RLP OLD CO LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    সচিব
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    British125719290002
    LEGGETT, Duncan Neil
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomBritish194179970001
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Premier House
    Centrium Business Park
    AL1 2RE Griffiths Way, St. Albans
    Hertfordshire
    EnglandBritish125719290002
    BROWN, Philip Damian
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    সচিব
    154 Nine Mile Ride
    Finchampstead
    RG40 4JA Wokingham
    Berkshire
    British120200002
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    সচিব
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    HARTREY, Patrick Mark
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    সচিব
    30 Colham Road
    UB8 3WQ Hillingdon
    Middlesex
    British50340730004
    HINES, Christine Anne
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    সচিব
    33 Sandhills Road
    Barnt Green
    B45 8NP Birmingham
    British27217290001
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    British120645920001
    WATERS, Paul Christopher
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    সচিব
    Avenue Road
    CV37 6UW Stratford-Upon-Avon
    37
    Warwickshire
    United Kingdom
    British126327110002
    WILBRAHAM, Simon Nicholas
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    সচিব
    Queens Crescent
    AL4 9QG St. Albans
    19
    Hertfordshire
    United Kingdom
    British125719290002
    WOODMORE, Michael Brian
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    সচিব
    59 Terrington Hill
    SL7 2RE Marlow
    Buckinghamshire
    British37177620001
    ALLNER, Andrew James
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    পরিচালক
    9 The Crescent
    Barnes
    SW13 0NN London
    British73003300001
    BOYD, James Macleod
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    পরিচালক
    Wych Cottage
    Common Lane
    S42 7AN Cutthorpe
    Derbyshire
    British21379830001
    BURTON, Denise Patricia
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    পরিচালক
    55 Kingston Hill Place
    Kingston Hill
    KT2 7QY Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570002
    BURTON, Denise Patricia
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    পরিচালক
    42 Windmill Rise
    Kingston Hill
    KT2 7TU Kingston Upon Thames
    Surrey
    British47432570001
    CLARKE, Jonathan Michael Rushton
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    পরিচালক
    1 Newalls Rise
    RG10 8AY Wargrave
    Berkshire
    United KingdomBritish98818450001
    COOK, Bernard
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    পরিচালক
    Flat C 1 Benbow Court
    Hammersmith
    W6 0AT London
    British12836850001
    COURTNEY, Paul
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    9 Churchill Drive
    Newtown
    GL20 8EL Tewkesbury
    Gloucestershire
    United KingdomBritish222001800001
    CROSSLEY, Nigel
    HP9
    পরিচালক
    HP9
    EnglandBritish145901880001
    HARDY, John
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    পরিচালক
    18 Turnpike Avenue
    GL12 7SD Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    British49690000002
    HOLROYD, Dean
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    15 Clarence Square
    GL50 4JN Cheltenham
    Gloucestershire
    British64875220001
    HUNTER, Muir Ian
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Fairhaven Akeferry Road
    Westwoodside
    DN9 2DS Doncaster
    South Yorkshire
    British65861860001
    JOLLANS, Kenneth Richard
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Maple Heights
    Broad Street
    GL19 3BN Hartpury
    Gloucestershire
    EnglandBritish73630340002
    KELLY, Timothy Geoffrey
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    The Mansion House
    Abbotts Inn
    SP11 7AU Andover
    Hampshire
    EnglandBritish92817300001
    LAWSON, Robert
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    পরিচালক
    36 Exeter Road
    NW2 4SB London
    EnglandBritish99991140001
    LEWIS, David
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Pennyfield 9 Pitch Pond Close
    Knotty Green
    HP9 1XY Beaconsfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish69920630001
    LEWIS, John
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    পরিচালক
    Riseley Mill Cottage
    Risely Mill
    RG7 1XU Reading
    Berks
    British21379850001
    MANN, Peter Charles
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    পরিচালক
    2 Orchard View
    Falfield
    GL12 8DG Wotton Under Edge
    Gloucestershire
    EnglandBritish48283310001
    MARCHANT, Richard Norman
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    পরিচালক
    60 The Mount
    Curdworth
    B76 9HR Sutton Coldfield
    West Midlands
    British26880001
    MCDONALD, Andrew John
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    EnglandBritish164670820001
    MCEVOY, Emmett
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Centrium Business Park
    Griffiths Way
    AL1 2RE St Albans
    Premier House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomIrish168590540001
    MCMAHON, Ian Reid
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    The Gate House
    Burfield Road
    SL4 2LH Old Windsor
    Berkshire
    British84644240002
    MILLER, Roger Keith
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Hatters Barn
    Stockwell Lane Little Meadle
    HP17 9UG Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish120645920001
    MURPHY, Thomas Jerome Peter
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    9 One Tree Lane
    HP9 2BU Beaconsfield
    Buckinghamshire
    British76945730001
    PANTER, Alan James, Mr.
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    পরিচালক
    14 Thornhill Bridge Wharf
    N1 0RU London
    British114414690002

    RLP OLD CO LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ জুল, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ আগ, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Jpmorgan Chase Bank as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৬ আগ, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture between rhm group one limited, the chargors and the chargees (all as defined)
    তৈরি করা হয়েছে ১১ সেপ, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ সেপ, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor to the chargee (or any of them) under the finance documents (or any of them), together with all costs charges and expenses incurred by the lenders (or any of them) in connection with the protection, preservation or enforcement of it's respective rights under the finance documents for which any obligor is liable under the finance documents except any obligation, which, if it were so included, would result in the debenture contravening 151 of the companies act 1985, section 60 of the republic of ireland act 1963 or companies (northern ireland) order 1996.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Guaranty Trust Company of New York (As "Security Agent")
    ব্যবসায়
    • ২৩ সেপ, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জুল, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £54,000 and all other moneys due or to become due from the company to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings at aber park flint clwyd.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Delyn Borough Council
    ব্যবসায়
    • ১৪ মে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২০ জুল, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৮৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ জানু, ১৯৮৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the north side of bentley moor lane, adwick le street, doncaster. South yorkshire title no:- syk 72481.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৯ জানু, ১৯৮৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৭৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ অক্টো, ১৯৭৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property under land title nos: syk 9008: syk 5509 syk 21732 in the county of south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২১ অক্টো, ১৯৭৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১১ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৭৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ মে, ১৯৭৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets present and future including book debts & goodwill uncalled capital. Fixed and floating charges see doc for further details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ মে, ১৯৭৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ মে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৭৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৭৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land & buildings at bentley moor lane, carcroft, doncaster, south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ অক্টো, ১৯৭৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge on contract for sale
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ অক্টো, ১৯৭৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ অক্টো, ১৯৭৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Company's interest in a contract for sale dated 26.3.74 between adwick le street, urban district council and the company relating to land having a frontage to bentley moor lane, carcroft near doncaster, south yorkshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৪ অক্টো, ১৯৭৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২১ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0