W T SEYMOUR LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামW T SEYMOUR LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00420431
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    W T SEYMOUR LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (9999) /

    W T SEYMOUR LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    W T SEYMOUR LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    W.T.SEYMOUR(STOCKTON)LIMITED২৮ সেপ, ১৯৪৬২৮ সেপ, ১৯৪৬

    W T SEYMOUR LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়২৮ ফেব, ২০১১
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ নভে, ২০১১
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৫ ফেব, ২০১০

    W T SEYMOUR LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১৩ আগ, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৭ আগ, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    W T SEYMOUR LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    W T SEYMOUR LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    4 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    পরিচালক হিসাবে Simon Terence Douglas-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Mr Simon Terence Douglas-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Philip Bowcock এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ আগ, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৮ আগ, ২০১১

    ১৮ আগ, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 4,000
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Mr Philip Hedley Bowcock-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    সচিব হিসাবে Mrs Jayne Fearn-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    পরিচালক হিসাবে Timothy O'gorman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Timothy O'gorman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৫ ফেব, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Andrew Marks এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Luminar Leisure Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP02

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৬ ফেব, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ ফেব, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ ফেব, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ০২ মার্চ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    W T SEYMOUR LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    সচিব
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158809780001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    পরিচালক
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    কর্পোরেট পরিচালক
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    পরিচয়পত্রের ধরনইউকে লিমিটেড কোম্পানি
    নিবন্ধন নম্বর03802937
    152133330001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    সচিব
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    COLLEDGE, David Ingram
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    সচিব
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    British9330890001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    সচিব
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    সচিব
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    সচিব
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    সচিব
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    সচিব
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    পরিচালক
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    পরিচালক
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    পরিচালক
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    পরিচালক
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    পরিচালক
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    COLLEDGE, David Ingram
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    পরিচালক
    14 Ebor Street
    BB10 1ER Burnley
    Lancashire
    United KingdomBritish9330890001
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    পরিচালক
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    পরিচালক
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MCCULLOCH, John James
    21 Manor Place
    Fairfield
    TS19 7HF Stockton On Tees
    Cleveland
    পরিচালক
    21 Manor Place
    Fairfield
    TS19 7HF Stockton On Tees
    Cleveland
    EnglandBritish31008980001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    পরিচালক
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    পরিচালক
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WELSH, James Michael
    Thackwoods The Mains
    Giggleswick
    BD24 0AX Settle
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Thackwoods The Mains
    Giggleswick
    BD24 0AX Settle
    North Yorkshire
    British9330900002
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    HANOVER THREE LIMITED
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    62089160004

    W T SEYMOUR LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ফেব, ১৯৯৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৩ ফেব, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ অক্টো, ১৯৯০
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due from truscott engineering limited to the governor and company of the bank of scotland
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৪ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ ডিসে, ১৯৮৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due or to become due from fife indmar PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The balances at credit of any accounts. Held by the governor and company of the bank of scotland.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ আগ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৮২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from T.S. forster & sons limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৩ সেপ, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ১৯৮২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ এপ্রি, ১৯৮২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from park naval engineering limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit on any account on accounts of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৮ এপ্রি, ১৯৮২একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of offset
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ মার্চ, ১৯৮১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from robt. Balbirnie & company limited and/or henry nuttall (rochdale) limited to the chargee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৮ মার্চ, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Letter of set off
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ১৯৭৯
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    Securing all monies due or to become due from W.l buyers & co lef bishop LTD. Fife forge co LTD fife forster LTD crompton & harrison LTD. Thompson brothers to the chargee.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All sums which are now or which may at any time hereafter be at the credit of any account or accounts of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১১ এপ্রি, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0