GORSEY SIX LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামGORSEY SIX LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00421037
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    GORSEY SIX LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (5212) /

    GORSEY SIX LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    GORSEY SIX LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ECLIPSE BLINDS LIMITED১৪ জুল, ১৯৯৪১৪ জুল, ১৯৯৪
    ASHLEY GROUP PLC০৯ সেপ, ১৯৮৮০৯ সেপ, ১৯৮৮
    ASHLEY INDUSTRIAL TRUST P L C৩১ ডিসে, ১৯৭৯৩১ ডিসে, ১৯৭৯
    THAMES PLYWOOD MANUFACTURERS LIMITED০৭ অক্টো, ১৯৪৬০৭ অক্টো, ১৯৪৬

    GORSEY SIX LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৫

    GORSEY SIX LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    3 পৃষ্ঠা4.71

    ০৭ জুন, ২০১০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০৭ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ০৭ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন

    LRESSP

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    2 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    13 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363s

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০২ পর্যন্ত তৈরি

    15 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০১ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed eclipse blinds LIMITED\certificate issued on 01/10/02
    2 পৃষ্ঠাCERTNM

    GORSEY SIX LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    DUGGAN, Geoffrey Michael
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    সচিব
    Westdale 19 Cosby Road
    Countesthorpe
    LE8 5PD Leicester
    Leicestershire
    British9962100001
    BREWER, Anthony John
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    পরিচালক
    House
    Blackwell Road
    B45 8BT Barnt Green
    The Manor
    Worcestershire
    EnglandBritish28937370012
    WILSON, Stephen Graham
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Clover House
    Old Warwick Road, Lapworth
    B94 6LD Solihull
    West Midlands
    United KingdomBritish23638320002
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    সচিব
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    British462890002
    GILLIES, Malcolm John
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    সচিব
    49 Arisdale Crescent
    Newton Mearns
    G77 6HE Glasgow
    Strathclyde
    British1381960001
    STABLES, Jane Margaret
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    সচিব
    23 Somerset Road
    Walthamstow
    E17 8QN London
    British41059230001
    ANDERSON, Thomas James
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    পরিচালক
    Spinners Ingle Kennell Hill
    Sharnbrook
    MK44 1PS Bedford
    Bedfordshire
    British57834870001
    BLACK, James Edward
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    পরিচালক
    1 Oakwood Drive
    Newton Mearns
    G77 5PU Glasgow
    ScotlandUnited Kingdom35816690001
    BROWN, John Kenneth
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    পরিচালক
    40 Beech Avenue
    G77 5PP Glasgow
    Renfrewshire
    ScotlandBritish462890002
    BUTLER, Anthony Bertram
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    পরিচালক
    222 The Colonnades
    W2 6AS London
    British18439630001
    GROSSART, Hamish Mcleod
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    পরিচালক
    West Court
    Newton
    EH52 6QH Broxburn
    West Lothian
    British37900003
    IRVINE, John Christopher
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    পরিচালক
    2 Abbots Road
    FK3 8HX Grangemouth
    Stirlingshire
    British38442060001
    JOHN, Christopher
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    পরিচালক
    6 Lavender Croft
    61 Wymondley Road
    SG4 9PT Hitchin
    Hertfordshire
    British71834620003
    KIRKHAM, Ian
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    পরিচালক
    106 Windingbrook Lane
    Collingtree Park
    NN4 0XN Northampton
    Northamptonshire
    British34964530002
    LANGLANDS, John Thomson
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    পরিচালক
    112 Braid Road
    EH10 6AS Edinburgh
    ScotlandBritish722090001
    LARMAN, Trevor George
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Thurlwood House Loudwater Lane
    Croxley Green
    WD3 3JD Rickmansworth
    Hertfordshire
    England/HertfordshireBritish10878930001
    MACDONALD, William
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    পরিচালক
    Netherdene
    G76 0JF Eaglesham
    British539830001
    MAYDON, Peter John
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    White Cottage
    North Heath Chieveley
    RG20 8UA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish5988360001
    MCNEIL, Robert
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    পরিচালক
    Kincardine Castle
    PH3 1PG Auchterarder
    Perthshire
    ScotlandBritish31415950001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    MONSERRAT MESANZA, Miguel
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    পরিচালক
    Paso Constitucion 18/20
    Zaragoza
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945210001
    ORTON, Anthony Stanley
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    পরিচালক
    Greville Cottage
    5a Greville Place
    NW6 5JP London
    British Canadian12605660001
    RODGER, James Roy
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    পরিচালক
    9 Old School
    Bridge Of Weir Delivery Office
    PA11 3LJ Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    British48535040002
    THOMAS, John Alan
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Garden House
    Pipewell
    NN14 1QZ Kettering
    Northamptonshire
    British802790001
    TIPPER, Christopher Stuart
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    পরিচালক
    1 Red Lion Lane
    Newbold Verdon
    LE9 9LS Leicester
    British46918370001
    URCELAY ALONSO, Antonio
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    পরিচালক
    Cerro Del Castanar 62
    Chalet No 3 Madrid 28034
    FOREIGN
    Spain
    Spanish9945230001
    WHITE, James
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Moat House
    Annables Lane Kingsbourne Green
    AL5 Harpenden
    Hertfordshire
    British28464050001

    GORSEY SIX LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and assets.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ ফেব, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ নভে, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ ডিসে, ১৯৯৫
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge all the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement dated 27 april 1989 as amended by a minute of variation dated of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (1) 46,906 ordinary shares of £1 each in the capital of vertika international limited and 250,000 ordinary shares of £1 each in the capital of british plywood manufacturers limited (2) the derivative assets and (3) all dividends, interest and other income deriving from the shares or any derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • James Mcneil
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The chargor as beneficial owner as continuing security for the payment of the secured obligations, has charged in favour of the creditor by way of floating charge. (A) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accuring on or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime attaching to, or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • James Mcneil
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to an agreement of 27 april 1989 as amrnded by a minute of variation of 14 may 1991 and supplemented by a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All dividends interest and other income at any time hereafter deriving from the shares or any derivative assets or deriving from any investment of any such dividends interest or other income. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Robert Mcneil
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    A deed of charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জুল, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of an agreement dated 27 april 1989 as amended or supplemented by inter alia a minute of variation dated 14 may 1991 and a minute of agreement dated 30 june 1994 and/or this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge (a) the securities (b) where the context so admits, all moneys and assets whatsoever at any time accruing on, or payable or receivable in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at anytime ataching to or exerciseable in respect of any of the securities. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Robert Mcneil
    ব্যবসায়
    • ১৮ জুল, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of or pursuant to the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of floating charge (a) the securities; and (b) all moneys and assets in respect of any of the securities and all voting and other rights and powers of any kind at any time (for full details of charge see form 395).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Secured Parties (As Defined).
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Assignment agreement
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৮৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88 and this assignment
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's right, title and interest (see form 395 for full details, ref : M50).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ সেপ, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility agreement dated 25/8/88, assignment agreement dated 31/8/88 and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395 for full details ref: M52). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Algemere Bank Nederland N.V.
    ব্যবসায়
    • ০৫ সেপ, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১২ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    GORSEY SIX LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ১৭ নভে, ২০১০ভেঙে গেছে
    ০৮ ডিসে, ২০০৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    অভ্যাসকারী
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    অভ্যাসকারী
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0