HENLYS GROUP PLC

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHENLYS GROUP PLC
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপাবলিক লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00435086
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HENLYS GROUP PLC এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7415) /

    HENLYS GROUP PLC কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HENLYS GROUP PLC এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    PLAXTON GROUP PLC২৩ মে, ১৯৮৯২৩ মে, ১৯৮৯
    PLAXTON PLC০২ মার্চ, ১৯৮৮০২ মার্চ, ১৯৮৮
    PLAXTONS (G B) PUBLIC LIMITED COMPANY৩১ ডিসে, ১৯৮১৩১ ডিসে, ১৯৮১
    PLAXTON'S (SCARBOROUGH) LIMITED ১৩ মে, ১৯৪৭১৩ মে, ১৯৪৭

    HENLYS GROUP PLC এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩১ মার্চ, ২০০৫
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩১ অক্টো, ২০০৫
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৩

    HENLYS GROUP PLC এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে১২ মে, ২০১৭
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে২৬ মে, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    HENLYS GROUP PLC এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    HENLYS GROUP PLC এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার - পূর্বে ঋণদাতাদের স্বেচ্ছায় দ্রবীভূতকরণে

    3 পৃষ্ঠাREST-CVL

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    14 পৃষ্ঠাLIQ14

    ২৩ জুল, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৯ জুল, ২০১৪ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 10 Furnival Street London EC4A 1AB থেকে 2Nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EUপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৩ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    ২৩ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৩ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    ২৩ জুল, ২০১২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠা4.68

    HENLYS GROUP PLC এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    সচিব
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    British22018030002
    JAMES, David Noel
    Vigilant House 120 Wilton Road
    SW1V 1JZ London
    পরিচালক
    Vigilant House 120 Wilton Road
    SW1V 1JZ London
    British41668080003
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    পরিচালক
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritish22018030002
    DAWES, Peter
    160 St Neots Road
    Eaton Ford St Neots
    PE19 7AD Huntingdon
    Cambridgeshire
    সচিব
    160 St Neots Road
    Eaton Ford St Neots
    PE19 7AD Huntingdon
    Cambridgeshire
    British45344670003
    RILEY, Leslie Ewart
    71 Bulstrode Court
    SL9 7RU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    সচিব
    71 Bulstrode Court
    SL9 7RU Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British8322010002
    ASKEW, Norman Brian Montague
    Offerton House
    Offerton
    S32 1BP Hathersage
    Derbyshire
    পরিচালক
    Offerton House
    Offerton
    S32 1BP Hathersage
    Derbyshire
    British69246420001
    BERESFORD, Kenneth Neil
    Hoggarth Hill House 42 Stone Quarry Road
    Burniston
    YO13 0DF Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Hoggarth Hill House 42 Stone Quarry Road
    Burniston
    YO13 0DF Scarborough
    North Yorkshire
    British26666850001
    BUST, Jeffry Dwight
    9705 Redamar Drive
    Hagerstown
    Maryland Md 21740
    Usa
    পরিচালক
    9705 Redamar Drive
    Hagerstown
    Maryland Md 21740
    Usa
    Us Citizen94375860001
    CHIVERS, Brian Arthur Calne
    Melloncroft 25 Cambridge Avenue
    KT3 4LD New Malden
    Surrey
    পরিচালক
    Melloncroft 25 Cambridge Avenue
    KT3 4LD New Malden
    Surrey
    British6141460001
    COWAN, Christopher Ian
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    পরিচালক
    Ballards
    Ballards Lane
    RH8 0SN Limpsfield
    Surrey
    British54679190001
    DOHERTY, Michael Eunan
    Nower Hayes Tyrells Wood
    KT22 8QW Leatherhead
    Surrey
    পরিচালক
    Nower Hayes Tyrells Wood
    KT22 8QW Leatherhead
    Surrey
    British11458190001
    EDWARDS, Derek
    Kings Lawn 7 Sandy Lane Road
    Charlton Kings
    GL53 9DB Cheltenham
    পরিচালক
    Kings Lawn 7 Sandy Lane Road
    Charlton Kings
    GL53 9DB Cheltenham
    British33892480001
    GILLESPIE, Graham Richard William
    The Old Rectory
    Welford Road, Long Marston
    CV37 8RH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Welford Road, Long Marston
    CV37 8RH Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    UkBritish161312160001
    HAWKSWORTH, Roger William
    Greenwood
    Mile Path
    GU22 0DY Woking
    Surrey
    পরিচালক
    Greenwood
    Mile Path
    GU22 0DY Woking
    Surrey
    EnglandBritish69630790001
    MADDOX, Richard Earnest
    102 Bonnie Brae Drive
    FOREIGN Perry
    Georgia 31069
    Usa
    পরিচালক
    102 Bonnie Brae Drive
    FOREIGN Perry
    Georgia 31069
    Usa
    American69630950001
    OST, Michael Stuart
    2 Muirfield House
    Whinshill Court, Cross Road
    SL5 9RU Sunningdale
    Berkshire
    পরিচালক
    2 Muirfield House
    Whinshill Court, Cross Road
    SL5 9RU Sunningdale
    Berkshire
    British16322990002
    PARFITT, Christopher Robin
    2 Arnolds Close
    Padbury
    MK18 2BG Buckingham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    2 Arnolds Close
    Padbury
    MK18 2BG Buckingham
    Buckinghamshire
    British1286410002
    TUKE, John
    Cedar Cottage Tanyard Lane
    Chelwood Gate
    RH17 7LJ Haywards Heath
    West Sussex
    পরিচালক
    Cedar Cottage Tanyard Lane
    Chelwood Gate
    RH17 7LJ Haywards Heath
    West Sussex
    British56752680001
    WATSON, James Kenneth
    Benton Potts
    Hawbridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Benton Potts
    Hawbridge Common
    HP5 2UH Chesham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish4921300002
    WELSH, Thomas Allan
    Capps Meadow
    Capps Lane
    HP5 2TX Chartridge
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Capps Meadow
    Capps Lane
    HP5 2TX Chartridge
    Buckinghamshire
    British80666890001
    WOOD, Robert Wilson
    Cluaran 12
    The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Cluaran 12
    The Ridgeway
    WD7 8PR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritish33261800003
    WOODWARK, Christopher John Stuart
    Holm Beech
    Wood End Close One Pin Lane
    SL2 3RF Farnham Common
    Bucks
    পরিচালক
    Holm Beech
    Wood End Close One Pin Lane
    SL2 3RF Farnham Common
    Bucks
    EnglandBritish29679520001

    HENLYS GROUP PLC এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Security assignment
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under each finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All rights under the underwriting agreement and all rights to the proceeds of the rights issue. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland Plcas Agent for the Banks and Financial Institutions Part to the Credit Agreement (The Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৫ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ সেপ, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Bulk deposit mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies deposited from time to time by the company with ford credit PLC pursuant to the terms of a sale return agreement between ford credit PLC, ford motor company limited and henlys group PLC.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Ford Credit PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৫ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯২
    অর্জিত হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-46 croydon road and 1 and 3 doods road reigate surrey. T/n-SY425327. (For full details of property charged see form 395 and contd sheets).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Charterhouse Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯২
    অর্জিত হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-land being 46 croydon road and 1 and 3 doods road reigate surrey. T/n-SY425327. (For full details of charge see form 395 and contd sheets).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref M605C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Charterhouse Bank Limited
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৯২
    অর্জিত হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ জানু, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H-46 croydon road and 1 and 3 doods road reigate surrey. T/n-SY425327 (for full details of charge see form 395 and contd sheets).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ জানু, ১৯৯৩অধিগ্রহণের নিবন্ধন (400)
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৯২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুল, ১৯৯২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    See form 395 ref M597C. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুল, ১৯৯২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ১৯৯৪বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ১৭ এপ্রি, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Standard
    তৈরি করা হয়েছে ১৭ মার্চ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ এপ্রি, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mnute of agreement dated 11 jan and 8 feb 1989
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    An area of ground near whistleberry road, hamilton, country of lanark extending 1.302 acre.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hamilton District Council
    ব্যবসায়
    • ০৬ এপ্রি, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or dc properties limited. To the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Plaxton coach repair works, widbury hill, ware hertfordshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Der Norske Credit Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১১ অক্টো, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ অক্টো, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or become due from the company and/or dnc properties limited. To the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and premises at 12 invicible road farnnborough hampshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Den Norske Credit Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ অক্টো, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge of cash deposit
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a counter indemnity dated 30.3.87
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Deposit of £2,058,000 on account number 00236158 with the bank including all interest accrued or accruing in the future on the deposit and all increases in the amount of the deposit.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ এপ্রি, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন

    HENLYS GROUP PLC এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ২৪ জানু, ২০০৬ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ২৫ নভে, ২০২১ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Geoffrey Paul Rowley
    Vantis
    Po Box 2653
    W1A 3RT 66 Wigmore Street
    London
    অভ্যাসকারী
    Vantis
    Po Box 2653
    W1A 3RT 66 Wigmore Street
    London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0