MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামMORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00492179
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    32-38 Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জানু, ২০১৬

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ০৪ মে, ২০১৮ তারিখে সচিব হিসাবে Amanda Claire Fogg এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ১৯ অক্টো, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    6 পৃষ্ঠাCS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    ১৭ মে, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 46 Colebrooke Row London N1 8AF থেকে 32-38 Scrutton Street London EC2A 4RQপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ০৮ এপ্রি, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Tim Morgan Davies এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ অক্টো, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ নভে, ২০১৫

    ০৯ নভে, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 262,500
    SH01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Teresa Tideman এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Tim Davies-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Shaun Simon Wills-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ২৩ এপ্রি, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Joanne Clare Bennett এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৫ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ অক্টো, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৪ অক্টো, ২০১৪

    ২৪ অক্টো, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 262,500
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Joanne Clare Bennett-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Ian Johnson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৯ অক্টো, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৫ নভে, ২০১৩

    ১৫ নভে, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 262,500
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৬ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    সচিব হিসাবে Mrs Amanda Claire Fogg-এর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে Philip Watt এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Ms Teresa Tideman-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Sarah Morris এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    4 পৃষ্ঠাAA

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    WILLS, Shaun Simon
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    পরিচালক
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    EnglandBritishChief Financial Officer185717270001
    ALSOP, Patricia Mary
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    সচিব
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    British501920002
    BRYAN, Paul Anthony Edward Peter
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    সচিব
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    BritishCompany Secretary25267050001
    CASH, Daphne Valerie
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    সচিব
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary59646330005
    FABIAN, Andrew Mark
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    সচিব
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    BritishAccountant61022990001
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    সচিব
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    British68232410001
    FOGG, Amanda Claire
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    সচিব
    Scrutton Street
    EC2A 4RQ London
    32-38
    England
    181382590001
    HAUGHTON, Adrian Paul
    Brambles The Old Pitch
    Tirley
    GL19 4ET Gloucester
    Gloucestershire
    সচিব
    Brambles The Old Pitch
    Tirley
    GL19 4ET Gloucester
    Gloucestershire
    BritishFinance Dir50089840002
    HEARD, Nicholas James
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    সচিব
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    BritishCompany Secretary132971860002
    JOHNSON, Ian Paul
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    সচিব
    Tugwood
    Kings Lane
    SL6 9TZ Cookham Dean
    Berkshire
    British76187110001
    KNIGHT, David Harper
    Lower Westfield House Westfield Lane
    Draycott
    BS27 3TN Cheddar
    Somerset
    সচিব
    Lower Westfield House Westfield Lane
    Draycott
    BS27 3TN Cheddar
    Somerset
    British67491150001
    WARBURTON, Jenny
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    সচিব
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    156850590001
    WATT, Philip Graham
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    সচিব
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    164008630001
    ALLEN, Paul Christopher
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomIrishExecutive Director185112730001
    ALSOP, Patricia Mary
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    পরিচালক
    32 Nicosia Road
    SW18 3RN London
    BritishSolicitor501920002
    BENNETT, Joanne Clare
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishChief Finance Officer184759270001
    BRYAN, Paul Anthony Edward Peter
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    পরিচালক
    37 Chantry Avenue
    Hartley
    DA3 8DD Longfield
    Kent
    BritishCompany Secretary25267050001
    CASH, Daphne Valerie
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    পরিচালক
    9 Marquis Close
    AL5 5QZ Harpenden
    Hertfordshire
    BritishChartered Secretary59646330005
    CHADWICK, Allan
    32 Chamberlain Way
    HA5 2AX Pinner
    Middlesex
    পরিচালক
    32 Chamberlain Way
    HA5 2AX Pinner
    Middlesex
    EnglandBritishChartered Accountant580310001
    COHEN, Elsie
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    BritishLadies Underwear Manufacturer24180670001
    COHEN, Morris
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    34 Oak Lodge Close
    HA7 4QB Stanmore
    Middlesex
    BritishLadies Underwear Manufacturer24180660001
    COHEN, Stanley Michael
    Kingswood House
    15 Linksway
    Northwood
    Middlesex
    পরিচালক
    Kingswood House
    15 Linksway
    Northwood
    Middlesex
    BritishLadies Underwear Manufacturer1752100002
    COURTS, Sarah Susan
    Brockenhirst 2 Brockley Hill
    HA7 4LS Stanmore
    Middlesex
    পরিচালক
    Brockenhirst 2 Brockley Hill
    HA7 4LS Stanmore
    Middlesex
    BritishDesigner23866720002
    DAVIES, Tim Morgan
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomBritishRetail Director197113400001
    FABIAN, Andrew Mark
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    পরিচালক
    139 Woodwarde Road
    SE22 8UP London
    United KingdomBritishAccountant61022990001
    FINCH, Russell
    9 Park Place
    W5 5NQ London
    পরিচালক
    9 Park Place
    W5 5NQ London
    BritishAccountant70159860001
    FINLAY, David Michael Gordon
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    পরিচালক
    2 Rogerstone Grange Cottages
    St. Arvans
    NP16 6EX Chepstow
    Gwent
    BritishChartered Accountant68232410001
    GARBETT-DAVIES, John Nigel
    21 Stonechat Close
    Rest Bay
    CF36 3QF Porthcawl
    Glam
    পরিচালক
    21 Stonechat Close
    Rest Bay
    CF36 3QF Porthcawl
    Glam
    BritishProduction Executive24149340001
    GERETY, James Anthony
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    পরিচালক
    22 Leadale Avenue
    Chingford
    E4 8AT London
    EnglandBritishDirector35957840001
    GILBERT, Arthur Sheldon
    High Windows 6 Alderbrook
    Cyncoed
    CF2 6QD Cardiff
    South Glamorgan
    পরিচালক
    High Windows 6 Alderbrook
    Cyncoed
    CF2 6QD Cardiff
    South Glamorgan
    BritishConsultant24180730001
    JOHNSON, Ian Paul
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    United KingdomBritishFinance Director76187110001
    KEMPSTER, Jonathan
    144 Finchampstead Road
    RG41 2NU Wokingham
    Berkshire
    পরিচালক
    144 Finchampstead Road
    RG41 2NU Wokingham
    Berkshire
    BritishAccountant73764250001
    LONG, Alan
    18 Cae Garw
    CF4 9EX Thornhill
    Cardiff
    পরিচালক
    18 Cae Garw
    CF4 9EX Thornhill
    Cardiff
    BritishCommercial Executive24180740002
    MAWER, Lorraine Olivia
    The Cedars
    Little Billington
    LU7 9BS Bedfordshire
    পরিচালক
    The Cedars
    Little Billington
    LU7 9BS Bedfordshire
    United KingdomBritishMarketing Director29819500001
    MORRIS, Sarah
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    পরিচালক
    46 Colebrooke Row
    London
    N1 8AF
    EnglandBritishDirector174804590001

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    William Baird Limited
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশScotland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানRegister Of Companies For England & Wales
    নিবন্ধন নম্বরSc021118
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।

    MORRIS COHEN (UNDERWEAR) LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a units 1 to 12 and 20 to 24 chesham industrial estate bury lancashire t/no.SM340341 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a unit 1 cyfartha industrial estate merthyr tydfil mid glam and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ আগ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ আগ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1. f/h land unit 19 ynyscedwyn industrial estate tongwynlais brecknock powys t/no.WA670042. 2. f/h land 2 & 3 st davids industrial estate pengam islwyn gwent t/no.WA353710. 3. f/h land & buildings west side of pengam road aberbargoed islwyn gwent. T/no.WA180255. 4. f/h land, factory premises church street pontadawe lliw valley west glamorgan.t/no.WA226139.5.f/h land & buildings north west side of quarr road pontardawe lliw valley west glam. T/no.WA390005. 6. f/h land north of purcell avenue port talbot west glam.t/no.WA183881. 7.F/h land north west side of purcell avenue aberavon port talbot west glamorgan t/no.WA109757. 8. f/h north west side of purcell avenue port talbot west glamorgan t/no.WA132115. 9.F/h land & buildings north side of A48 at pyle ogwr mid glam t/no.WA398879. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ আগ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    1 goat mill road merthyr tydfil mid glamorgan.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H unit 2 cyfartha industrial estate merthyr tydfil mid glamorgan.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge and set off
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of account no.011675310100 With the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Letter of charge and set off
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ জুল, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to account no.011675310000 With the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Credit Lyonnais
    ব্যবসায়
    • ০২ জুল, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ জানু, ২০১০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৮ আগ, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Factory premises at church street pontardawe lliw valley west glamorgan t/no wa 226139 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north west side of purcell avenue port talbot afon west glamorgan t/no wa 132115 and/or the proceeds of the sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the north west side of purcell avenue aberavon port talbot west glamorgan t/no wa 109757 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ জানু, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১২ জানু, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land lying to the north of purcell avenue, port talbot, west glamorgan, t/no wa 183881 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১২ জানু, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding the 50% share of S.M.cohen in the proceeds of sale of the mortgaged property under the terms of the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H property k/a all that plot of land comprising 1.29 acres or thereabouts together with all buildings and structures erected thereon and for the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৩ ডিসে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৮৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ ফেব, ১৯৮৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the south side of salford street, bury, greater manchester, tn gm 340341 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ ফেব, ১৯৮৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ নভে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ নভে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The leasehold property known as unit a weldon industrial estate corby northamptonshire and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ নভে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মে, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings on the west side of pengam road, aberbargoed, gwent title no na 180255 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0