SWISH PRODUCTS

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামSWISH PRODUCTS
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট আনলিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00505296
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    SWISH PRODUCTS এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    SWISH PRODUCTS কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    123 Deansgate
    Manchester
    M3 2BU Lancashire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    SWISH PRODUCTS এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০০৪

    SWISH PRODUCTS এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    5 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    legacy

    1 পৃষ্ঠা652a

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    সীমিত থেকে অসীম পুনঃ নিবন্ধনের শংসাপত্র

    1 পৃষ্ঠাCERT3

    পুনঃনিবন্ধন সমিতির এবং সংবিধির নথি

    14 পৃষ্ঠাMAR

    legacy

    1 পৃষ্ঠা49(8)(b)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা49(8)(a)

    legacy

    1 পৃষ্ঠা49(1)

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    পুনঃ নিবন্ধনের রেজুলেশন

    RES02

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৩ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    7 পৃষ্ঠা363s

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০২ পর্যন্ত তৈরি

    10 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    2 পৃষ্ঠা288a

    অডিটরের পদত্যাগ

    1 পৃষ্ঠাAUD

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০১ পর্যন্ত তৈরি

    9 পৃষ্ঠাAA

    SWISH PRODUCTS এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    HOWLETT, Michael John
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    সচিব
    123 Deansgate
    M3 2BU Manchester
    BritishSolicitor67433110003
    MARTIN, Douglas
    40 N Wise
    ILLINOIS Freeport
    Illinois 61032
    United States
    পরিচালক
    40 N Wise
    ILLINOIS Freeport
    Illinois 61032
    United States
    AmericanVice President Tax86525080001
    MATSCHULLAT, Dale Lewis
    1410 Geneva Club
    FOREIGN Lake Geneva
    Wisconsin Wi 53147
    United States
    পরিচালক
    1410 Geneva Club
    FOREIGN Lake Geneva
    Wisconsin Wi 53147
    United States
    AmericanCompany Director81870280001
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    সচিব
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    PARSONS, Graham John
    Derwent Ridge
    Bullhurst Lane Weston Underwood
    DE6 4PA Ashbourne
    Derbyshire
    সচিব
    Derwent Ridge
    Bullhurst Lane Weston Underwood
    DE6 4PA Ashbourne
    Derbyshire
    British33400140001
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    সচিব
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    TEMPELAAR-LIETZ, Johannes Wilhelm
    Kastanjedreef 26
    BELGIUM Overijse
    3090
    Belgium
    সচিব
    Kastanjedreef 26
    BELGIUM Overijse
    3090
    Belgium
    American58636460002
    BENTLEY, Paul Arthur
    55 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    পরিচালক
    55 Meadway
    Southgate
    N14 6NJ London
    EnglandBritishCompany Director71971440001
    DAVENPORT, Clarence Russel
    264 Park Crest Drive
    61032 Freeport
    Illinois
    Usa
    পরিচালক
    264 Park Crest Drive
    61032 Freeport
    Illinois
    Usa
    AmericanDirector42999920001
    DAVIES, Michael Thomas
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    পরিচালক
    11 The Rills
    LE10 1NA Hinckley
    Leicestershire
    BritishManager50770000001
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    পরিচালক
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant56562210001
    EVANS, Jonathan Denvir
    91 Back Lane
    Whittington
    WS14 9SA Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    91 Back Lane
    Whittington
    WS14 9SA Lichfield
    Staffordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant45506810001
    FRIEND, Nicholas
    Stocking Hill
    Mere Green
    WR9 7DZ Hanbury
    Worcs
    পরিচালক
    Stocking Hill
    Mere Green
    WR9 7DZ Hanbury
    Worcs
    BritishSales & Marketing Director121305220001
    GODDARD, David Peter
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    পরিচালক
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritishManaging Director8828350002
    GRIES, Brett E
    26-9 Wymwood Court
    Lanark Illinois 61046
    FOREIGN Usa
    পরিচালক
    26-9 Wymwood Court
    Lanark Illinois 61046
    FOREIGN Usa
    AmericanDirector58120840001
    HANRAHAN, Shaun Patrick
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    পরিচালক
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    BritishCommercial Director49298590002
    HARDING, Ian
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    পরিচালক
    Jasmine Cottage
    Eglinton Road Tilford
    GU10 2DH Farnham
    Surrey
    EnglandBritishChartered Accountant35278190002
    HAYWOOD, Timothy Paul
    32 Dunley Road
    DY13 0AX Stourport On Severn
    Worcestershire
    পরিচালক
    32 Dunley Road
    DY13 0AX Stourport On Severn
    Worcestershire
    BritishManager62962370001
    HORNE, Andrea Lynn
    810 Livingston Lane
    IL 60010 Barrington
    Il 60010 Iillinois
    Usa
    পরিচালক
    810 Livingston Lane
    IL 60010 Barrington
    Il 60010 Iillinois
    Usa
    AmericanAttorney81870580001
    HUDSON, Terence Nigel
    85 Meadow Drive
    Prestbury
    SK10 4EY Macclesfield
    Cheshire
    পরিচালক
    85 Meadow Drive
    Prestbury
    SK10 4EY Macclesfield
    Cheshire
    BritishManaging Director27376550001
    JACKMAN, Peter Frederick
    78 The Moors
    OX5 2AG Kidlington
    Oxfordshire
    পরিচালক
    78 The Moors
    OX5 2AG Kidlington
    Oxfordshire
    BritishManaging Director49464170001
    LLOYD, David Richard
    10 Park House Drive
    ST15 8QR Stone
    Staffordshire
    পরিচালক
    10 Park House Drive
    ST15 8QR Stone
    Staffordshire
    United KingdomBritishFinancial Director27376560001
    MARTIN, Peter J
    Avenue Des Pelerins 19
    Lasne
    1380
    Belgium
    পরিচালক
    Avenue Des Pelerins 19
    Lasne
    1380
    Belgium
    AmericanDirector57246900002
    MATSCHULLAT, Dale Lewis
    1410 Geneva Club
    FOREIGN Lake Geneva
    Wisconsin Wi 53147
    United States
    পরিচালক
    1410 Geneva Club
    FOREIGN Lake Geneva
    Wisconsin Wi 53147
    United States
    AmericanDirector81870280001
    MOULDER, Robert Arnold
    1591 Warwick Road
    B93 9LF Knowle
    West Midlands
    পরিচালক
    1591 Warwick Road
    B93 9LF Knowle
    West Midlands
    BritishManaging Director82513400001
    PARSONS, John Philip
    Poplars Farm Cottage
    Walsall Road, Springhill
    WS14 0BY Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    Poplars Farm Cottage
    Walsall Road, Springhill
    WS14 0BY Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishAccountant83630720001
    POWELL, Don Malcolm
    173 Station Road
    Mickleover
    DE3 9FJ Derby
    পরিচালক
    173 Station Road
    Mickleover
    DE3 9FJ Derby
    United KingdomBritishChartered Accountant79094140002
    PURCHASE, Roger
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishFinance Director49298600001
    SIMPSON, Kenneth
    Hillside
    Butts Lane
    SA68 0TP Kilgetty
    Dyfed
    পরিচালক
    Hillside
    Butts Lane
    SA68 0TP Kilgetty
    Dyfed
    BritishDirector27376570001
    WATKIN, David Howard
    14 Elizabeth Road
    Brookhouse
    WS5 3PF Walsall
    West Midlands
    পরিচালক
    14 Elizabeth Road
    Brookhouse
    WS5 3PF Walsall
    West Midlands
    BritishWorks Director59716410001
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    কর্পোরেট পরিচালক
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    SWISH PRODUCTS এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ ডিসে, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ জানু, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the finance documents (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    ব্যবসায়
    • ০৯ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ জুন, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises being plots 114-118 lichfield rod industrial estate tamworth, staffordshire title no: sf 168725.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book debts & other debts uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৮১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৮১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & property situated at lichfield road industrial estate tamworth staffordshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৯ এপ্রি, ১৯৮১একটি চার্জের নিবন্ধন

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0