TERMINUS 65 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTERMINUS 65 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00510793
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TERMINUS 65 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য প্রিন্টিং (18129) / উৎপাদন
    • গ্রাহক এবং ব্যবসায়িক জার্নাল এবং সাময়িকী প্রকাশনা (58142) / তথ্য এবং যোগাযোগ

    TERMINUS 65 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TERMINUS 65 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    POLESTAR GREAVES LIMITED০৬ নভে, ১৯৯৮০৬ নভে, ১৯৯৮
    D.H. GREAVES LIMITED২৩ আগ, ১৯৫২২৩ আগ, ১৯৫২

    TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১০
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০১১
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৯

    TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০১ আগ, ২০১৬
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৫ আগ, ২০১৬
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ৩০ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Ann Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২০ আগ, ২০১৪

    ২০ আগ, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,000,000
    SH01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    3 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed polestar greaves LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১২ মে, ২০১১

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১০ মে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    8 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ আগ, ২০১০

    ০২ আগ, ২০১০ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2,000,000
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    TERMINUS 65 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    সচিব
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    পরিচালক
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 0LQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    পরিচালক
    Peters Lane
    HP27 0LQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    STEVENSON, John Cyril
    2 Queen Elizabeth Drive
    Scalby
    YO13 0SR Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    2 Queen Elizabeth Drive
    Scalby
    YO13 0SR Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector53677600002
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    HAINSWORTH, Paul
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    সচিব
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    BritishCompany Secretary84514980001
    HIRST, Andrew Patrick
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    সচিব
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    British89191830001
    HOWELL, Michael Wayne
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    সচিব
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    British15478430001
    ALDREN, Stephen
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    পরিচালক
    59 Seward Road
    WR11 7HQ Badsey
    Evesham
    United KingdomBritishAccountant105696350001
    ALLAN, Russell
    Stonebeck 6 Beech Drive
    Scalby
    YO13 0NP Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Stonebeck 6 Beech Drive
    Scalby
    YO13 0NP Scarborough
    North Yorkshire
    BritishManaging Director9908720001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    CHAPMAN, Peter William
    Cawood Cottage
    Cloughton
    YO13 0AX Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Cawood Cottage
    Cloughton
    YO13 0AX Scarborough
    North Yorkshire
    BritishTechnical Director15478440001
    CLARK, Stephen John
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    পরিচালক
    Beaumont House Evesham Road
    Salford Priors
    WR11 5UU Evesham
    Worcestershire
    BritishEngineer49702240002
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HENNERS, Brian Anthony
    7 Newlands Park Drive
    YO12 6DW Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    7 Newlands Park Drive
    YO12 6DW Scarborough
    North Yorkshire
    BritishWorks Director37532310001
    HIRST, Andrew Patrick
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    পরিচালক
    The Meadows
    Ogle Road
    YO15 1NT Flamborough
    East Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director & Company Sec89191830001
    HOWELL, Michael Wayne
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Ings Green 17 Ings Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DR Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director15478430001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    পরিচালক
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    LYALL, Peter Edward
    Chalkpit House
    The Dell Kingsclere
    RG15 8NL Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    Chalkpit House
    The Dell Kingsclere
    RG15 8NL Newbury
    Berkshire
    BritishSales Dir44633140001
    MAUGHAN, Colin
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director2000880001
    MCQUILLAN, Paul John
    18e Market Place
    YO17 7LX Malton
    North Yorkshire
    পরিচালক
    18e Market Place
    YO17 7LX Malton
    North Yorkshire
    BritishSales Director78958070002
    OXFORD, Jonathan James
    19 Cayley Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DL Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    19 Cayley Lane
    Brompton By Sawdon
    YO13 9DL Scarborough
    North Yorkshire
    BritishProcess & It Director54046870001
    POCKNALL, Michael George
    74 Abbots Garth
    Seamer
    YO12 4QN Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    74 Abbots Garth
    Seamer
    YO12 4QN Scarborough
    North Yorkshire
    BritishProduction Director49294360001
    POWELL, George Christopher James
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishAccountant71388200001
    RACKLEY, Ralph William Derek
    43 Hovingham Drive
    YO12 5DT Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    43 Hovingham Drive
    YO12 5DT Scarborough
    North Yorkshire
    BritishCommercial Director15478450001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishChief Executive Officer44908110001
    SALTER, Declan John
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishPrinter67413330001
    SCHOFIELD, Raymond
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishGeneral Manager10127810002
    STEVENSON, John Cyril
    2 Sea View Grove
    YO11 3JA Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    2 Sea View Grove
    YO11 3JA Scarborough
    North Yorkshire
    BritishOperations Director53677600001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    পরিচালক
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003
    TOPHAM, Bryan
    17 Pullan Avenue
    BD2 3RS Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    17 Pullan Avenue
    BD2 3RS Bradford
    West Yorkshire
    BritishChairman9908710001
    WALKER, Patrick Granville
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    BritishChief Executive23217500001

    TERMINUS 65 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited as Agent and Trustee for the Benefit of the Lenders
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The real estate being l/h land situated between brunel way and newcomen way colchester. L/h petty house whitehall road & coleman street leeds t/n WYK767996. L/h unit 2 lockwood house lockwood way parkside industrial estate leeds. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (In Its Capacity as Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ১৯ মার্চ, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ মে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Security agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited for Itself and as Agent and Trustee for Each of the Secured Creditors
    ব্যবসায়
    • ২২ ডিসে, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trstee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Supplemental deed (supplemental to a composite guarantee & debenture dated 19 june 1998)
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other watmoughs UK charging subsidiary (as therein defined) to the secured parties or any of them including all monies due under or pursuant to the finance documents (as defined) and/or the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent and Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৫৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৫৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০২ মার্চ, ১৯৫৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৫ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0