TERMINUS 65 LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | TERMINUS 65 LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 00510793 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ | |
বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
TERMINUS 65 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- অন্যান্য প্রিন্টিং (18129) / উৎপাদন
- গ্রাহক এবং ব্যবসায়িক জার্নাল এবং সাময়িকী প্রকাশনা (58142) / তথ্য এবং যোগাযোগ
TERMINUS 65 LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | 1 Apex Business Centre Boscombe Road LU5 4SB Dunstable Bedfordshire |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
TERMINUS 65 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
POLESTAR GREAVES LIMITED | ০৬ নভে, ১৯৯৮ | ০৬ নভে, ১৯৯৮ |
D.H. GREAVES LIMITED | ২৩ আগ, ১৯৫২ | ২৩ আগ, ১৯৫২ |
TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
---|---|
পরবর্তী হিসাব | |
পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০১০ |
পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ জুন, ২০১১ |
শেষ হিসাব | |
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ সেপ, ২০০৯ |
TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
---|---|
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ০১ আগ, ২০১৬ |
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ১৫ আগ, ২০১৬ |
মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?
বার্ষিক রিটার্ন |
|
---|
TERMINUS 65 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার | 3 পৃষ্ঠা | AC92 | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2 | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||||||||||
আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার | 3 পৃষ্ঠা | AC92 | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2 | ||||||||||
বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1 | ||||||||||
৩০ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Ann Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 8 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার | 3 পৃষ্ঠা | AC92 | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed polestar greaves LIMITED\certificate issued on 12/05/11 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | CONNOT | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 পৃষ্ঠা | MG02 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ০১ আগ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 8 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি | 8 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
TERMINUS 65 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODWIN, Alan | সচিব | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | British | Company Secretary | 98921850001 | |||||
GOODWIN, Alan James | পরিচালক | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | United Kingdom | British | Company Secretary | 98921850003 | ||||
HIBBERT, Barry Alan | পরিচালক | River Steps Gibraltar Lane SL6 9TR Cookham Dean Berkshire | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 68122470005 | ||||
JOHNSTON, Peter Douglas | পরিচালক | Peters Lane HP27 0LQ Whiteleaf Tanglewood Bucks | England | British | Finance Director | 138015860001 | ||||
STEVENSON, John Cyril | পরিচালক | 2 Queen Elizabeth Drive Scalby YO13 0SR Scarborough North Yorkshire | England | British | Director | 53677600002 | ||||
BRIDGES, Clive | সচিব | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 987230001 | |||||
HAINSWORTH, Paul | সচিব | 28 Oakleigh View Baildon BD17 5TP Shipley Yorkshire | British | Company Secretary | 84514980001 | |||||
HIRST, Andrew Patrick | সচিব | The Meadows Ogle Road YO15 1NT Flamborough East Yorkshire | British | 89191830001 | ||||||
HOWELL, Michael Wayne | সচিব | Ings Green 17 Ings Lane Brompton By Sawdon YO13 9DR Scarborough North Yorkshire | British | 15478430001 | ||||||
ALDREN, Stephen | পরিচালক | 59 Seward Road WR11 7HQ Badsey Evesham | United Kingdom | British | Accountant | 105696350001 | ||||
ALLAN, Russell | পরিচালক | Stonebeck 6 Beech Drive Scalby YO13 0NP Scarborough North Yorkshire | British | Managing Director | 9908720001 | |||||
BRIDGES, Clive | পরিচালক | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 987230001 | |||||
BROWN, Frederick James | পরিচালক | 61 Handside Lane AL8 6SH Welwyn Garden City Hertfordshire | British | Chief Executive Officer | 16105360002 | |||||
CHAPMAN, Peter William | পরিচালক | Cawood Cottage Cloughton YO13 0AX Scarborough North Yorkshire | British | Technical Director | 15478440001 | |||||
CLARK, Stephen John | পরিচালক | Beaumont House Evesham Road Salford Priors WR11 5UU Evesham Worcestershire | British | Engineer | 49702240002 | |||||
HEARN, Catherine Ann | পরিচালক | White Gate House Ellesborough Road HP22 6ES Wendover Buckinghamshire | United Kingdom | British | Group Hr Director | 83713930001 | ||||
HENNERS, Brian Anthony | পরিচালক | 7 Newlands Park Drive YO12 6DW Scarborough North Yorkshire | British | Works Director | 37532310001 | |||||
HIRST, Andrew Patrick | পরিচালক | The Meadows Ogle Road YO15 1NT Flamborough East Yorkshire | United Kingdom | British | Finance Director & Company Sec | 89191830001 | ||||
HOWELL, Michael Wayne | পরিচালক | Ings Green 17 Ings Lane Brompton By Sawdon YO13 9DR Scarborough North Yorkshire | England | British | Managing Director | 15478430001 | ||||
JOHNSTON, Peter Douglas | পরিচালক | Flat 3 76 Carter Lane EC4V 5EA London | British | Group Finance Director | 83714120001 | |||||
LYALL, Peter Edward | পরিচালক | Chalkpit House The Dell Kingsclere RG15 8NL Newbury Berkshire | British | Sales Dir | 44633140001 | |||||
MAUGHAN, Colin | পরিচালক | The Grange Moorhead Crescent BD18 4LQ Shipley West Yorkshire | British | Company Director | 2000880001 | |||||
MCQUILLAN, Paul John | পরিচালক | 18e Market Place YO17 7LX Malton North Yorkshire | British | Sales Director | 78958070002 | |||||
OXFORD, Jonathan James | পরিচালক | 19 Cayley Lane Brompton By Sawdon YO13 9DL Scarborough North Yorkshire | British | Process & It Director | 54046870001 | |||||
POCKNALL, Michael George | পরিচালক | 74 Abbots Garth Seamer YO12 4QN Scarborough North Yorkshire | British | Production Director | 49294360001 | |||||
POWELL, George Christopher James | পরিচালক | 16 Wellington Square GL50 4JS Cheltenham Gloucestershire | British | Accountant | 71388200001 | |||||
RACKLEY, Ralph William Derek | পরিচালক | 43 Hovingham Drive YO12 5DT Scarborough North Yorkshire | British | Commercial Director | 15478450001 | |||||
ROBERTSON, Malcolm Murray | পরিচালক | Mardale 85 Harmer Green Lane Digswell AL6 0ER Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 39155140002 | ||||
RUDSTON, Anthony | পরিচালক | Minstrels Barn Henton OX9 4AE Chinnor Oxfordshire | England | British | Chief Executive Officer | 44908110001 | ||||
SALTER, Declan John | পরিচালক | Woodcote Burtons Lane HP8 4BA Chalfont St. Giles Buckinghamshire | England | British | Printer | 67413330001 | ||||
SCHOFIELD, Raymond | পরিচালক | 6 Whitham Close Boston Spa LS23 6DU Wetherby West Yorkshire | England | British | General Manager | 10127810002 | ||||
STEVENSON, John Cyril | পরিচালক | 2 Sea View Grove YO11 3JA Scarborough North Yorkshire | British | Operations Director | 53677600001 | |||||
TIMMINS, Richard Keith | পরিচালক | 3 Maxey View Deeping Gate PE6 9BE Peterborough | United Kingdom | British | Director | 127238050003 | ||||
TOPHAM, Bryan | পরিচালক | 17 Pullan Avenue BD2 3RS Bradford West Yorkshire | British | Chairman | 9908710001 | |||||
WALKER, Patrick Granville | পরিচালক | Plumpton House Mitchell Lane Thackley BD10 0TA Bradford West Yorkshire | British | Chief Executive | 23217500001 |
TERMINUS 65 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
Security agreement | তৈরি করা হয়েছে ২৬ নভে, ২০০৮ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৮ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ For details of properties charged please refer to the form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Amendment agreement relating to the security agreement dated 13 december 2006 and | তৈরি করা হয়েছে ২৫ নভে, ২০০৮ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ২০০৮ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ For properties charged please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Supplemental security agreement | তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ২০০৭ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ মার্চ, ২০০৭ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The real estate being l/h land situated between brunel way and newcomen way colchester. L/h petty house whitehall road & coleman street leeds t/n WYK767996. L/h unit 2 lockwood house lockwood way parkside industrial estate leeds. For further details of property charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Security agreement | তৈরি করা হয়েছে ১৩ ডিসে, ২০০৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৬ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998 | তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited | তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All moneys and liabilities due or to become due from the chargor to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Including (I) l/hold over unit B5 blenheim industrial park estate,bury st edmunds,suffolk; (ii) l/hold unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; BD77546; (iii) l/hold over wigman rd,aspley,nottingham; t/nos NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited | তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Supplemental deed (supplemental to a composite guarantee & debenture dated 19 june 1998) | তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৮ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৮ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company and each other watmoughs UK charging subsidiary (as therein defined) to the secured parties or any of them including all monies due under or pursuant to the finance documents (as defined) and/or the deed | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Charge | তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ১৯৫৯ ডেলিভারি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৫৯ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
|
তথ্য উৎস
- ইউকে কম্পানিজ হাউস
যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে। - লাইসেন্স: CC0