TERMINUS 67 LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
কোম্পানির নাম | TERMINUS 67 LIMITED |
---|---|
কোম্পানির স্থিতি | সক্রিয় |
আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
কোম্পানি নম্বর | 00517383 |
এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
সৃষ্টির তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
---|---|
চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
TERMINUS 67 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- অন্যান্য প্রিন্টিং (18129) / উৎপাদন
TERMINUS 67 LIMITED কোথায় অবস্থিত?
নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Official Receivers Office 4 Abbey Orchard Street SW1P 2HT London United Kingdom |
---|---|
ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
TERMINUS 67 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
---|---|---|
POLESTAR WATMOUGHS LIMITED | ০৬ নভে, ১৯৯৮ | ০৬ নভে, ১৯৯৮ |
WATMOUGHS LIMITED | ১৯ মার্চ, ১৯৫৩ | ১৯ মার্চ, ১৯৫৩ |
TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
---|---|
পরবর্তী হিসাব | |
পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয় | ৩০ সেপ, ২০১০ |
পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয় | ৩০ জুন, ২০১১ |
শেষ হিসাব | |
শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩০ সেপ, ২০০৯ |
TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?
মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
---|---|
শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে | ৩০ এপ্রি, ২ ০১৭ |
পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে | ১৪ মে, ২০১৭ |
মেয়াদোত্তীর্ণ | হ্যাঁ |
TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?
বার্ষিক রিটার্ন |
|
---|
TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
০১ জানু, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Alan Goodwin এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM02 | ||||||||||
০১ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alan James Goodwin এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
০১ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Douglas Johnston এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
০১ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Barry Alan Hibbert এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
১৯ ফেব, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 Apex Business Centre Boscombe Road Dunstable Bedfordshire LU5 4SB থেকে Official Receivers Office 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HT এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
৩০ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Ann Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার | 5 পৃষ্ঠা | AC92 | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ার হোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
পরিচালক হিসাবে Catherine Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | SOAS(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | 1 পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 7 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র Company name changed polestar watmoughs LIMITED\certificate issued on 12/05/11 | 3 পৃষ্ঠা | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি | 2 পৃষ্ঠা | CONNOT | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি | 8 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্ত ন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH03 | ||||||||||
৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি | 8 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
legacy | 4 পৃষ্ঠা | 363a | ||||||||||
TERMINUS 67 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARKER, Philip Dennison | সচিব | 7 Brecks Gardens Kippax LS25 7LP Leeds | British | 40070580001 | ||||||
BRIDGES, Clive | সচিব | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | 987230001 | ||||||
GOODWIN, Alan | সচিব | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | British | Company Secretary | 98921850001 | |||||
SCHOFIELD, Raymond | সচিব | 6 Whitham Close Boston Spa LS23 6DU Wetherby West Yorkshire | British | 10127810002 | ||||||
SMITH, John Barry | সচিব | Cravens 29 Staveley Road BD18 4HD Shipley West Yorkshire | British | 10769190001 | ||||||
WALLIS, Andrew Leonard | সচিব | The Old Rectory Church Street South Collingham NG23 7LH Newark Nottinghamshire | British | 681750001 | ||||||
WIGGLESWORTH, Peter | সচিব | 1 Parlington Villas Aberford LS25 3EP Leeds West Yorkshire | British | Director | 96547470001 | |||||
BARKER, Philip Dennison | পরিচালক | 7 Brecks Gardens Kippax LS25 7LP Leeds | United Kingdom | British | Company Director | 40070580001 | ||||
BRIDGES, Clive | পরিচালক | 334 Wendover Road Weston Turville HP22 5TN Aylesbury Buckinghamshire | British | Chartered Accountant | 987230001 | |||||
BROWN, Frederick James | পরিচালক | 61 Handside Lane AL8 6SH Welwyn Garden City Hertfordshire | British | Chief Executive Officer | 16105360002 | |||||
CLARK, Stephen John | পরিচালক | 38 Woodvale Crescent Oakwood Park Bingley BD16 4AL Bradford West Yorkshire | British | Commercial Director | 49702240001 | |||||
FORRESTER, David Graham | পরিচালক | 2 Foss Walk Nether Poppleton YO26 6RF York North Yorkshire | British | Manufacturing Development | 71131490001 | |||||
GOODWIN, Alan James | পরিচালক | Ensign House Juniper Drive SW18 1TR London 104 | United Kingdom | British | Company Secretary | 98921850003 | ||||
HEARN, Catherine Ann | পরিচালক | White Gate House Ellesborough Road HP22 6ES Wendover Buckinghamshire | United Kingdom | British | Group Hr Director | 83713930001 | ||||
HIBBERT, Barry Alan | পরিচালক | River Steps Gibraltar Lane SL6 9TR Cookham Dean Berkshire | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 68122470005 | ||||
JOHNSTON, Peter Douglas | পরিচালক | Peters Lane HP27 OLQ Whiteleaf Tanglewood Bucks | England | British | Finance Director | 138015860001 | ||||
JOHNSTON, Peter Douglas | পরিচালক | Flat 3 76 Carter Lane EC4V 5EA London | British | Group Finance Director | 83714120001 | |||||
KITCHEN, Christopher David | পরিচালক | Nidd View Top Wath Road Pateley Bridge HG3 5PG Harrogate North Yorkshire | British | Commercial Director | 42980520001 | |||||
KNIGHTON, Nigel | পরিচালক | 3 Larkfield Close Copmanthorpe YO2 3GF York North Yorkshire | British | Works Director | 31240090001 | |||||
MAUGHAN, Colin | পরিচালক | The Grange Moorhead Crescent BD18 4LQ Shipley West Yorkshire | British | Deputy Chairman | 2000880001 | |||||
MITCHELL, Peter Harry | পরিচালক | 16 Nursery Road Nether Poppleton YO26 6NN York Yorkshire | British | Northern Sales Director | 48081990002 | |||||
POWELL, George Christopher James | পরিচালক | 16 Wellington Square GL50 4JS Cheltenham Gloucestershire | British | Director | 71388200001 | |||||
RICHARDSON, Douglas | পরিচালক | 12 Keeble Close Tiptree CO5 0NU Colchester Essex | British | Printer | 90947730001 | |||||
ROBERTSON, Malcolm Murray | পরিচালক | Mardale 85 Harmer Green Lane Digswell AL6 0ER Welwyn Hertfordshire | United Kingdom | British | Finance Director | 39155140002 | ||||
ROBINSON, Paul | পরিচালক | 11 Mountside GU2 5JD Guildford Surrey | British | Sales Director | 28582730001 | |||||
RUDSTON, Anthony | পরিচালক | Minstrels Barn Henton OX9 4AE Chinnor Oxfordshire | England | British | Group Chief Executive | 44908110001 | ||||
RUMBLE, Adrian Douglas | পরিচালক | 44 Meadowhill Newton Mearns G77 6SX Glasgow Lanarkshire | British | Managing Director | 70945400001 | |||||
SALTER, Declan John | পরিচালক | Woodcote Burtons Lane HP8 4BA Chalfont St. Giles Buckinghamshire | England | British | Managing Director | 67413330001 | ||||
SCHOFIELD, Raymond | পরিচালক | 6 Whitham Close Boston Spa LS23 6DU Wetherby West Yorkshire | England | British | Financial Director | 10127810002 | ||||
SMITH, John Barry | পরিচালক | Cravens 29 Staveley Road BD18 4HD Shipley West Yorkshire | British | Accountant | 10769190001 | |||||
SMITH, John Barry | পরিচালক | Cravens 29 Staveley Road BD18 4HD Shipley West Yorkshire | British | Financial Director | 10769190001 | |||||
STEVENSON, John Cyril | পরিচালক | 2 Queen Elizabeth Drive Scalby YO13 0SR Scarborough North Yorkshire | England | British | Director | 53677600002 | ||||
TIMMINS, Richard Keith | পরিচালক | 3 Maxey View Deeping Gate PE6 9BE Peterborough | United Kingdom | British | Director | 127238050003 | ||||
TOPHAM, Bryan | পরিচালক | 17 Pullan Avenue BD2 3RS Bradford West Yorkshire | British | Executive Chairman | 9908710001 | |||||
WALKER, Patrick Granville | পরিচালক | Plumpton House Mitchell Lane Thackley BD10 0TA Bradford West Yorkshire | British | Director | 23217500001 |
TERMINUS 67 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
---|---|---|---|---|
A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998 | তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৬ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998 | তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited | তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২ | বকেয়া | সুরক্ষিত পরিমাণ All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited | তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১ |