TERMINUS 67 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • বার্ষিক রিটার্ন
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTERMINUS 67 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিসক্রিয়
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00517383
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TERMINUS 67 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য প্রিন্টিং (18129) / উৎপাদন

    TERMINUS 67 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Official Receivers Office
    4 Abbey Orchard Street
    SW1P 2HT London
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TERMINUS 67 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    POLESTAR WATMOUGHS LIMITED০৬ নভে, ১৯৯৮০৬ নভে, ১৯৯৮
    WATMOUGHS LIMITED১৯ মার্চ, ১৯৫৩১৯ মার্চ, ১৯৫৩

    TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ সেপ, ২০১০
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়৩০ জুন, ২০১১
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৯

    TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে৩০ এপ্রি, ২০১৭
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৪ মে, ২০১৭
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ বার্ষিক রিটার্নের স্থিতি কী?

    বার্ষিক রিটার্ন
    শেষ বার্ষিক রিটার্ন
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    TERMINUS 67 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ০১ জানু, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Alan Goodwin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০১ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alan James Goodwin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ অক্টো, ২০১৫ তারিখে পরিচালক হিসাবে Peter Douglas Johnston এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০১ জানু, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Barry Alan Hibbert এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ১৯ ফেব, ২০১৬ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 Apex Business Centre Boscombe Road Dunstable Bedfordshire LU5 4SB থেকে Official Receivers Office 4 Abbey Orchard Street London SW1P 2HTপরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD01

    ৩০ সেপ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Catherine Ann Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০২ জুন, ২০১৫

    ০২ জুন, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000,000
    SH01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৫ জুন, ২০১৪

    ২৫ জুন, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 3,000,000
    SH01

    আদালতের আদেশে পুনরুদ্ধার

    5 পৃষ্ঠাAC92

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Catherine Hearn এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাSOAS(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed polestar watmoughs LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name১২ মে, ২০১১

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১০ মে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    বার্ষিক রিটার্ন ৩০ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    TERMINUS 67 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BARKER, Philip Dennison
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    সচিব
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    British40070580001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    সচিব
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    SCHOFIELD, Raymond
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    সচিব
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    British10127810002
    SMITH, John Barry
    Cravens 29 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    সচিব
    Cravens 29 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    British10769190001
    WALLIS, Andrew Leonard
    The Old Rectory
    Church Street South Collingham
    NG23 7LH Newark
    Nottinghamshire
    সচিব
    The Old Rectory
    Church Street South Collingham
    NG23 7LH Newark
    Nottinghamshire
    British681750001
    WIGGLESWORTH, Peter
    1 Parlington Villas
    Aberford
    LS25 3EP Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    1 Parlington Villas
    Aberford
    LS25 3EP Leeds
    West Yorkshire
    BritishDirector96547470001
    BARKER, Philip Dennison
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    পরিচালক
    7 Brecks Gardens
    Kippax
    LS25 7LP Leeds
    United KingdomBritishCompany Director40070580001
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    CLARK, Stephen John
    38 Woodvale Crescent
    Oakwood Park Bingley
    BD16 4AL Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    38 Woodvale Crescent
    Oakwood Park Bingley
    BD16 4AL Bradford
    West Yorkshire
    BritishCommercial Director49702240001
    FORRESTER, David Graham
    2 Foss Walk
    Nether Poppleton
    YO26 6RF York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    2 Foss Walk
    Nether Poppleton
    YO26 6RF York
    North Yorkshire
    BritishManufacturing Development71131490001
    GOODWIN, Alan James
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    পরিচালক
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    United KingdomBritishCompany Secretary98921850003
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    পরিচালক
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    পরিচালক
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    KITCHEN, Christopher David
    Nidd View Top Wath Road
    Pateley Bridge
    HG3 5PG Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Nidd View Top Wath Road
    Pateley Bridge
    HG3 5PG Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCommercial Director42980520001
    KNIGHTON, Nigel
    3 Larkfield Close
    Copmanthorpe
    YO2 3GF York
    North Yorkshire
    পরিচালক
    3 Larkfield Close
    Copmanthorpe
    YO2 3GF York
    North Yorkshire
    BritishWorks Director31240090001
    MAUGHAN, Colin
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    BritishDeputy Chairman2000880001
    MITCHELL, Peter Harry
    16 Nursery Road
    Nether Poppleton
    YO26 6NN York
    Yorkshire
    পরিচালক
    16 Nursery Road
    Nether Poppleton
    YO26 6NN York
    Yorkshire
    BritishNorthern Sales Director48081990002
    POWELL, George Christopher James
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    16 Wellington Square
    GL50 4JS Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishDirector71388200001
    RICHARDSON, Douglas
    12 Keeble Close
    Tiptree
    CO5 0NU Colchester
    Essex
    পরিচালক
    12 Keeble Close
    Tiptree
    CO5 0NU Colchester
    Essex
    BritishPrinter90947730001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    ROBINSON, Paul
    11 Mountside
    GU2 5JD Guildford
    Surrey
    পরিচালক
    11 Mountside
    GU2 5JD Guildford
    Surrey
    BritishSales Director28582730001
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive44908110001
    RUMBLE, Adrian Douglas
    44 Meadowhill
    Newton Mearns
    G77 6SX Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    44 Meadowhill
    Newton Mearns
    G77 6SX Glasgow
    Lanarkshire
    BritishManaging Director70945400001
    SALTER, Declan John
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishManaging Director67413330001
    SCHOFIELD, Raymond
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    6 Whitham Close
    Boston Spa
    LS23 6DU Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishFinancial Director10127810002
    SMITH, John Barry
    Cravens 29 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Cravens 29 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    BritishAccountant10769190001
    SMITH, John Barry
    Cravens 29 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Cravens 29 Staveley Road
    BD18 4HD Shipley
    West Yorkshire
    BritishFinancial Director10769190001
    STEVENSON, John Cyril
    2 Queen Elizabeth Drive
    Scalby
    YO13 0SR Scarborough
    North Yorkshire
    পরিচালক
    2 Queen Elizabeth Drive
    Scalby
    YO13 0SR Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector53677600002
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    পরিচালক
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003
    TOPHAM, Bryan
    17 Pullan Avenue
    BD2 3RS Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    17 Pullan Avenue
    BD2 3RS Bradford
    West Yorkshire
    BritishExecutive Chairman9908710001
    WALKER, Patrick Granville
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector23217500001

    TERMINUS 67 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 19TH june 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৬
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sum or sums from time to time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental deed (supplemental to a composite guarantee & debenture dated 19 june 1998)
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other watmoughs UK charging subsidiary (as therein defined) to the secured parties or any of them including all monies due under or pursuant to the finance documents (as defined) and/or the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent and Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0