KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামKITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00540556
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    St Anns Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    VENT MASTER (EUROPE) LIMITED২১ জুন, ১৯৯৬২১ জুন, ১৯৯৬
    BERISFORD BAKER STREET LIMITED০১ মার্চ, ১৯৯৫০১ মার্চ, ১৯৯৫
    BERISFORD TREASURY LIMITED১০ ফেব, ১৯৯৫১০ ফেব, ১৯৯৫
    BERISFORD TREASURY LIMITED০৯ মে, ১৯৮৯০৯ মে, ১৯৮৯
    S & W BERISFORD TREASURY LIMITED২৯ অক্টো, ১৯৮৭২৯ অক্টো, ১৯৮৭
    ASTON METAL CO LIMITED১২ নভে, ১৯৫৪১২ নভে, ১৯৫৪

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১২

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    4 পৃষ্ঠাDS01

    ০৯ আগ, ২০১৩ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    legacy

    3 পৃষ্ঠাSH20

    legacy

    3 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ০৩ এপ্রি, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Michael James Kachmer এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Graham Philip Brisley Veal-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Kevin Blades এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    5 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ২৮ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    7 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Thomas Doerr এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Adrian David Gray-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা353

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PRIMA SECRETARY LIMITED
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    কর্পোরেট সচিব
    St Ann's Wharf
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    94529700001
    GRAY, Adrian David
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    পরিচালক
    Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Ann's Wharf 112
    United KingdomBritish146072380001
    JONES, Maurice Delon
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    পরিচালক
    1650 Westbury Court
    Manitowoc
    Wisconsin 54220
    Usa
    UsaAmerican134328700001
    VEAL, Graham Philip Brisley
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    পরিচালক
    112 Quayside
    NE1 3DX Newcastle Upon Tyne
    St Anns Wharf
    United Kingdom
    EnglandBritish43215170003
    BURROWES, Rosemary Anne
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    সচিব
    108c Bramley Road
    Oakwood
    N14 4HT London
    British49687740001
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    SYMS, Rhonda Sneddon
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    সচিব
    2 Swallow Rise
    Knaphill
    GU21 2LG Woking
    Surrey
    British16978550002
    BLADES, Kevin Nicholas
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    পরিচালক
    Hatch Farm
    Bossingham Road
    CT4 6AQ Stelling Minnis
    Kent
    EnglandBritish79449700002
    BUTLER, Peter Robert
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    পরিচালক
    Gifford House
    22 Chalklands Howe Green
    CM2 7TH Chelmsford
    Essex
    British34707070001
    CUTHBERTSON, George Brian
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    পরিচালক
    39 The Gardens
    WD1 3DN Watford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish6996370001
    DOERR, Thomas
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    পরিচালক
    Hillborow Road
    KT10 9UD Esher
    Newleigh House
    Surrey
    United States134081280001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    British45532880003
    GORDON, Alastair Neil
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    পরিচালক
    64 Castelnau
    SW13 9EX London
    EnglandBritish61620710001
    HOOPER, David Ross
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Mill Road
    SL7 1UA Marlow
    6 Millbank
    Buckinghamshire
    British17023730002
    HOOPER, David Ross
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    পরিচালক
    Long Mynd Burchetts Green Lane
    Burchetts Green
    SL6 3QW Maidenhead
    Berkshire
    British17023730001
    JONES, Eric Alan
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    পরিচালক
    Stidolphs Old Farm House
    Eggpie Lane Sevenoaks
    TN4 6NP Weald
    Kent
    British27290300001
    KACHMER, Michael James
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    পরিচালক
    Marywood Trail
    60187 Wheaton
    14
    Illinois
    United States
    United StatesAmerican136570610001
    O'CONNOR, Patrick Finbarr
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    মনোনীত পরিচালক
    66 Cumberland Mills Square
    Saunders Ness Road
    E14 3BJ Isle Of Dogs
    London
    British/Irish900010100001
    WILSON, Andrew George Richard
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Cononley Hall
    Main Street Cononley
    BD20 8LJ Skipton
    West Yorkshire
    British47433990002
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310650003
    BERISFORD (OVERSEAS) LIMITED
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    কর্পোরেট পরিচালক
    Washington House
    40-41 Conduit Street
    W1S 2YQ London
    75310650002
    S & W BERISFORD LIMITED
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    কর্পোরেট পরিচালক
    The Place
    175 High Holborn
    WC1V 7AA London
    75310610006
    S & W BERISFORD LIMITED
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    কর্পোরেট পরিচালক
    1 Farnham Road
    GU2 4RG Guildford
    Surrey
    75310610001

    KITCHEN VENTILATION SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Second supplemental security agreement, which is supplemental to the security agreement, dated 20TH november 2001 as supplemented by a supplemental security agreement dated 20TH february 2002
    তৈরি করা হয়েছে ১১ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property 13 lower bristol road bath t/n AV190171, l/h property 42 west street gravesend t/n K702855, f/h property 51 bath street gravensend t/n K709759 (for details of further properties charged please refer to form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental security agreement between, amongst others, the charging company and the facility agent which is supplemental to the security agreement dated 20 november 2001 between the chargors and the facility agent
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ফেব, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ মার্চ, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due of each obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    ব্যবসায়
    • ০৮ মার্চ, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security agreement between the chargor and the royal bank of scotland the (facility agent)
    তৈরি করা হয়েছে ২০ নভে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ নভে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each chargor to any finance party under each finance document
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ৩০ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ আগ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ আগ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations due or to become due from each credit party from time to time to the facility agent, each issuing bank, the lenders or any of them or their respective affiliates under any credit document or secured hedge agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All investment property: all right, title and interest of the company in all shares of capital stock owned by any us subsidiary ,the pledge agreement and the certificates, the collateral account together with all amounts on deposit from time to time in such deposit account. All books, records, ledger cards, files, computer programs, tapes, discs and related data processing software that at any time evidence or contain information relating to any of the collateral. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Barclays Bank PLC as Facility Agent
    ব্যবসায়
    • ২৭ আগ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২২ আগ, ২০০১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Deed of amendment.
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for itself and for each bank (as defined) and barclays bank PLC (the replacement agent) under the terms of the debenture dated 26.9.90
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All the company's rights in the book debts & other debts, licenses, coments, authorisations etc. (see form 395 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ সেপ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obliger (as therein defiend) to national westminster bank PLC (the second security agent) and the banks (as threin defined) or any at them under the indebtedness agreements and the coffee refinancing agreement and all monies due or to become due from berisford international PLC under the subcrdination guarantee
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ৩০ জানু, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ সেপ, ১৯৯০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ অক্টো, ১৯৯০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee (the security agent) and the banks (aas therein defined) or any of them under each of the indebtedness agreements
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Nsee from 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৯ অক্টো, ১৯৯০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২২ এপ্রি, ১৯৯৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0