CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00540840
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অন্যান্য প্রস্তুতকৃত ধাতব পণ্য উত্পাদন (25990) / উৎপাদন

    CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    46 Edison Road
    PE27 3LG St. Ives
    Cambridgeshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ জুন, ২০১৪

    CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ স্থগিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS16(SOAS)

    চার্জ 9 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    1 পৃষ্ঠাMR04

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৪ ফেব, ২০১৬

    ০৪ ফেব, ২০১৬ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 123,103
    SH01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৯ জানু, ২০১৫

    ০৯ জানু, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 123,103
    SH01

    চার্জ 10 পুরোপুরি সন্তুষ্ট

    2 পৃষ্ঠাMR04

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার পদক্ষেপ বন্ধ করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাDISS40

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital০৬ জানু, ২০১৪

    ০৬ জানু, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 123,103
    SH01

    পরিচালক হিসাবে Steven Horton এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    18 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Mr David Jonathan Pett-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে James Walker এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে Steven James Horton-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    পূর্ণ হিসাব ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    19 পৃষ্ঠাAA

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৩ জানু, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    PETT, David Jonathan
    23 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    Cambridgeshire
    সচিব
    23 Mill Lane
    Linton
    CB1 6JY Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishAccountant12054930001
    PETT, David Jonathan
    Edison Road
    PE27 3LG St. Ives
    46
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Edison Road
    PE27 3LG St. Ives
    46
    Cambridgeshire
    United Kingdom
    EnglandBritishAccountant159428620001
    STOTT, Colin Andre
    NN13 5NF Hinton-In-The-Hedges
    Brook Farm Barn
    Northants
    পরিচালক
    NN13 5NF Hinton-In-The-Hedges
    Brook Farm Barn
    Northants
    United KingdomBritishManaging Director130529800001
    GLANFIELD, Martin James
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    সচিব
    Weston House
    Milcote Road
    CV37 8EH Welford On Avon
    Warwickshire
    British206032560001
    HALFORD, Timothy William
    8 Sandon Road
    Wollescote
    DY9 8XY Stourbridge
    West Midlands
    সচিব
    8 Sandon Road
    Wollescote
    DY9 8XY Stourbridge
    West Midlands
    British35192150001
    JAKES, Mark Andrew
    15 Station Road
    Manea
    PE15 0JL March
    Cambridgeshire
    সচিব
    15 Station Road
    Manea
    PE15 0JL March
    Cambridgeshire
    British67124530001
    LINFORD, Stephen Geoffrey
    Brook House School Road
    Snitterfield
    CV37 0JL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    সচিব
    Brook House School Road
    Snitterfield
    CV37 0JL Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    British15354310001
    MALLON, Ronald Jeffrey
    32 East Approach Drive
    Pittville
    GL52 3JE Cheltenham
    Gloucestershire
    সচিব
    32 East Approach Drive
    Pittville
    GL52 3JE Cheltenham
    Gloucestershire
    British8448420001
    PRICE, William Harold
    48 Batchworth Lane
    HA6 3HG Northwood
    Middlesex
    সচিব
    48 Batchworth Lane
    HA6 3HG Northwood
    Middlesex
    BritishSecretary51585490001
    ALDRED, Mark James
    Senna Drive
    NN12 7AU Towcester
    10
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Senna Drive
    NN12 7AU Towcester
    10
    Northamptonshire
    EnglandBritishManaging Director131095300001
    ARNSBY, Alan John
    Nine Daintrees
    Widford
    SG12 8RX Ware
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Nine Daintrees
    Widford
    SG12 8RX Ware
    Hertfordshire
    BritishElectrical Engineer12022400002
    BUTLER, Richard Stanley
    16 Earith Road
    Willingham
    CB4 5LS Cambridge
    Cambridgeshire
    পরিচালক
    16 Earith Road
    Willingham
    CB4 5LS Cambridge
    Cambridgeshire
    BritishCompany Director2886530001
    CHAMBERLAIN, Alan John
    53 Fernlea
    Braiswick
    CO4 5UB Colchester
    Essex
    পরিচালক
    53 Fernlea
    Braiswick
    CO4 5UB Colchester
    Essex
    BritishChartered Accountant37261670001
    HORTON, Steve James
    Hawkes Lane
    Bracon Ash
    NR14 8EW Norwich
    Amberly
    Norfolk
    পরিচালক
    Hawkes Lane
    Bracon Ash
    NR14 8EW Norwich
    Amberly
    Norfolk
    EnglandBritishNone193075380001
    JENKINS, Trefor
    Ty-Isaf Barns
    Derwydd
    SA18 2LJ Ammanford
    Carmarthenshire
    পরিচালক
    Ty-Isaf Barns
    Derwydd
    SA18 2LJ Ammanford
    Carmarthenshire
    BritishDirector26089450001
    MIDDLETON, Stephen
    `Lindisfarne`
    Holywell Front, Holywell.
    PE17 3TG Huntingdon
    Cambridge
    পরিচালক
    `Lindisfarne`
    Holywell Front, Holywell.
    PE17 3TG Huntingdon
    Cambridge
    BritishCompany Director2886540003
    PATTERSON, James Hutton
    19 New Street
    PE15 0SP Doddington
    Cambridge
    England
    পরিচালক
    19 New Street
    PE15 0SP Doddington
    Cambridge
    England
    BritishCompany Director32918500001
    REDFORD, Barry
    Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JU Solihull
    74
    West Midlands
    পরিচালক
    Avenue Road
    Dorridge
    B93 8JU Solihull
    74
    West Midlands
    United KingdomBritishManaging Director135706980001
    STICKINGS, Robert Anthony
    Tiffield Grange High St South
    Tiffield
    NN12 8AB Towcester
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Tiffield Grange High St South
    Tiffield
    NN12 8AB Towcester
    Northamptonshire
    EnglandBritishCompany Director3012250001
    WALKER, James Alan Fairley
    Priddeons Hadley Common
    EN5 5QE Barnet
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Priddeons Hadley Common
    EN5 5QE Barnet
    Hertfordshire
    United KingdomBritishChartered Accountant7945280002
    WATSON, Henry
    Davander
    Findley Close
    IP9 2TL Stutton
    Suffolk
    পরিচালক
    Davander
    Findley Close
    IP9 2TL Stutton
    Suffolk
    United KingdomBritishCompany Director2886550001

    CRESCENT OF CAMBRIDGE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The freehold land and buildings adjoining edison road and somersham road st ives. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৪ মার্চ, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ জানু, ২০১৫একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ এপ্রি, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ২০০২
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৯ এপ্রি, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৪ জুল, ২০১৬একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Chattel mortgage supplemental to a mortgage debenture dated 10TH march 1999 issued by the company
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Assignment of the items listed below (the equipment) including any part or parts thereof and all additional alterations and accessories replacements and renewals of component parts thereto together with the benefit of all obligations and warranties given by any manufacturer or supplier of the equipment and all other obligations and warranties given by any other party in respect of the equipment to or in favour of the company and without prejudice to the generality of the foregoing the benefit of all maintenance agreements entered into between the company and any such third party; items: vw lt 35 van N452 yav. Roadrunner F245 bfl. LT85G trailer purchase date 6/94 (see form 395 for full details). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১১ মে, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মে, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a piece of land at st ives cambridgeshire. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মে, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১০ মার্চ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ মার্চ, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ আগ, ১৯৯১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ১৯৯১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    First fixed charge over all book and other debts; floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ১৯৯১একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মার্চ, ১৯৮৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ এপ্রি, ১৯৮৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H property k/a permises at school lane swaversey cambridgeshire.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৫ এপ্রি, ১৯৮৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding sterling pounds 100000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land & premises being factory premises in school lane swavesley cambridge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মে, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/Hold land hereditanets and premises being: factory premises in edison road st. Ives, cambridge.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মে, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ২৭ ডিসে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0