GENTRA LIMITED
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
| কোম্পানির নাম | GENTRA LIMITED |
|---|---|
| কোম্পানির স্থিতি | বাতিল |
| আইনি ফর্ম | প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি |
| কোম্পানি নম্বর | 00544337 |
| এখতিয়ার | ইংল্যান্ড/ওয়েলস |
| সৃষ্টির তারিখ | |
| বন্ধের তারিখ |
সংক্ষিপ্তসার
| সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছে | না |
|---|---|
| চার্জ রয়েছে | হ্যাঁ |
| দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছে | না |
| নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণ | না |
GENTRA LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?
- নিষ্ক্রিয় কোম্পানি (99999) / বহির্ভূত সংস্থা এবং সংস্থার কার্যক্রম
GENTRA LIMITED কোথায় অবস্থিত?
| নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London England |
|---|---|
| ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা | না |
GENTRA LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?
| কোম্পানির নাম | থেকে | পর্যন্ত |
|---|---|---|
| ROYAL TRUST BANK | ০৩ নভে, ১৯৮৬ | ০৩ নভে, ১৯৮৬ |
| ROYAL TRUST COMPANY OF CANADA (THE) | ০৮ ফেব, ১৯৫৫ | ০৮ ফেব, ১৯৫৫ |
GENTRA LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?
| শেষ হিসাব | |
|---|---|
| শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে | ৩১ ডিসে, ২০১৮ |
GENTRA LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?
| তারিখ | বর্ণনা | দলিল | প্রকার | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | GAZ2(A) | ||||||||||
স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি | পৃষ্ঠা | GAZ1(A) | ||||||||||
কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন | 3 পৃষ্ঠা | DS01 | ||||||||||
২৪ ফেব, ২০২০ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
২৪ ফেব, ২০১৯ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০১৮ তারিখে P Keith Hyde-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
০৫ ডিসে, ২০১৮ তারিখে Ricky Tang-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 2 পৃষ্ঠা | CH01 | ||||||||||
ছোট কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৭ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
০৩ আগ, ২০১৮ তারিখে উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি হিসাবে Gentra Holdings Company এর বিবরণের পরিবর্তন | 2 পৃষ্ঠা | PSC05 | ||||||||||
০৩ আগ, ২০১৮ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD England থেকে Joanna Scott, Level 15, Citypoint 1 Ropemaker Street London EC2Y 9AW এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ ্ঠা | AD01 | ||||||||||
২৪ ফেব, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি | 3 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি | 9 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
২৪ ফেব, ২০১৭ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি | 5 পৃষ্ঠা | CS01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি | 12 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
দ্বিতীয় দায়ের AR01 এর যা পূর্বে কোম্পানিজ হাউসে জমা দেওয়া হয়েছিল ২৪ ফেব, ২০১৬ তারিখে | 22 পৃষ্ঠা | RP04 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ফেব, ২০১৬ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 6 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
১১ মার্চ, ২০১৪ তারিখে Allen Yi-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | CH03 | ||||||||||
০৮ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ricky Tang-এর নিয়োগ | 2 পৃষ্ঠা | AP01 | ||||||||||
০৮ ফেব, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Bryan Kenneth Davis এর পদব্যবস্থা বাতিল | 1 পৃষ্ঠা | TM01 | ||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি | 11 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
১৮ জুল, ২০১৪ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ
| 3 পৃষ্ঠা | SH01 | ||||||||||
২৫ সেপ, ২০১৫ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা , C/O Berwin Leighton Paisner Llp, D Hughes Adelaide House, London Bridge, London, EC4R 9HA থেকে C/O Joanna Scott 99 Bishopsgate Level 2 London EC2M 3XD এ পরিবর্তন করা হয়েছে | 1 পৃষ্ঠা | AD01 | ||||||||||
বার্ষিক রিটার্ন ২৪ ফেব, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ | 5 পৃষ্ঠা | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি | 10 পৃষ্ঠা | AA | ||||||||||
GENTRA LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?
| নাম | নিয়োগ করা হয়েছে | পদত্যাগের তারিখ | ভূমিকা | ঠিকানা | কোম্পানি পরিচয় | বাসস্থানের দেশ | জাতীয়তা | জন্ম তারিখ | পেশা | নম্বর |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YI, Allen | সচিব | Bay Street, Suite 330 Toronto 181 Ontario M5j 2t3 Canada | British | 187547370001 | ||||||
| HYDE, P Keith | পরিচালক | 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London Joanna Scott, Level 15, Citypoint England | Canada | Canadian | 105505500001 | |||||
| TANG, Ricky | পরিচালক | 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London Joanna Scott, Level 15, Citypoint England | United States | Canadian | 206973950002 | |||||
| GREGORY, Philip Charles | সচিব | Mulberry House 26 North Grove Highgate N6 4SL London | British | 33287640001 | ||||||
| HYDE, P Keith | সচিব | 26 Hambly Avenue Toronto Ontario M4e 2r6 Canada | Canadian | 105505500001 | ||||||
| IRONSIDE, Simon Anthony | সচিব | 2 Orchard Mews Southgate Grove Islington N1 5BS London | British | 31215710001 | ||||||
| MOODY, Patricia Joan | সচিব | 8 Riverdene HA8 9TD Edgware Middlesex | British | 5286990001 | ||||||
| MULROY, Kieran Finbarr | সচিব | 31 White Lodge Crescent L4C 9A1 Richmond Hill Ontario Canada | Canadian | 48720010001 | ||||||
| WICKS, Martin Theodore | সচিব | 206 Britannia Drive 431 Grand Cayman Box 30616 Smb Cayman Islands | British | 62800470003 | ||||||
| BARR, Brian Ernest | পরিচালক | C/O Falconbridge Limited 181 Bay Street Suite 200 Bce Place Toronto Ontario M5j2t3 Canada | British Canadian | 7708890001 | ||||||
| BRIERLEY, Michael Charles | পরিচালক | 45 Carisbrooke Gardens LE2 3PR Leicester Leicestershire | British | 5287010001 | ||||||
| CAPE, Edmund Andrew | পরিচালক | 75 Rosedale Heights Drive Toronto Ontario FOREIGN Canada | Canadian | 36523210001 | ||||||
| CORNELISSEN, Michael Adriaan | পরিচালক | 2061 Lakeshore Road East FOREIGN Oakville Ontario L6j 1x4 Canada | Canadian | 7708900001 | ||||||
| DAVENPORT, Maurice Hopwood | পরিচালক | Pines Dormans Park RH19 2LX East Grinstead West Sussex | United Kingdom | British | 6765160001 | |||||
| DAVIS, Bryan Kenneth | পরিচালক | 75 Buckingham Avenue Toronto Ontario M4n 1r3 Canada | Canada | Canadian | 111671370001 | |||||
| DONNE, David Lucas | পরিচালক | 8 Montague Mews North W1H 1AH London | United Kingdom | British | 36527200001 | |||||
| FAIRCHILD, Robert William | পরিচালক | 26 Western Avenue Branksome Park BH13 7AN Poole Dorset | Britain | British | 16613760002 | |||||
| FELL, Fraser Matthews | পরিচালক | 34 Glenorchy Road M3C 2P9 Don Mills Ontario Canada | Canadian | 36469670001 | ||||||
| FREUND, Michael Walter | পরিচালক | 272 Belsize Drive M4S 1M6 Toronto Ontario Canada | Canadian | 36469710001 | ||||||
| GAMBLE, Horace Roy | পরিচালক | River Lodge 1 Ravensbury Drive TQ6 9BZ Dartmouth Devon | British | 4379420001 | ||||||
| HARKER, William Clinton | পরিচালক | 88 Hermitage Court Knighten Street E1 9PW London | Canadian | 22380340003 | ||||||
| HOLBECHE, Philip Leslie | পরিচালক | 7 Milburn Walk KT18 5JN Epsom Surrey | United Kingdom | British | 7708940001 | |||||
| JOLY, Laurent Maurice | পরিচালক | 4 Berkeley Gardens Kensington W8 4AP London | Canadian | 48827400001 | ||||||
| KELLER-HOBSON, Donald Stephen Douglas | পরিচালক | 48-50 Cannon Street EC4N 6LD London | Canadian | 36228770001 | ||||||
| KIMBALL, Marcus Richard, Lord | পরিচালক | Great Easton Manor LE16 8TB Market Harborough Leicestershire | British | 7708960001 | ||||||
| LAMBERT, Allen Thomas | পরিচালক | 483 Russell Hill Road FOREIGN Toronto Ontario M5p 2s8 Canada | Canadian | 7708970001 | ||||||
| LAURIE, Craig J | পরিচালক | The World Financial Center 200 Vesey Street 11th Floor New York Ny 10281-1021 Usa | Canadian | 105152590003 | ||||||
| LOVEGROVE, Philip Albert | পরিচালক | 50 Thorley Lane Bishops Stortford CM23 4AD Hertfordshire | British | 35568310001 | ||||||
| MACDOUGALL, Hartland Molson | পরিচালক | Belfountain FOREIGN Ontario L0n 1bo Canada | Canadian | 7708980001 | ||||||
| MILLER, James William | পরিচালক | 670 Fairmile Road V75 IR2 West Vancouver Bc Canada | Canadian | 34028940001 | ||||||
| PORTER, Michael Andrew | পরিচালক | Pitt Cottage Church Street Great Baddow CM2 7AA Chelmsford Essex | British | 32404350001 | ||||||
| STROYAN, Colin Strathearn Ropner | পরিচালক | Bridgend Of Teith FK16 6AD Doune Perthshire | United Kingdom | British | 1866210001 | |||||
| WALKER, James Barrett | পরিচালক | 53 Hillhurst Boulevard M5N 1N5 Toronto Ontario Canada | Canadian | 36469780001 | ||||||
| ONTARIO LIMITED | কর্পোরেট পরিচালক | Suite 1400 70 York Street Toronto Ontario M5j 1sj Canada | 48719890001 | |||||||
| SURREY INVESTMENTS INCORPORATED | কর্পোরেট পরিচালক | Box 30616 Smb Genesis Building Genesis Close Grand Cayman Cayman Islands | 68083360002 |
GENTRA LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?
| নাম | জানানো হয়েছে | ঠিকানা | বন্ধ হয়েছে | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gentra Holdings Company | ১৯ এপ্রি, ২০১৬ | 1 Ropemaker Street EC2Y 9AW London Joanna Scott, Level 15, Citypoint England | না | ||||||||||
| |||||||||||||
নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
| |||||||||||||
GENTRA LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?
| শ্রেণীবিন্যাস | তারিখ | স্থিতি | বিস্তারিত | |
|---|---|---|---|---|
| Assignment | তৈরি করা হয়েছে ১১ নভে, ১৯৯৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ২১ নভে, ১৯৯৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ All moneys due or owing or from time to time becoming due or owing to the company under or by virtue of the contract. The sum of £24,000 deposited with barclays finance company (isle of man) limited in the name of gentra limited. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Assignment | তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৯৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ The obligations of the company to the chargee (as defined in the deed) | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The sum of £952,500 in account no 31538268. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Charge over cash | তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ১৯৯৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৯৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever in connection with the hutton guarantee and/or this charge | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Any sum or sums deposited in account no. 548-785-5 and any debts represented thereby. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security agreement | তৈরি করা হয়েছে ০৯ মার্চ, ১৯৯৪ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ মার্চ, ১৯৯৪ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the counter-indemnity of even date and/or this agreement | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ All of the company's right title benefit and interest in and to the obligations of the mortgagee to make payment of all amounts standing to the credit to the company's deutschmark call deposit account maintained with the mortgagee and designated "royal bank of canada europe limited re: gentra - cash collateral a/c" and in and to all interest arising in connection therewith and all other amounts credited to the account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Mortgage sale agreement | তৈরি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ আগ, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement (as defined) | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The sum of £7,918,194.00 credited to the midland bank PLC of poultry & princes street,london EC2P 2BX, account number 21381679 together with all sums in the future credited to that account and including interest accrued or accruing in the future on the account. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ১৮ জুন, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৫ জুল, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ By way of first legal mortgage the charged assets and by way of floating charge the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Supplemental security document | তৈরি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ জুন, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the sub-participation agreement (as defined therein) | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ By way of first legal mortgage all the additional charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ১৭ মে, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জুন, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a sub-participation agreement dated 17 may 1993. | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The chargor charges as beneficial owner in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets as defined.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৩ | পুর োপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the sub-participation agreement dated 7 may 1993. | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ The chargor as beneficial owner charges in favour of the bank by way of first legal mortgage the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ২৩ এপ্রি, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the charged assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ এপ্রি, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement (as defined) | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ All rights under any additional documents and charged assets...................see form 395. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Letter of amendment | তৈরি করা হয়েছে ১৪ এপ্রি, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়ে ছে ২৯ এপ্রি, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ For amending the sub-participation agreement dated 7.4.93 (as defined) | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ All present and future rights......see form 395. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ০৭ এপ্রি, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ এপ্রি, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charges over the "charged assets" being the loan portfolio and all rights of the company under any additional documents connected with the loan portfolio. See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Security document | তৈরি করা হয়েছে ১২ মার্চ, ১৯৯৩ ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৩ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sub-participation agreement of even date | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ Fixed and floating charge over the "charged assets". See the mortgage charge document for full details. | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||
| Legal mortgage | তৈরি করা হয় েছে ২৭ মার্চ, ১৯৮৬ ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ এপ্রি, ১৯৮৬ | পুরোপুরি পরিশোধিত | সুরক্ষিত পরিমাণ All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
সংক্ষিপ্ত বিবরণ F/H land at eccleshall road, south, sheffield district of s yorks known as blenham nursing home t/n yew 41499. f/h land adjoining the above known as the blenheim lifestyle developments, t/nos. Stk 154003, ywe 41499. f/h land at old whittington chesterfield, derbyshire. F/h land off melbourne ave sheffield district of s yorks, (see doc M151 for full details). | ||||
অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
| ||||
ব্যবসায়
| ||||