PAIG OVERSEAS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামPAIG OVERSEAS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00549628
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    PAIG OVERSEAS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Kpmg One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    West Midlands
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    SETON HOUSE OVERSEAS LIMITED১৭ নভে, ২০০৫১৭ নভে, ২০০৫
    BRITAX OVERSEAS LIMITED০১ জুন, ১৯৯৭০১ জুন, ১৯৯৭
    B.S.G. OVERSEAS LIMITED১১ জুল, ১৯৯৪১১ জুল, ১৯৯৪
    BRISTOL STREET GROUP LIMITED২১ মে, ১৯৫৫২১ মে, ১৯৫৫

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১০

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ১৯ সেপ, ২০১২ তারিখে

    LRESSP

    ৩১ জুল, ২০১২ তারিখে সচিব হিসাবে Maureen Hodgkinson এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Mcgillivray-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে William Gerard Devanney এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ৩০ জুন, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Alistair Duncan Stewart-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ ডিসে, ২০১২ থেকে ৩০ জুন, ২০১২ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ জুন, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৬ জুন, ২০১২

    ২৬ জুন, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    SH01

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    2 পৃষ্ঠাAD01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Dividends paig acquisition LTD 18/01/2012
    RES13

    legacy

    1 পৃষ্ঠাSH20

    ২০ জানু, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1
    4 পৃষ্ঠাSH19

    ১৮ জানু, ২০১২ তারিখে শেয়ার একত্রীকরণ

    5 পৃষ্ঠাSH02

    legacy

    1 পৃষ্ঠাCAP-SS

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    2 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital

    রেজুলেশনগুলি

    Consolidation 18/01/2012
    RES13
    capital

    জারি করা শেয়ার মূলধন কমানোর রেজুলেশন

    RES06

    ৩১ আগ, ২০১১ তারিখে পরিচালক হিসাবে Stuart David Mccaslin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    12 পৃষ্ঠাAA

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    27 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৮ জুন, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    14 পৃষ্ঠাAR01

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    MCGILLIVRAY, Ian
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    পরিচালক
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    United KingdomBritishBank Official170383130001
    STEWART, Alistair Duncan
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    পরিচালক
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Kpmg
    West Midlands
    ScotlandBritishBank Official128116940001
    HODGKINSON, Maureen
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    সচিব
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    British161783480001
    PREMIUM AIRCRAFT INTERIORS GROUP LIMITED
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    কর্পোরেট সচিব
    Watchmoor Road
    GU15 3EX Camberley
    Watchmoor Point
    Surrey
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর3929802
    154770020001
    SETON HOUSE INTERNATIONAL SERVICES LIMITED
    Watchmoor Point
    Watchmor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    কর্পোরেট সচিব
    Watchmoor Point
    Watchmor Road
    GU15 3EX Camberley
    Surrey
    109290008
    BROGAN, Bernard Desmond
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    পরিচালক
    Blakeley Lodge
    Egginton Road Etwall
    DE65 6NQ Derby
    Derbyshire
    EnglandBritishChartered Engineer70252730001
    CANNON, Thomas Charles
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    90 Knowle Wood Road
    Dorridge
    B93 8JP Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary2756000001
    CARTER, Paul Dennis
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    পরিচালক
    24 Allington Avenue
    WS13 6PF Lichfield
    Staffordshire
    EnglandBritishCompany Director123148720001
    DAWSON, Anthony David
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    পরিচালক
    Flat 21 Hillbrow
    Richmond Hill
    TW10 6BH Richmond
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant89317200001
    DEVANNEY, William Gerard
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    পরিচালক
    Hillswood Drive
    Hillswood Business Park
    KT16 0RS Chertsey
    3000
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director87628900001
    DUFFIELD, Stephen Leslie
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    Jacknett Barn
    1820 Warwick Road Knowle
    B93 0DX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishCompany Director24487000002
    ELLSMORE, Mark Anthony
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    পরিচালক
    Moor Cottage
    Eversley Centre
    RG27 0NB Hook
    BritishFinance Director58979090001
    FINDLER, Jonathan Paul
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Westwood House
    Heathfield Avenue
    SL5 0AL Ascot
    Berkshire
    BritishCompany Director45532880003
    JONES, Evan Taylor
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    পরিচালক
    Ash Lea
    Barbon
    LA6 2LW Kirby Lonsdale
    Cumbria
    BritishDirector40267750001
    KAYSER, Michael Arthur
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    পরিচালক
    17 Hartsbourne Avenue
    WD23 1JP Bushey Heath
    Hertfordshire
    United KingdomBritishCompany Director141893610001
    MADELEY, Sydney John, Dr
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    46b Hampton Lane
    B91 2PZ Solihull
    West Midlands
    UkBritishChartered Engineer51063290002
    MARTON, Richard Egerton Christopher
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    পরিচালক
    Capernwray
    6 Kier Park
    SL5 7DS Ascot
    Berkshire
    BritishDirector34653220001
    MCCASLIN, Stuart David, Mr
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    পরিচালক
    Victoria House 27 Victoria Road
    B50 4AS Bidford On Avon
    Warwickshire
    United KingdomBritishChartered Secretary1824650002
    MCCOMASKY, James Anthony
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    123 Old Bath Road
    GL53 7DH Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritishChartered Accountant148271070001
    ROBERTSON, Douglas Grant
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    পরিচালক
    Blackmore Grange
    Blackmore End
    WR8 0EE Hanley Swan
    Worcestershire
    EnglandBritishChartered Accountant123487130001
    RODGERS, Neil Anthony
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    পরিচালক
    Latchmere Green
    Little London
    RG26 5EJ Tadley
    Abbots Dwell
    Hampshire
    Uk
    EnglandBritishGroup Finance Director136538310002
    SELWAY, Mark Wayne
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    পরিচালক
    Flat 5-4
    5 South Frederick Street
    G1 1JG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomAustralianDirector105098120001
    THORNE, Raymond
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    60 Silhill Hall Road
    B91 1JS Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Accountants2756010001
    TURNBULL, Peter
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Much Binding
    Marsh
    HP17 8SS Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant41591930001

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ অক্টো, ২০০৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ নভে, ২০০৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Burdale Financial Limited as Security Trustee for the Finance Parties
    ব্যবসায়
    • ০৭ নভে, ২০০৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৯ ফেব, ২০১২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ ডিসে, ২০০৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Legal mortgage all f/h and l/h property,first fixed charge all the subsidiary shares and investments,all other interests in any f/h or l/h property,the buildings and fixtures (including trade fixtures) on that property,all proceeds of sale derived therefrom. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৬ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৮ জানু, ২০০৯একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security accession deed between the company,seton house group limited (the "parent") and lehman commercial paper inc (the "security agent") supplemental to a debenture dated 4 july 2001
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ আগ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) or any other obligor (as defined) to any secured party (as defined) under any finance document (as defined) on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lehman Commercial Paper Inc.
    ব্যবসায়
    • ৩১ আগ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২১ নভে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Share pledge agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২১ আগ, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ সেপ, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All obligations and liabilities of the chargor and/or any obligor owing to the chargee (the security agent) incurred under or pursuant to the finance documents, in particular incurred under or pursuant to the provisions of clause 17.11 of the senior credit agreement and clause 15.11 of the mezzanine loan agreement
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    A first priority pledge over the pledged assets (as defined) for the payment and discharge of the secured obligations (as defined). See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lehman Commercial Peper Inc.
    ব্যবসায়
    • ১০ সেপ, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ডিসে, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    PAIG OVERSEAS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৮ মে, ২০১৩ভেঙে গেছে
    ১৯ সেপ, ২০১২ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Mark Jeremy Orton
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    অভ্যাসকারী
    Kpmg Llp One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Jeremy Simon Spratt
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    অভ্যাসকারী
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0