ENVOPAK GROUP

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামENVOPAK GROUP
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট আনলিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00596706
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    ENVOPAK GROUP এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    ENVOPAK GROUP কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    ENVOPAK GROUP এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    ENVOPAK LIMITED০৮ জানু, ১৯৫৮০৮ জানু, ১৯৫৮

    ENVOPAK GROUP এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১১

    ENVOPAK GROUP এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বর্তমান হিসাব অর্থবছর বর্ধিত ৩০ নভে, ২০১১ থেকে ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ নভে, ২০১১

    ৩০ নভে, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 2
    SH01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ০৫ নভে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Ola Tricia Aramita Barreto-Morley-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Philip Matthew Deakin-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Edward Ufland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে Giles Hudson-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ০১ অক্টো, ২০০৯ তারিখে S & J Registrars Limited-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH04

    পরিচালক হিসাবে Gavin Udall এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    পরিচালক হিসাবে Ola Tricia Aramita Barreto-Morley-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    পরিচালক হিসাবে Philip Matthew Deakin-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    হিসাব ৩০ নভে, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ নভে, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ নভে, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288c

    ENVOPAK GROUP এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    S & J REGISTRARS LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    Gresham Street
    EC2V 7NG London
    99
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর01740543
    43122090005
    BARRETO-MORLEY, Ola Tricia Aramita
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    পরিচালক
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    EnglandBritish,Portuguese140644240001
    DEAKIN, Philip Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    পরিচালক
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish146225080002
    HUDSON, Giles Matthew
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    পরিচালক
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish161583790001
    UFLAND, Edward
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    পরিচালক
    99 Gresham Street
    London
    EC2V 7NG
    United KingdomBritish87558180001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    সচিব
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    PIPER, Maurice George
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    সচিব
    8 Chestnut Lane
    Matfield
    TN12 7JL Tonbridge
    Kent
    British8141120001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    সচিব
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    WICKETT, Edna May
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    সচিব
    55 Ladbrooke Crescent
    Albany Park
    DA14 4RU Sidcup
    Kent
    British36891520001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    সচিব
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001
    ARTHUR, Frank Henry
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    পরিচালক
    Well Hill Cottage
    Well Hill
    BR6 7RL Chelsfield
    Kent
    EnglandBritish8141130001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    পরিচালক
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BANGLE, Alfred Richard George
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    পরিচালক
    48 Princes Avenue
    Minster On Sea
    ME12 2HJ Isle Of Sheppey
    Kent
    British20981040001
    BLACK, Stephen
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    পরিচালক
    Les Vielles Terres
    Havelet
    GY1 1AZ St Peter Port
    Guernsey
    British73554610001
    CAMERON, Ian Donald
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    পরিচালক
    The Old Rectory
    Peasemore
    RG16 0JH Newbury
    Berkshire
    British13521010001
    HENSHAW, Robert Charles Mayon
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    পরিচালক
    89 Sherbrooke Road
    SW6 7QL London
    British66661330001
    HOLLINGSWORTH, Roger Colin
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    পরিচালক
    97 Copse Avenue
    BR4 9NW West Wickham
    Kent
    British20963700001
    HOULDSWORTH, Raymond
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    পরিচালক
    26 York Road
    Chingford
    E4 8QN London
    British28059370001
    KIRBY, Robert Bernard
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    পরিচালক
    1 Manor House Drive
    Crawford
    WN8 9QZ Upholland
    Lancashire
    EnglandBritish221394890001
    LEWIS, Thomas Arwyn
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    পরিচালক
    35 Clos Glanlliw
    Pontlliw
    SA4 9DW Swansea
    West Glamorgan
    British65122490001
    O'DOHERTY, Jean Crichton
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    পরিচালক
    2g The Glebe
    Blackheath
    SE3 9TT London
    EnglandBritish13964410001
    PILKINGTON, Thomas Henry Milborne Swinnerton, Sir
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    পরিচালক
    Kings Walden
    Bury
    SG4 8JU Hitchin
    Herts
    EnglandBritish5324930001
    PROBERT, Clive Michael Douglas
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    পরিচালক
    Cefn Bryn Cottage
    Penmaen
    SA3 2HQ Swansea
    West Glamorgan
    British10804410001
    REED, Peter John
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    পরিচালক
    116 Woodland Way
    BR4 9LU West Wickham
    Kent
    British21740620001
    UDALL, Gavin
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    পরিচালক
    Summer Lodge
    Romsey Road, Whiteparish
    SP5 2SD Salisbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish83889580001
    UDELHOFEN, Mark James
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    পরিচালক
    771 Revere Road
    Glen Ellyn
    Illinois 60137
    Usa
    American84364350001
    WILLIAMS, Ian Ralph
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    পরিচালক
    Littledown Cottage
    Vernham Dean
    SP11 0EF Andover
    Hampshire
    British19140250001

    ENVOPAK GROUP এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ নভে, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ নভে, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৬ নভে, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জুল, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুল, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/H land & buildings at thorpe industrial estate off crabtree road thorpe egham surrey. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুল, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৭ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ জুন, ১৯৯৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ জুল, ১৯৯৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein to the chargee under the terms of the "security documents" (as defined in the debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ জুল, ১৯৯৫একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৬ জুল, ১৯৯৮বিবৃতি যে একটি ভাসমান চার্জের অংশ বা সম্পূর্ণ সম্পত্তি মুক্তি পেয়েছে (403b)
    • ২৭ সেপ, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০২ মার্চ, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৬ মার্চ, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h property k/as land and buildings at thorpe industrial estate,off crabtree road,thorpe,egham,surrey.t/no.SY624363 together with all buildings and fixtures thereon by way of assignment the goodwill of the business (if any) carried on by the company at the above premises. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৬ মার্চ, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ ফেব, ১৯৯৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ৩১ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ এপ্রি, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Ruxley yard & ruxley office block ruxley, foots cray sidcup kent.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৩ এপ্রি, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ১৬ মার্চ, ১৯৮৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ মার্চ, ১৯৮৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    31 sidcup by pass road, ruxley corner sidcup T.N. sgl 193057. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ মার্চ, ১৯৮৭একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ অক্টো, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land and buildings in the south west side of market place, portland road, south morwood t/n:- sy 53499. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২০ অক্টো, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১৪ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৭০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ জুল, ১৯৭০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    £150,000 due from S.P. gears & instrumentation LTD.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and all property and goodwill & assets present and future including uncalled capital. Land & buildings in powerscroft road, sidcup. Fixed & floating charge (see doc 65 for details).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Charente Steamship Co LTD
    ব্যবসায়
    • ২৯ জুল, ১৯৭০একটি চার্জের নিবন্ধন
    Charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুন, ১৯৬৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ জুন, ১৯৬৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    5 and 7 powerscraft rd., And land adjoining, foots gray, sidcup, london borough of bexley.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ জুন, ১৯৬৮একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Single debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জানু, ১৯৬৫
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ১৯৬৫
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys due etc
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Properties mentioned in schedule to the debenture, all other f/h & l/h property present & future & all fixtures plants & machinery the goodwill & uncalled capital present & future floating charge on undertaking & all other property & assets present & future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ১৯৬৫একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৮ ডিসে, ১৯৯৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0