NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামNUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00634498
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • ভবন নির্মাণ প্রকল্প উন্নয়ন (41100) / নির্মাণ

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৫

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01
    A6AY8Y28

    একজন পরিচালকের পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01
    X5KWM4W8

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে Philip John Martin এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02
    X5KRAXQE

    ৩১ অক্টো, ২০১৬ তারিখে সচিব হিসাবে British Land Company Secretarial Limited-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP04
    X5KRADDN

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    L5F1B8BV

    ১৩ জুল, ২০১৬ তারিখে আপডেট সহ নিশ্চয়তা বিবৃতি

    5 পৃষ্ঠাCS01
    X5EXIWIX

    ১৩ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Charles John Middleton-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X5CJBJUX

    ১৩ জুল, ২০১৬ তারিখে পরিচালক হিসাবে Jonathan Charles Mcnuff-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01
    X5BNY2NU

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    A4HY9GV5

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ জুল, ২০১৫ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital২৯ জুল, ২০১৫

    ২৯ জুল, ২০১৫ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500
    SH01
    X4COY4Z4

    ০৯ অক্টো, ২০১৪ তারিখে Mrs Lucinda Margaret Bell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X3J6GE0B

    অডিট ছাড় সহায়ক হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি

    16 পৃষ্ঠাAA
    A3IOBPAX

    legacy

    184 পৃষ্ঠাPARENT_ACC
    A3HJQDDN

    legacy

    1 পৃষ্ঠাAGREEMENT2
    A3HJQDFF

    legacy

    3 পৃষ্ঠাGUARANTEE2
    A3HJ8ZY0

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ জুল, ২০১৪ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৪ জুল, ২০১৪

    ১৪ জুল, ২০১৪ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 500
    SH01
    X3C3VU6W

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    A2HPN2S0

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ জুল, ২০১৩ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital৩০ জুল, ২০১৩

    ৩০ জুল, ২০১৩ তারিখে শেয়ার বরাদ্দ অনুসারে মূলধনের বিবরণ

    SH01
    X2DPB4VE

    ৩০ জুল, ২০১৩ তারিখে Mr Philip John Martin-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03
    X2DPB4UY

    ৩০ জুল, ২০১৩ তারিখে Lucinda Margaret Bell-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01
    X2DPB4V6

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    A1IF8ATF

    বার্ষিক রিটার্ন ১৩ জুল, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    4 পৃষ্ঠাAR01
    X1DBAXC8

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩১ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA
    A5PA5XXD

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    কর্পোরেট সচিব
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    পরিচয়পত্রের ধরনইইএ
    নিবন্ধন নম্বর8992198
    187856670001
    BELL, Lucinda Margaret
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    পরিচালক
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    পরিচালক
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    MARTIN, Philip John
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    সচিব
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    British35118050001
    WILSON, Michael Anthony
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    সচিব
    4 Alleyn Road
    SE21 8AL London
    British68971270001
    BERESFORD, Valentine Tristram
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    পরিচালক
    3 Smith Terrace
    SW3 4DL London
    EnglandBritishCompany Director40766290003
    CLARKE, Peter Courtenay
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    পরিচালক
    Oakmeade
    Park Road
    SL2 4PG Stoke Poges
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Secretary78691990003
    CLUTTON, Rodney
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    পরিচালক
    Grange Farm
    CV23 8DJ Grandborough
    Warwickshire
    BritishDirector4388360001
    DOYLE, Eugene Francis
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    পরিচালক
    2 Gombards
    AL3 5NW St. Albans
    Hertfordshire
    United KingdomIrishChartered Surveyor73961570001
    JONES, Andrew Marc
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    পরিচালক
    Hazlewell Road
    Putney
    SW15 6LH London
    2
    EnglandBritishCompany Director82020730004
    MCGANN, Martin Francis
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    পরিচালক
    10 Westcombe Park Road
    SE3 7RB Blackheath
    London
    BritishChartered Accountant109383240001
    NETTLETON, John Dering
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Newington House
    OX10 7AG Warborough
    Oxfordshire
    EnglandEnglishDirector1866530002
    PRICE, Humphrey James Montgomery
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    পরিচালক
    Deaks
    Deaks Lane
    RH17 5JA Cuckfield
    West Sussex
    UkBritishChartered Accountant14448630001
    STIRLING, Mark Andrew
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Great Oak House
    Essendon Place, Essendon
    AL9 6GZ Hatfield
    Hertfordshire
    United KingdomBritishSurveyor106882210001
    VAUGHAN, Patrick Lionel
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    পরিচালক
    June Farm
    Trumpet Hill Road
    RH2 8QY Reigate
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director73972350001
    WATES, Paul Christopher Ronald
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    পরিচালক
    Bellasis House
    Headley Heath Approach Mickleham
    RH5 6DH Dorking
    Surrey
    EnglandBritishDirector2119440001

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Wates City Of London Properties Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    না
    আইনি ফর্মPrivate Company Limited By Shares
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষCompanies Act 2006
    নিবন্ধিত স্থানUnited Kingdom Companies Registry
    নিবন্ধন নম্বর1788526
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    NUMBER 80 CHEAPSIDE LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Mortgage of shares
    তৈরি করা হয়েছে ২৩ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to deutsche pfandbrief- und hypothekenbank aktiengesellschaft (the "agent") and the finance parties (as defined) or any of them under each finance document (as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The issued share capital in qsl and all interest in the shares and related rights see form 395 for full details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Pfandbrief-Un Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of shares
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ ডিসে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee under each of the finance documents (as therein defined) to which such obligor is a party except for any obligation which, if it were so included, would result in the mortgage of shares contravening S151 of the companies act 1 985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares: the issued share capital of number 90 queen street limited and all dividends thereon. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Deutsche Pfandbrief- Und Hypothekenbank Aktiengesellschaft
    ব্যবসায়
    • ২৪ ডিসে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৬ অক্টো, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties (or any of them) under each of the finance documents to which the obligor is a party except for any obligation which,if it were so included, would result in the chargor debenture contravening section 151 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage of shares
    তৈরি করা হয়েছে ১৮ এপ্রি, ১৯৯৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever of each obligor to the finance parties under each finance document except for any obligation which, if it were so included, would result in this charge contravening section 151 of the companies act 1985
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All shares held by the chargor and/or any nominee in its behalf and all related rights and first fixed charge the chargor's interest in all the shares and all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Midland Bank Plcas Agent and Trustee for the Finance Parties (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০১ নভে, ২০০০একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ জানু, ১৯৯৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৩ ফেব, ১৯৯৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee as agent and trustee for itself and each other finance party under the terms of each of the finance documents (as defined) to which such obligor is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Samuel Montagu & Co. Limitedas Agent and Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৩ ফেব, ১৯৯৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৮ এপ্রি, ১৯৯৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0