HMV CARD SERVICES LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHMV CARD SERVICES LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00635858
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HMV CARD SERVICES LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • নন-ট্রেডিং কোম্পানি নন ট্রেডিং (74990) / পেশাদার, বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত কার্যক্রম

    HMV CARD SERVICES LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Windsor House
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HMV CARD SERVICES LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    HMV SHOPS LIMITED১২ মে, ১৯৮৬১২ মে, ১৯৮৬
    RADIO RENTALS THAMESDOWN CABLE LIMITED১৭ জুন, ১৯৮৩১৭ জুন, ১৯৮৩
    CLEARVISION,LIMITED২৭ আগ, ১৯৫৯২৭ আগ, ১৯৫৯

    HMV CARD SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে২৮ এপ্রি, ২০১২

    HMV CARD SERVICES LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    বাধ্যতামূলক বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1

    ৩১ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Peter Kenyon এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ০৮ ফেব, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Trevor Philip Moore এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৪ জানু, ২০১৩ তারিখে পরিচালক হিসাবে Elaine Marriner এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    ২৪ জানু, ২০১৩ তারিখে সচিব হিসাবে Elaine Marriner এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM02

    ০৩ সেপ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Ian Peter Kenyon-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ সেপ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Mr Trevor Philip Moore-এর নিয়োগ

    2 পৃষ্ঠাAP01

    ০৩ সেপ, ২০১২ তারিখে পরিচালক হিসাবে Simon Richard Fox এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৮ এপ্রি, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ মে, ২০১২ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১১ মে, ২০১২

    ১১ মে, ২০১২ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 85,570
    SH01

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ এপ্রি, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    3 পৃষ্ঠাAR01

    পরিচালক হিসাবে Neil Bright এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৪ এপ্রি, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১০ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    5 পৃষ্ঠাAR01

    ১০ মে, ২০১০ তারিখে Elaine Marriner-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    ১০ মে, ২০১০ তারিখে Mr Simon Richard Fox-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১০ মে, ২০১০ তারিখে Elaine Marriner-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১০ মে, ২০১০ তারিখে Neil Irvine Bright-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    13 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ২৫ এপ্রি, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    HMV CARD SERVICES LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    BRIGHT, Neil Irvine
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    সচিব
    Pound End
    Cedar Drive, Cookham
    SL6 9DZ Maidenhead
    Berkshire
    British180993450001
    CAMPBELL, Laurence James
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    সচিব
    Mellbreak Dell Grove
    Frimley
    GU16 5PZ Camberley
    Surrey
    British27960300001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    সচিব
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    British62634010001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    সচিব
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    British76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    সচিব
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    British40470020001
    RITCHIE, Ian
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    সচিব
    66 Cherwell Drive
    Marston
    OX3 0LZ Oxford
    Oxfordshire
    British68246050001
    SMITH, George Marsden
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    সচিব
    18 Bevin Square
    SW17 7BB London
    British15729150003
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    সচিব
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    British63502600001
    BELL, Duncan Charles
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    পরিচালক
    Longwood
    Queen Annes Road
    SL4 2BJ Windsor
    Berkshire
    British9950440002
    BRIGHT, Neil Irvine
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    পরিচালক
    Shelley House, 2-4 York Road
    Maidenhead
    SL6 1SR Berkshire
    United KingdomBritish180993450001
    FOX, Simon Richard
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish58101280002
    GILES, Alan James
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Tanglewood
    Crowsley Road
    RG9 3LE Shiplake
    Oxfordshire
    EnglandBritish156046020001
    HOWELL, Peter Graham
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    পরিচালক
    76 Kings Road
    SW19 8QW London
    UkBritish62634010001
    KENYON, Ian Peter
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish107735600001
    LYMATH, Michael Gerald
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    পরিচালক
    Windsor Cottage
    Temple Park Farm
    SL6 5LT Hurley
    Berkshire
    EnglandBritish76768320001
    MARRINER, Elaine
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish40470020001
    MCALLISTER, Stuart
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    পরিচালক
    The Granary 38 Wellington Street
    OX9 3BN Thame
    Oxfordshire
    British9406880001
    MOORE, Trevor Philip
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    পরিচালক
    Spittal Street
    SL7 3HJ Marlow
    Windsor House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish113047410001
    TOMBLIN, Denise Lynne
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    20 Bell Crescent
    Longwick
    HP27 9SE Princes Risborough
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish63502600001

    HMV CARD SERVICES LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ জুন, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Chase Manhattan Bank,as Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ০৪ জুন, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998)
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Emi Group PLC (As Security Agent for Itself and Emi Group Finance PLC)
    ব্যবসায়
    • ১৫ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Emi Group PLC (As Security Trustee for Itself and Emi Group Finance PLC)
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ মার্চ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Swiss Bank Corporation as "Security Agent"Which Expression Shall Include Any Person for the Time Being Appointed as Security Trustee or as an Additional Trustee for the Purpose of, and in Accordance with, the Senior Facility Agreement
    ব্যবসায়
    • ০৯ এপ্রি, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৬ নভে, ২০০২একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0