TERMINUS 28 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামTERMINUS 28 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00654475
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেনা
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    TERMINUS 28 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (2222) /

    TERMINUS 28 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    1 Apex Business Centre
    Boscombe Road
    LU5 4SB Dunstable
    Bedfordshire
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    TERMINUS 28 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    POLESTAR CORPORATE PRINT LIMITED০৬ নভে, ১৯৯৮০৬ নভে, ১৯৯৮
    WATMOUGHS CORPORATE PRINT LIMITED১৫ জানু, ১৯৯৬১৫ জানু, ১৯৯৬
    WATMOUGHS FINANCIAL PRINT LIMITED১৮ নভে, ১৯৮৭১৮ নভে, ১৯৮৭
    ENGRAVERS (HULL) LIMITED২৯ মার্চ, ১৯৬০২৯ মার্চ, ১৯৬০

    TERMINUS 28 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০০৯

    TERMINUS 28 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত গেজেট ভেঙে দেওয়া হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাGAZ2(A)

    স্বেচ্ছায় বাদ দেওয়ার জন্য প্রথম গেজেট বিজ্ঞপ্তি

    1 পৃষ্ঠাGAZ1(A)

    কোম্পানিকে রেজিস্টার থেকে বাদ দেওয়ার আবেদন

    3 পৃষ্ঠাDS01

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১১ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    7 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১৩ জুল, ২০১১

    ১৩ জুল, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,650,000
    SH01

    নাম পরিবর্তনের শংসাপত্র

    Company name changed polestar corporate print LIMITED\certificate issued on 12/05/11
    3 পৃষ্ঠাCERTNM
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    change-of-name

    নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত রেজুলেশন ১০ মে, ২০১১

    RES15

    নাম পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি

    2 পৃষ্ঠাCONNOT

    বার্ষিক রিটার্ন ৩১ মে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    ৩১ জুল, ২০০৯ তারিখে Alan Goodwin-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    legacy

    4 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    8 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা287

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288a

    legacy

    1 পৃষ্ঠা288b

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৬ পর্যন্ত তৈরি

    6 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    4 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের স্মারকলিপি এবং/অথবা নিবন্ধের রেজুলেশন

    RES01

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৫ পর্যন্ত তৈরি

    14 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    1 পৃষ্ঠা225

    পূর্ণ হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৪ পর্যন্ত তৈরি

    17 পৃষ্ঠাAA

    TERMINUS 28 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    GOODWIN, Alan
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    সচিব
    Ensign House
    Juniper Drive
    SW18 1TR London
    104
    BritishCompany Secretary98921850001
    GOODWIN, Alan
    Friars Cottage
    Bucks Hill
    WD4 9BR Kings Langley
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Friars Cottage
    Bucks Hill
    WD4 9BR Kings Langley
    Hertfordshire
    BritishCompany Secretary98921850001
    HEARN, Catherine Ann
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    White Gate House
    Ellesborough Road
    HP22 6ES Wendover
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishGroup Hr Director83713930001
    HIBBERT, Barry Alan
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    পরিচালক
    River Steps
    Gibraltar Lane
    SL6 9TR Cookham Dean
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Executive Officer68122470005
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    পরিচালক
    Peters Lane
    HP27 OLQ Whiteleaf
    Tanglewood
    Bucks
    EnglandBritishFinance Director138015860001
    BREWSTER, Philip Thomas
    37 Barncroft Rise
    Seacroft
    LS14 1AU Leeds
    West Yorkshire
    সচিব
    37 Barncroft Rise
    Seacroft
    LS14 1AU Leeds
    West Yorkshire
    British40485070002
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    সচিব
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    British987230001
    HAINSWORTH, Paul
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    সচিব
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    BritishFianance Director84514980001
    SCOTLAND, Alister Henry
    4 Green Acre Close
    Baildon
    BD17 6JD Shipley
    West Yorkshire
    সচিব
    4 Green Acre Close
    Baildon
    BD17 6JD Shipley
    West Yorkshire
    British10003860001
    BEALES, Graham
    Holly Lodge
    6a Chestnut Avenue
    LS22 6SG Wetherby
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Holly Lodge
    6a Chestnut Avenue
    LS22 6SG Wetherby
    West Yorkshire
    EnglandBritishManaging Director Corporate Pr70776860002
    BRIDGES, Clive
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    334 Wendover Road
    Weston Turville
    HP22 5TN Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishChartered Accountant987230001
    BROWN, Frederick James
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    পরিচালক
    61 Handside Lane
    AL8 6SH Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    BritishChief Executive Officer16105360002
    BURN, David Frederick
    Upper Kingston Farm
    Banbury Road
    CV35 0AE Lighthorne
    Warwickshire
    পরিচালক
    Upper Kingston Farm
    Banbury Road
    CV35 0AE Lighthorne
    Warwickshire
    BritishChairman9908690001
    CAWOOD, Colin
    96 Westfield Lane
    Idle
    BD10 8UQ Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    96 Westfield Lane
    Idle
    BD10 8UQ Bradford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director19432900001
    COVENEY, Michael John
    1 Dene Bank
    Lady Lane
    BD16 4AR Bingley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    1 Dene Bank
    Lady Lane
    BD16 4AR Bingley
    West Yorkshire
    BritishEngineer43212720001
    COWGILL, William Charles
    12 Overdale Drive
    Thackley
    BD10 0AN Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    12 Overdale Drive
    Thackley
    BD10 0AN Bradford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director6431280001
    CROSSLAND, Ernest
    The Nook,
    Tingley Common, Morley
    LS27 0HE Leeds
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Nook,
    Tingley Common, Morley
    LS27 0HE Leeds
    West Yorkshire
    BritishManaging Director70694800001
    FROBISHER, Graham
    116 Cottingham Road
    NN17 1SY Corby
    Northamptonshire
    পরিচালক
    116 Cottingham Road
    NN17 1SY Corby
    Northamptonshire
    BritishManager43497340001
    FURNESS, Victor George
    7 Millbeck Drive
    Harden
    BD16 1TF Bingley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    7 Millbeck Drive
    Harden
    BD16 1TF Bingley
    West Yorkshire
    BritishLithographer56819660002
    GANNAWAY, Michael John
    1 Dene Bank
    Lady Lane
    BD16 4AR Bingley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    1 Dene Bank
    Lady Lane
    BD16 4AR Bingley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director9797890002
    HAINSWORTH, Paul
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    পরিচালক
    28 Oakleigh View
    Baildon
    BD17 5TP Shipley
    Yorkshire
    BritishFianance Director84514980001
    HOOK, Geofrey
    2 The Fennings
    Chesham Bois
    HP6 5LE Amersham
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    2 The Fennings
    Chesham Bois
    HP6 5LE Amersham
    Buckinghamshire
    BritishCompany Director28603540001
    JOHNSTON, Peter Douglas
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    পরিচালক
    Flat 3
    76 Carter Lane
    EC4V 5EA London
    BritishGroup Finance Director83714120001
    KEIGHLEY, Neville Anthony
    25 Brackendale Grove
    Thackley
    BD10 0TS Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    25 Brackendale Grove
    Thackley
    BD10 0TS Bradford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director10003870001
    LE MARE, Robert Hugh
    Porch House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5PJ Harrogate
    North Yorkshire
    পরিচালক
    Porch House Farm
    Pateley Bridge
    HG3 5PJ Harrogate
    North Yorkshire
    BritishCompany Director10127830001
    MAUGHAN, Colin
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    The Grange Moorhead Crescent
    BD18 4LQ Shipley
    West Yorkshire
    BritishDeputy Chairman2000880001
    MORTER, William Henry
    12 Wisteria Way
    PE10 9SY Bourne
    Lincolnshire
    পরিচালক
    12 Wisteria Way
    PE10 9SY Bourne
    Lincolnshire
    BritishCompany Director28603560001
    NEWMAN, James Henry
    23 Park Drive
    Hale
    WA15 9DJ Altrincham
    Cheshire
    পরিচালক
    23 Park Drive
    Hale
    WA15 9DJ Altrincham
    Cheshire
    BritishCompany Director6036000001
    ROBERTSON, Malcolm Murray
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    পরিচালক
    Mardale 85 Harmer Green Lane
    Digswell
    AL6 0ER Welwyn
    Hertfordshire
    United KingdomBritishFinance Director39155140002
    ROWLAND, Nigel Shaun
    29 Sanger Drive
    Send
    GU23 7EU Woking
    Surrey
    England
    পরিচালক
    29 Sanger Drive
    Send
    GU23 7EU Woking
    Surrey
    England
    BritishSales Director34675510001
    RUDSTON, Anthony
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Minstrels Barn
    Henton
    OX9 4AE Chinnor
    Oxfordshire
    EnglandBritishChief Executive Officer44908110001
    SALTER, Declan John
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    পরিচালক
    Woodcote
    Burtons Lane
    HP8 4BA Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector67413330001
    SCOTLAND, Alister Henry
    4 Green Acre Close
    Baildon
    BD17 6JD Shipley
    West Yorkshire
    পরিচালক
    4 Green Acre Close
    Baildon
    BD17 6JD Shipley
    West Yorkshire
    BritishCompany Director10003860001
    TIMMINS, Richard Keith
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    পরিচালক
    3 Maxey View
    Deeping Gate
    PE6 9BE Peterborough
    United KingdomBritishDirector127238050003
    WALKER, Patrick Granville
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Plumpton House Mitchell Lane Thackley
    BD10 0TA Bradford
    West Yorkshire
    BritishDirector23217500001

    TERMINUS 28 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Restated amendment to the supplemental deed to a composite guarantee and debenture dated 19 june 1998 and dated 4 september 1998
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ অক্টো, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ নভে, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company, each other company and/or corporation to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P. Morgan Europe Limited (Formerly Chase Manhattan International Limited) as Security Trusteefor Itself and the Other Secured Parties or Such Other Person as May from Time to Time Be Appointed Security Trustee
    ব্যবসায়
    • ১০ নভে, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A composite guarantee and debenture between polestar,the polestar corporation PLC,certain subsidiaries of polestar and J.P.morgan europe limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৮ জানু, ২০০২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৫ ফেব, ২০০২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All moneys and liabilities due or to become due from the company to the secured parties or any of them under or pursuant to the finance documents (as defined) and under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Including (I) unit B5 blenheim industrial park estate,bury st.edmunds,suffolk; (ii) unit 14 luton stadium estate,craddock rd,luton,bedfordshire; bd 77546; (iii) wigman rd,aspley,nottingham; NT78782 and NT180765; see form 395 for details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • J.P.Morgan Europe Limited,as Security Trustee for the Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৫ ফেব, ২০০২একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    A composite guarantee and debenture between the chargor, the polestar corporation PLC, certain subsidiaries of the chargor and chase manhattan international limited
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ নভে, ২০০১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee for Itself and Investcorp Fundinglimited)
    ব্যবসায়
    • ১৪ নভে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Supplemental deed (supplemental to a composite guarantee & debenture dated 19 june 1998)
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৪ সেপ, ১৯৯৮
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other watmoughs UK charging subsidiary (as therein defined) to the secured parties or any of them including all monies due under or pursuant to the finance documents (as defined) and/or the deed
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Chase Manhattan International Limited(As Security Agent and Trustee for the Secured Parties)
    ব্যবসায়
    • ২৪ সেপ, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0