BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামBARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00655064
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • (7499) /

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    Firth House
    Meadowhall Road
    644
    S9 1JD Sheffield
    South Yorkshire
    England
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    FIRTH RIXSON SPECIAL STEELS LIMITED২৫ সেপ, ১৯৯৮২৫ সেপ, ১৯৯৮
    BARWORTH FLOCKTON LIMITED০১ এপ্রি, ১৯৬০০১ এপ্রি, ১৯৬০

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩০ সেপ, ২০১০

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    সদস্যদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    5 পৃষ্ঠা4.71

    legacy

    3 পৃষ্ঠাMG02

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    1 পৃষ্ঠা600

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    1 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    liquidation

    লিকুইডেশনের জন্য বিশেষ রেজোলিউশন ০৬ ডিসে, ২০১১ তারিখে

    LRESSP

    দ্রাবকতার ঘোষণাপত্র

    3 পৃষ্ঠা4.70

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    পরিচালক হিসাবে James Hart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM01

    সচিব হিসাবে Christopher David Seymour-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP03

    সচিব হিসাবে James Hart এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    পরিচালক হিসাবে Christopher David Seymour-এর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAP01

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ ডিসে, ২০১০ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01
    সম্পর্কিত ফাইলিংস
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    capital১০ জানু, ২০১১

    ১০ জানু, ২০১১ তারিখে মূলধনের বিবরণ

    • মূলধন: GBP 1,000,000
    SH01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD04

    change-registered-office-address-company-with-date-old-address

    1 পৃষ্ঠাAD01

    নিষ্ক্রিয় কোম্পানির জন্য হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি

    2 পৃষ্ঠাAA

    বার্ষিক রিটার্ন ১৭ ডিসে, ২০০৯ পর্যন্ত তৈরি শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ তালিকা সহ

    6 পৃষ্ঠাAR01

    রেজিস্টার(গুলি) নিবন্ধিত পরিদর্শন স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD03

    রেজিস্টার পরিদর্শন ঠিকানা পরিবর্তন করা হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাAD02

    ১৭ ডিসে, ২০০৯ তারিখে James Thomas Hart-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৭ ডিসে, ২০০৯ তারিখে Peter Simon Bland-এর জন্য পরিচালকের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাCH01

    ১৭ ডিসে, ২০০৯ তারিখে James Thomas Hart-এর জন্য সচিবের বিবরণ পরিবর্তন হয়েছে

    1 পৃষ্ঠাCH03

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৮ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    legacy

    3 পৃষ্ঠা363a

    হিসাব ৩০ সেপ, ২০০৭ পর্যন্ত তৈরি

    3 পৃষ্ঠাAA

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    SEYMOUR, Christopher David
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    সচিব
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    British158367200001
    BLAND, Peter Simon
    Meadowhall Road
    Pobox 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    পরিচালক
    Meadowhall Road
    Pobox 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant42351130005
    SEYMOUR, Christopher David
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    পরিচালক
    Meadowhall Road
    PO BOX 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    EnglandBritishChartered Accountant158310680001
    ATKINSON, Mandy Elizabeth
    16 Church Lane
    Warmsworth
    DN4 9NS Doncaster
    South Yorkshire
    সচিব
    16 Church Lane
    Warmsworth
    DN4 9NS Doncaster
    South Yorkshire
    British56543190001
    BRIGGS, Anthony John
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    সচিব
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    British3305550001
    GIBBONS, Michael Andrew
    9 Garth Way
    S18 1RL Dronfield
    Derbyshire
    সচিব
    9 Garth Way
    S18 1RL Dronfield
    Derbyshire
    British60763380001
    HART, James Thomas
    Meadowhall Road
    Pobox 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    সচিব
    Meadowhall Road
    Pobox 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    BritishChartered Accountant115557140002
    KEIGHLEY, Richard Nicholas
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    সচিব
    Main Street
    Saxby-All-Saints
    DN20 0QB Brigg
    Park View 48
    North Lincolnshire
    British137305900001
    AINSWORTH, Sydney
    Highway Derwent Lane
    Hathersage Hope Valley
    S32 1AS Sheffield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Highway Derwent Lane
    Hathersage Hope Valley
    S32 1AS Sheffield
    Derbyshire
    BritishEngineer56543130001
    APPLEBY, Herbert
    12 Woodvale Road
    S10 3EX Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    12 Woodvale Road
    S10 3EX Sheffield
    South Yorkshire
    BritishSolicitor3386660001
    BERGIN, John Charles Michael Francis
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    পরিচালক
    24 Northgate
    Tickhill
    DN11 9HY Doncaster
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector12452990001
    BRIGGS, Anthony John
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    115 Townhead Road
    Dore
    S17 3AQ Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Secretary3305550001
    EDWARDS, John Richard
    65 Carsick Hill Crescent
    S10 3LS Sheffield
    পরিচালক
    65 Carsick Hill Crescent
    S10 3LS Sheffield
    EnglandBritishDirector21666370002
    EDWARDS, Peter David
    The Cottage Moorlands
    Frogatt Hope Valley
    S1 2GA Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    The Cottage Moorlands
    Frogatt Hope Valley
    S1 2GA Sheffield
    South Yorkshire
    BritishCompany Director75195470001
    EDWARDS, Walter Noel
    46 Stumperlowe Park Road
    S10 3QP Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    46 Stumperlowe Park Road
    S10 3QP Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishDirector3305570001
    FLETCHER, Douglas Leslie
    143 High Storrs Road
    S11 7LG Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    143 High Storrs Road
    S11 7LG Sheffield
    South Yorkshire
    BritishChartered Accountant3526330001
    HALL, David John
    Craglands
    Ashopton Road, Bamford
    S33 0DB Hope Valley
    Derbyshire
    পরিচালক
    Craglands
    Ashopton Road, Bamford
    S33 0DB Hope Valley
    Derbyshire
    BritishCompany Director40070600001
    HART, James Thomas
    Meadowhall Road
    Pobox 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    পরিচালক
    Meadowhall Road
    Pobox 644
    S9 1JD Sheffield
    Firth House
    South Yorkshire
    England
    United KingdomBritishChartered Accountant115557140002
    HULLEY, Reginald
    17 Robin Hood Chase
    Stannington
    S6 6FH Sheffield
    পরিচালক
    17 Robin Hood Chase
    Stannington
    S6 6FH Sheffield
    BritishSteel Manufacturer3314600001
    KIRKHAM, Philip David
    Lime Spinney Somersall Close
    Somersall
    S40 3SG Chesterfield
    Derbyshire
    পরিচালক
    Lime Spinney Somersall Close
    Somersall
    S40 3SG Chesterfield
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector & General Manager13484340002
    MACDONALD, Neil Andrew
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    পরিচালক
    21 Clarendon Road
    S10 3TQ Sheffield
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director3696630003
    WRAGG, David
    10 Kirk Edge Drive
    Worrall
    S35 0AZ Sheffield
    পরিচালক
    10 Kirk Edge Drive
    Worrall
    S35 0AZ Sheffield
    BritishManaging Director21666380002

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    Security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ২০ ডিসে, ২০০৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৯ ডিসে, ২০০৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    The f/h land and premises at johnson lane ecclesfield t/n's SYK272351 SYK392864, fixed and floating charges over all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures plant and machinery,. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lehman Brothers International (Europe) (Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২৯ ডিসে, ২০০৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৮ ডিসে, ২০১১একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৭ সেপ, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২০ সেপ, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and premises at johnson lane t/. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lehman Brothers International (Europe), as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (the Security Agent)
    ব্যবসায়
    • ২০ সেপ, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১১ ফেব, ২০০৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ৩০ সেপ, ২০০৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All key properties together with all buildings and fixtures,all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০২ অক্টো, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Security accession deed
    তৈরি করা হয়েছে ২১ ফেব, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ ফেব, ২০০৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All money or liabilities due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge over freehold land and premises at johnson lane,ecclesfield (no 12); site 1 - SYK272351,site 2 - SYK392864,site 3 - SYK50024;all buildings and fixtures thereon and by way of first equitable charge over all subsidiary shares,investments and all distribution rights and all freehold/leasehold property not charged pursuant to clause 2.3(a) of the deed; all book debts,rights and claims,all monetary claims and monies standing to the credit of its accounts; the goodwill and uncalled capital; floating charge over all assets; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland,London,as Security Trustee for Itself and Theother Secured Parties
    ব্যবসায়
    • ২৭ ফেব, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ অক্টো, ২০০৪একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Three parcels of f/h land situate on the northern and southern sides of matlock lane sheffield south yorkshire fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings on the south side of black lane, bradfield, sheffield south yorkshire title no syk 7292 fixed charge over all movable plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ১০ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings on south and the east sides of tanfield road sheffield south yorkshire title no ywe 13577 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ডিসে, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ডিসে, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H 2 minerva road ealing l b of ealing greater london title no ngl 413778 fixed charge over all plant machinery implements utensils furniture and equipment fixtures and fittings.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    ব্যবসায়
    • ০৮ ডিসে, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Supplemental debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ এপ্রি, ১৯৮৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ এপ্রি, ১৯৮৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge on all the bookdebts and other debts of the company both present and future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams and Glyn's Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৭ এপ্রি, ১৯৮৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ জুল, ১৯৮০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুল, ১৯৮০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    L/Hold factory premises and offices 2 minerva road london together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined in section 5 of the bills of sale act 1878 fixed and movable plant machinery fixtures implements and utensils.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams and Glyn's Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুল, ১৯৮০একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Collateral mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ সেপ, ১৯৭৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১১ সেপ, ১৯৭৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from barworth holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge on f/h land on south side of johnson lane, ecclesfield, sheffield with works and offices thereon together with all buildings & all fixtures fixed & plant & machinery present & future.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    ব্যবসায়
    • ১১ সেপ, ১৯৭৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৭৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ সেপ, ১৯৭৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Undertaking and goodwill all property and assets present and future including uncalled capital fixed plant etc fixed and floating charge (see doc 32).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Williams & Glyns Bank LTD
    ব্যবসায়
    • ২৭ সেপ, ১৯৭৪একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Legal mortgage
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ জানু, ১৯৬৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৮ ফেব, ১৯৬৩
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    For further securing all moneys due from barworth holdings limited to williams deacons bank limited secured by a charge dated 31/10/60
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Land on the south side of johnson lane, ecclesfield, york with factory outbuildings and offices known as "barworth steel works".
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Mosley Street Nominees LTD
    ব্যবসায়
    • ০৮ ফেব, ১৯৬৩একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৫ ফেব, ১৯৯৮একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    BARWORTH FORGED PRODUCTS LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৩ ডিসে, ২০১২ভেঙে গেছে
    ০৬ ডিসে, ২০১১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    অভ্যাসকারী
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Benson House
    LS1 4JP 33 Wellington Street
    Leeds
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    অভ্যাসকারী
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0