HCSU29 LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামHCSU29 LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিবাতিল
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00658368
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ
    বন্ধের তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    HCSU29 LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • অ-বিশেষায়িত পাইকারি বাণিজ্য (46900) / হোলসেল এবং খুচরা বিক্রয়; মোটর গাড়ি এবং মোটরসাইকেল মেরামত

    HCSU29 LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    HCSU29 LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    UNIPART SERVICE COMPANY LIMITED০৩ অক্টো, ২০১১০৩ অক্টো, ২০১১
    UNIPART AUTOMOTIVE LIMITED৩০ এপ্রি, ২০০৪৩০ এপ্রি, ২০০৪
    PARTCO LIMITED০১ অক্টো, ১৯৯৫০১ অক্টো, ১৯৯৫
    PARTCO AUTOPARTS LIMITED০১ জানু, ১৯৯০০১ জানু, ১৯৯০
    PARTCO LIMITED০৬ মে, ১৯৬০০৬ মে, ১৯৬০

    HCSU29 LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ ডিসে, ২০১৩

    HCSU29 LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    দ্রবীভূতকরণের পরে ভেঙে দেওয়া চূড়ান্ত গেজেট

    1 পৃষ্ঠাGAZ2

    ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছায় উইন্ডিং আপে চূড়ান্ত মিটিংয়ের রিটার্ন

    21 পৃষ্ঠাLIQ14

    ১৮ মার্চ, ২০২১ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    19 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ মার্চ, ২০২০ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    18 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    15 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    16 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    14 পৃষ্ঠা4.68

    ১৮ মার্চ, ২০১৬ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    13 পৃষ্ঠা4.68

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    কোম্পানি নিবন্ধকের নোটিশ দাবিত্যাগের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাF10.2

    HCSU29 LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    RIMMER, Michael Douglas
    32 Watling Lane
    Dorchester On Thames
    OX10 7JG Wallingford
    Oxfordshire
    সচিব
    32 Watling Lane
    Dorchester On Thames
    OX10 7JG Wallingford
    Oxfordshire
    British48355360001
    BURKE, Carol
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    পরিচালক
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritishManaging Director118908550001
    DESSAIN, Paul Mark
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    10 High Street
    Bodicote
    OX15 4BX Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishAccountant17182840001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    সচিব
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    British94183390001
    STAMP, Christopher David
    49 Grange Road
    Dorridge
    B93 8QS Solihull
    West Midlands
    সচিব
    49 Grange Road
    Dorridge
    B93 8QS Solihull
    West Midlands
    British44492580001
    ANDERSON, Richard Kevin George
    Clare House
    Halse
    NN13 6DY Brackley
    Northants
    পরিচালক
    Clare House
    Halse
    NN13 6DY Brackley
    Northants
    BritishMarketing Director30163970002
    BECK, Anthony John
    51 Sunnyside Lane
    CV7 7FY Balsall Common
    West Midlands
    পরিচালক
    51 Sunnyside Lane
    CV7 7FY Balsall Common
    West Midlands
    BritishLogistics Director49316240001
    BURNS, Frank William
    Four Oaks
    B74 4UE Sutton Coldfield
    30 Sandhurst Road
    West Midlands
    England
    পরিচালক
    Four Oaks
    B74 4UE Sutton Coldfield
    30 Sandhurst Road
    West Midlands
    England
    United KingdomBritishDirector26675550001
    DEWAR, John Henderson
    Rooks Rest 21b Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    Rooks Rest 21b Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishDirector76669730002
    DEWAR, John Henderson
    Rooks Rest 21b Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    Rooks Rest 21b Clarendon Square
    CV32 5QT Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishOperations Director76669730002
    ETHERINGTON, Christopher
    Forge House
    Selborne Road Greatham
    GU33 6HG Liss
    Hampshire
    পরিচালক
    Forge House
    Selborne Road Greatham
    GU33 6HG Liss
    Hampshire
    BritishManaging Director120039720001
    FORMAN, Paul Anthony
    Millfield
    Coln St Aldwyns Post Office
    GL7 5AN Cirencester
    Gloucestershire
    পরিচালক
    Millfield
    Coln St Aldwyns Post Office
    GL7 5AN Cirencester
    Gloucestershire
    BritishExecutive59639890001
    GRAY, Bruce Nelson
    96 Gillhurst Road
    Edgbaston
    B17 8PA Birmingham
    পরিচালক
    96 Gillhurst Road
    Edgbaston
    B17 8PA Birmingham
    EnglandBritishFinance Director90779090002
    HEALEY, John Joseph
    Elizabeth Jennings Way
    OX2 7BN Oxford
    38
    Oxon
    পরিচালক
    Elizabeth Jennings Way
    OX2 7BN Oxford
    38
    Oxon
    United KingdomBritishFinance Director48355090002
    HEALEY, John Joseph
    38 Elizabeth Jennings Way
    OX2 7BN Oxford
    Oxfordshire
    পরিচালক
    38 Elizabeth Jennings Way
    OX2 7BN Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritishFinance Director48355090002
    HENDERSON, Dennis Malcolm
    Chapel House
    Glenridding
    CA11 0PG Penrith
    Cumbria
    পরিচালক
    Chapel House
    Glenridding
    CA11 0PG Penrith
    Cumbria
    United KingdomBritishManaging Director108068100002
    HILL, Benjamin Edwin
    Beaumont Grove
    B91 1RP Solihull
    'Cedar Wood' 9
    West Midlands
    পরিচালক
    Beaumont Grove
    B91 1RP Solihull
    'Cedar Wood' 9
    West Midlands
    EnglandBritishDirector133611910001
    LUCAS, Paul William
    Wootton Grange
    Wootton Green Lane
    CV7 7BQ Balsall Common
    পরিচালক
    Wootton Grange
    Wootton Green Lane
    CV7 7BQ Balsall Common
    EnglandBritishDirector77754260001
    MCHALE, Stuart Alan
    Halstede House
    Hinton-In-The-Hedges
    NN13 5NF Brackley
    Halstede House
    Northamptonshire
    পরিচালক
    Halstede House
    Hinton-In-The-Hedges
    NN13 5NF Brackley
    Halstede House
    Northamptonshire
    EnglandBritishOperations Support Director115858250001
    MOURGUE, Anthony John
    Brompton Gates
    170 Burley Road
    BH23 8DE Bransgore
    Dorset
    পরিচালক
    Brompton Gates
    170 Burley Road
    BH23 8DE Bransgore
    Dorset
    EnglandBritishAccountant17182830005
    NEILL, John Mitchell
    Unipart House
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    পরিচালক
    Unipart House
    Cowley
    OX4 2PG Oxford
    EnglandBritishGroup Chief Executive27195420006
    NICHOLS, Matt Ward, Mr.
    Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    18
    West Midlands
    England
    পরিচালক
    Sweetpool Lane
    Hagley
    DY8 2XH Stourbridge
    18
    West Midlands
    England
    EnglandBritishSales & Operations Director177829370001
    PARKER, Nigel Graham
    25 Saracen Drive
    Balsall Common
    CV7 7UA Coventry
    পরিচালক
    25 Saracen Drive
    Balsall Common
    CV7 7UA Coventry
    EnglandBritishPurchasing Director63333980001
    PRICHARD, Christopher
    4 Castle Street
    Astwood Bank
    B96 6DP Redditch
    Worcestershire
    পরিচালক
    4 Castle Street
    Astwood Bank
    B96 6DP Redditch
    Worcestershire
    BritishDirector11695860002
    QUINNEY, Colin Edgar
    10 Lillington Avenue
    CV32 5UJ Leamington Spa
    Warwickshire
    পরিচালক
    10 Lillington Avenue
    CV32 5UJ Leamington Spa
    Warwickshire
    BritishManufacturing Director67965190001
    RAYNER, Nicholas Land
    Southwinds
    Barford Road Bloxham
    OX15 4EZ Banbury
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Southwinds
    Barford Road Bloxham
    OX15 4EZ Banbury
    Oxfordshire
    United KingdomBritishManager122855660001
    REDFERN, Peter Johnson
    Staveley Park
    Staveley
    LA8 9QT Kendal
    Cumbria
    পরিচালক
    Staveley Park
    Staveley
    LA8 9QT Kendal
    Cumbria
    BritishDirector14981730002
    ROBERTS, Peter Tregarthen
    The Cottage Waldley
    Doveridge
    DE6 5LR Ashbourne
    Derbyshire
    পরিচালক
    The Cottage Waldley
    Doveridge
    DE6 5LR Ashbourne
    Derbyshire
    EnglandBritishDirector55406540001
    SACKETT, Anthony
    The Coach House Field Head Lane
    Myton Road
    CV34 6PT Warwick
    Warwickshire
    পরিচালক
    The Coach House Field Head Lane
    Myton Road
    CV34 6PT Warwick
    Warwickshire
    BritishDirector51224950003
    SACKETT, Anthony
    Pear Tree Cottage 114a Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DW Leeds
    পরিচালক
    Pear Tree Cottage 114a Tinshill Road
    Cookridge
    LS16 7DW Leeds
    BritishDirector51224950001
    SCOTT, Christopher George
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    120 Lady Byron Lane
    Knowle
    B93 9BA Solihull
    West Midlands
    EnglandBritishDirector94183390001
    SKONIECZNA, Vanda
    7 Fallows Road
    Northleach
    GL54 3QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    পরিচালক
    7 Fallows Road
    Northleach
    GL54 3QQ Cheltenham
    Gloucestershire
    BritishPersonnel Director55406300001
    STAMP, Christopher David
    49 Grange Road
    Dorridge
    B93 8QS Solihull
    West Midlands
    পরিচালক
    49 Grange Road
    Dorridge
    B93 8QS Solihull
    West Midlands
    BritishChartered Secretary44492580001
    STRINGER, Michael John
    Mill Lane
    OX25 5PG Lower Heyford
    Cherwell House
    Oxfordshire
    পরিচালক
    Mill Lane
    OX25 5PG Lower Heyford
    Cherwell House
    Oxfordshire
    United KingdomBritishManager124647360001
    WOOD, Michael Thomas
    8 Clydesdale Close
    WR9 7SB Droitwich
    Worcestershire
    পরিচালক
    8 Clydesdale Close
    WR9 7SB Droitwich
    Worcestershire
    BritishChartered Accountant35115790001

    HCSU29 LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২২ মে, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩১ মে, ২০১৪
    বকেয়া
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ৩১ মে, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ মে, ২০১২
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ জুন, ২০১২
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৪ জুন, ২০১২একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Non-vesting debts charge and first floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ অক্টো, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৩ অক্টো, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company formerly known as unipart automotive limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed charge the non-vesting debts together with the related rights floating charge the undertaking and all property assets and rights see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited as Asset Trustee
    ব্যবসায়
    • ১৩ অক্টো, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Rent deposit deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৫ আগ, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২২ আগ, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    £20,193 held in an interest bearing account, see image for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Invista Industrial (General Partner) Limited and Invista Industrial (Nominee) Limited
    ব্যবসায়
    • ২২ আগ, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Second floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ জানু, ২০০৪
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and each other company named therein to the secured parties or any of them under or pursuant to the asset ancillary agreements and/or the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of second floating charge its undertaking and all its property assets and rights including its property situated in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Asset Ancillary Trustee for the Secured Parties (The "Asset Ancillary Trustee")
    ব্যবসায়
    • ০৭ জানু, ২০০৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Non-vesting debts charge and first floating charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৯ ডিসে, ২০০৩
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৩ ডিসে, ২০০৩
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of first fixed charge all those of its present and future debts together with the related rights. By way of first floating charge its undertaking and all its property assets and rights whatsoever and wheresoever both present and future.. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited as Security Agent
    ব্যবসায়
    • ২৩ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    Floating charge and guarantee
    তৈরি করা হয়েছে ১২ এপ্রি, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All present and future obligations and liabilities of each obligaor to any lender under each finance document which such obligor is a party and tmi under the isda master agreement dated 18TH october 1999 (all terms as defined)
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Floating charge all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Investment Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and for Eachlender (The Security Trustee)
    ব্যবসায়
    • ২৫ এপ্রি, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Floating charge and guarantee
    তৈরি করা হয়েছে ২৯ সেপ, ১৯৯৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    In favour of the chargee all present and future obligations and liabilities due or to become due from each obligor to any transaction party under each transaction document to which such obligor is a party
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of a floating charge all its assets except for those contracts, to which it is a party, which by their terms prohibit the creation of a floating charge over or in respect of them.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Investment Bank PLC (The "Security Trustee")
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৯একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২৩ মার্চ, ২০০৫একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee and charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মে, ১৯৯৮
    ডেলিভারি করা হয়েছে ৩০ মে, ১৯৯৮
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    By way of fixed and specific charge all monies present or future standing to the credit of the account(s)of the company with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    ব্যবসায়
    • ৩০ মে, ১৯৯৮একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৯ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৫ এপ্রি, ১৯৯৭
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৭ মে, ১৯৯৭
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the books of the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ০৭ মে, ১৯৯৭একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ২০ ডিসে, ২০০৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১২ অক্টো, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৪ অক্টো, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from partco limited and/or woodhead rsr limited and/or partco group PLC to the chargee on any account whatsover
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies now or at any time standing to the credit of any account or accounts of the company in the banks books.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ১৪ অক্টো, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Letter of charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ মার্চ, ১৯৯৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ১৯৯৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from partco group PLC and/or partco limited to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All monies standing to the credit of any account(s) of the company in the bank's books.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৬ মার্চ, ১৯৯৪একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৯ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৪ সেপ, ১৯৮৯
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৯ সেপ, ১৯৮৯
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotlandas Trustee for the Beneficiaries (As Defined)
    ব্যবসায়
    • ১৯ সেপ, ১৯৮৯একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Composite guarantee & debenture
    তৈরি করা হয়েছে ২১ জুল, ১৯৮৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুল, ১৯৮৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company and/or wrapbond limited to the chargee on any account whatsoever.
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    (See doc 97 for further details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুল, ১৯৮৬একটি চার্জের নিবন্ধন
    • ০৯ জানু, ১৯৯৭একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    HCSU29 LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ৩০ অক্টো, ২০১৪প্রশাসন শুরু
    ১৯ মার্চ, ২০১৫প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    অভ্যাসকারী
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    অভ্যাসকারী
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2
    তারিখপ্রকার
    ১৯ মার্চ, ২০১৫ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ১৮ মার্চ, ২০২২ভেঙে গেছে
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    প্রস্তাবিত তরলকারী
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    প্রস্তাবিত তরলকারী
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    অভ্যাসকারী
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Philip Lewis Armstrong
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    অভ্যাসকারী
    Frp Advisory Llp 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0