CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED

  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ
  • সংক্ষিপ্তসার
  • উদ্দেশ্য
  • ঠিকানা
  • পূর্বের নামসমূহ
  • হিসাব
  • নিশ্চয়তা বিবৃতি
  • ফাইলিংস
  • কর্মকর্তাগণ
  • উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
  • চার্জ
  • দেউলিয়া
  • তথ্য উৎস
  • সংক্ষিপ্ত বিবরণ

    কোম্পানির নামCLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED
    কোম্পানির স্থিতিলিকুইডেশন
    আইনি ফর্মপ্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি
    কোম্পানি নম্বর 00681537
    এখতিয়ারইংল্যান্ড/ওয়েলস
    সৃষ্টির তারিখ

    সংক্ষিপ্তসার

    সুপার সিকিউর পিএসসি রয়েছেনা
    চার্জ রয়েছেহ্যাঁ
    দেউলিয়া ইতিহাস রয়েছেহ্যাঁ
    নিবন্ধিত অফিস বিরোধপূর্ণনা

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর উদ্দেশ্য কী?

    • বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণ (41201) / নির্মাণ

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED কোথায় অবস্থিত?

    নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা
    C/O INTERPATH LTD
    4th Floor Tailors Centre Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    ডেলিভারিযোগ্য নয় এমন নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানানা

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর পূর্বের নামগুলি কী কী?

    পূর্বের কোম্পানির নামসমূহ
    কোম্পানির নামথেকেপর্যন্ত
    CLUGSTON LIMITED২৩ জানু, ১৯৯১২৩ জানু, ১৯৯১
    CLUGSTON SLAG COMPANY LIMITED০৭ নভে, ১৯৮৬০৭ নভে, ১৯৮৬
    CLUGTON SLAG COMPANY LIMITED১০ সেপ, ১৯৮৬১০ সেপ, ১৯৮৬
    CLUGSTON ROADSTONE LIMITED৩১ ডিসে, ১৯৭৯৩১ ডিসে, ১৯৭৯
    CLUGSTON SLAG COMPANY LIMITED২৫ জানু, ১৯৬১২৫ জানু, ১৯৬১

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ হিসাবগুলি কী কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    পরবর্তী হিসাব
    পরবর্তী হিসাবের পরবর্তী সময়কাল শেষ হয়৩০ জানু, ২০১৯
    পরবর্তী হিসাবের মেয়াদ শেষ হয়২১ জানু, ২০২০
    শেষ হিসাব
    শেষ হিসাব তৈরি করা হয়েছে৩১ জানু, ২০১৮

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ নিশ্চয়তা বিবৃতির স্থিতি কী?

    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৫ জুল, ২০২০
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে১৬ আগ, ২০২০
    শেষ নিশ্চয়তা বিবৃতি
    পরবর্তী নিশ্চয়তা বিবৃতি তৈরি করা হয়েছে০৫ জুল, ২০১৯
    মেয়াদোত্তীর্ণহ্যাঁ

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর সর্বশেষ ফাইলিংগুলি কী কী?

    ফাইলিংস
    তারিখবর্ণনাদলিলপ্রকার

    ২৪ নভে, ২০২৪ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    24 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৪ নভে, ২০২৩ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    27 পৃষ্ঠাLIQ03

    ২৪ নভে, ২০২২ পর্যন্ত লিকুইডেটরদের রসিদ এবং অর্থপ্রদানের বিবৃতি

    30 পৃষ্ঠাLIQ03

    ১৮ জানু, ২০২২ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা 1 Sovereign Square Sovereign Street Leeds LS1 4DA থেকে 4th Floor Tailors Centre Thirsk Row Leeds LS1 4JFপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেটর নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠা600

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    28 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসন থেকে ক্রেডিটরদের স্বেচ্ছাসেবক লিকুইডেশনে স্থানান্তরের নোটিশ

    29 পৃষ্ঠাAM22

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    28 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    37 পৃষ্ঠাAM10

    প্রশাসনের সময় বর্ধনের নোটিশ

    4 পৃষ্ঠাAM19

    প্রশাসকের অগ্রগতির প্রতিবেদন

    41 পৃষ্ঠাAM10

    ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে সচিব হিসাবে Ian Pattison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    2 পৃষ্ঠাTM02

    ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে পরিচালক হিসাবে Ian Pattison এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    প্রস্তাবগুলির অনুমোদিত অনুমোদনের নোটিশ

    3 পৃষ্ঠাAM06

    বিবৃতির বিবৃতি সংযুক্ত ফর্ম সহ AM02SOA

    202 পৃষ্ঠাAM02

    প্রশাসকের প্রস্তাবের বিবৃতি

    53 পৃষ্ঠাAM03

    ১৮ ডিসে, ২০১৯ তারিখে নিবন্ধিত কার্যালয়ের ঠিকানা St Vincent House Normanby Road Scunthorpe North Lincolnshire DN15 8QT থেকে 1 Sovereign Square Sovereign Street Leeds LS1 4DAপরিবর্তন করা হয়েছে

    2 পৃষ্ঠাAD01

    প্রশাসক নিয়োগ

    3 পৃষ্ঠাAM01

    পূর্ববর্তী হিসাব অর্থবছর সংক্ষিপ্ত ৩১ জানু, ২০১৯ থেকে ৩০ জানু, ২০১৯ পর্যন্ত

    1 পৃষ্ঠাAA01

    ০৫ জুল, ২০১৯ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    ২৮ জুন, ২০১৯ তারিখে পরিচালক হিসাবে Robert John Vickers এর পদব্যবস্থা বাতিল

    1 পৃষ্ঠাTM01

    কোম্পানির উদ্দেশ্যের বিবৃতি

    2 পৃষ্ঠাCC04

    রেজুলেশনগুলি

    Resolutions
    30 পৃষ্ঠাRESOLUTIONS
    প্রস্তাব
    বিভাগতারিখবর্ণনাপ্রকার
    incorporation

    সংঘের নিবন্ধ গৃহীত করার রেজুলেশন

    RES01

    পূর্ণ হিসাব ৩১ জানু, ২০১৮ পর্যন্ত তৈরি

    20 পৃষ্ঠাAA

    ০৫ জুল, ২০১৮ তারিখে কোনও আপডেট ছাড়াই নিশ্চয়তা বিবৃতি

    3 পৃষ্ঠাCS01

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর কর্মকর্তাগণ কারা?

    কর্মকর্তাগণ
    নামনিয়োগ করা হয়েছেপদত্যাগের তারিখভূমিকাঠিকানাকোম্পানি পরিচয়বাসস্থানের দেশজাতীয়তাজন্ম তারিখপেশানম্বর
    ALLINGHAM, Andrew Thomas
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    পরিচালক
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    United KingdomBritishCommercial Director96288100001
    CLUGSTON, David Westland Antony
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    পরিচালক
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    EnglandBritishDirector148304470001
    FRY, Roderick Malcolm
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    পরিচালক
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    EnglandBritishDirector178305420001
    RADCLIFFE, Stephen John
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    পরিচালক
    Thirsk Row
    LS1 4JF Leeds
    4th Floor Tailors Centre
    United KingdomBritishDirector80781440002
    BALES, Michael Howard
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    সচিব
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    British2645510001
    HODGSON, John Anthony
    Stonecroft Hill Top Road
    Newmillerdam
    WF2 6PZ Wakefield
    West Yorkshire
    সচিব
    Stonecroft Hill Top Road
    Newmillerdam
    WF2 6PZ Wakefield
    West Yorkshire
    British32222690001
    HURST, Richard Leslie
    26 Churchill Avenue
    DN20 8DF Brigg
    North Lincolnshire
    সচিব
    26 Churchill Avenue
    DN20 8DF Brigg
    North Lincolnshire
    British619540001
    PATTISON, Ian
    Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    1 Sovereign Square
    সচিব
    Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    1 Sovereign Square
    207696440001
    WILSON, Alan
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    সচিব
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    BritishChartered Accountant147755040001
    AMOS, Andrew Jonathan
    2 Hawkcliffe View
    Woodside Park
    BD20 0BS Silsden
    West Yorkshire
    পরিচালক
    2 Hawkcliffe View
    Woodside Park
    BD20 0BS Silsden
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director97277560001
    BALES, Michael Howard
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    পরিচালক
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    United KingdomBritishFinance Director2645510001
    BURNETT, John Martin
    Millwood House
    Blackthorn Lane Cammeringham
    LN1 2SH Lincoln
    পরিচালক
    Millwood House
    Blackthorn Lane Cammeringham
    LN1 2SH Lincoln
    EnglandBritishCompany Director70646680001
    BUTCHER, Roy
    St Andrew's House
    Castle Howard Road
    YO17 7AY Malton
    N Yorkshire
    পরিচালক
    St Andrew's House
    Castle Howard Road
    YO17 7AY Malton
    N Yorkshire
    EnglandBritishGroup Chief Executive364670031
    CLUGSTON, John Westland Antony
    The Old Vicarage
    Scawby
    DN20 9LX Brigg
    North Lincolnshire
    পরিচালক
    The Old Vicarage
    Scawby
    DN20 9LX Brigg
    North Lincolnshire
    EnglandBritishChairman2292210001
    DIXON, George William
    Carpenters Cottage
    Brattleby
    LN1 2SQ Lincoln
    Lincolnshire
    পরিচালক
    Carpenters Cottage
    Brattleby
    LN1 2SQ Lincoln
    Lincolnshire
    BritishCompany Director14883930006
    DYMOND, Alan John
    No 5 Home Farm Court
    Park Lane West Bretton
    WF4 4TR Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    No 5 Home Farm Court
    Park Lane West Bretton
    WF4 4TR Wakefield
    West Yorkshire
    BritishCompany Director45897810002
    HODGSON, John Anthony
    Stonecroft Hill Top Road
    Newmillerdam
    WF2 6PZ Wakefield
    West Yorkshire
    পরিচালক
    Stonecroft Hill Top Road
    Newmillerdam
    WF2 6PZ Wakefield
    West Yorkshire
    BritishChartered Accountant32222690001
    IVES, Simon George
    Highfield
    Thornton Road, South Kelsey
    LN7 6PS Market Rasen
    পরিচালক
    Highfield
    Thornton Road, South Kelsey
    LN7 6PS Market Rasen
    EnglandBritishCompany Director18924830003
    MARCH, Timothy Robert
    Westend House 2 Meggitt Lane
    Winteringham
    DN15 9NY Scunthorpe
    South Humberside
    পরিচালক
    Westend House 2 Meggitt Lane
    Winteringham
    DN15 9NY Scunthorpe
    South Humberside
    BritishDirector119099390001
    MARTIN, Stephen Frederick
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    পরিচালক
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritishDirector117868520002
    PATTISON, Ian
    Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    1 Sovereign Square
    পরিচালক
    Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    1 Sovereign Square
    United KingdomBritishFinance Director160032140003
    STERRY, David William Edmund
    9 Eastgate
    Scotton
    DN21 3QP Gainsborough
    Lincolnshire
    পরিচালক
    9 Eastgate
    Scotton
    DN21 3QP Gainsborough
    Lincolnshire
    United KingdomBritishManaging Director - Chartered Civil Engineer50971630001
    TILLEY, Stewart Arthur
    Knaith Park
    DN21 5HB Gainsborough
    Stephensons Hill House
    South Yorkshire
    পরিচালক
    Knaith Park
    DN21 5HB Gainsborough
    Stephensons Hill House
    South Yorkshire
    United KingdomBritishCompany Director123096270003
    VICKERS, Robert John
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    পরিচালক
    St Vincent House
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    North Lincolnshire
    EnglandBritishChief Executive Officer164124450001
    WILSON, Alan
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    পরিচালক
    20 Westfield Park
    Elloughton
    HU15 1AN Brough
    East Yorkshire
    United KingdomBritishChartered Accountant147755040001

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা কারা?

    উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তি
    নামজানানো হয়েছেঠিকানাবন্ধ হয়েছে
    Clugston Group Limited
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    England
    ০৬ এপ্রি, ২০১৬
    Normanby Road
    DN15 8QT Scunthorpe
    St Vincent House
    North Lincolnshire
    England
    না
    আইনি ফর্মLimited Company
    নিবন্ধিত দেশEngland
    আইনি কর্তৃপক্ষEngland And Wales
    নিবন্ধিত স্থানRegister Of Companies Maintained By The Registrar Of Companies For England And Wales
    নিবন্ধন নম্বর00333188
    নিয়ন্ত্রণের প্রকৃতি
    • ব্যক্তিটি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে কোম্পানির ৭৫% এর বেশি শেয়ারের মালিকানাধীন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির ভোটাধিকারের 75% এর বেশি সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য নিয়োগ বা অপসারণ করার অধিকার সরাসরি বা পরোক্ষভাবে ধারণ করেন।
    • ব্যক্তি কোম্পানির উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বা নিয়ন্ত্রণ ব্যায় করার অধিকার রাখেন বা কার্যত ব্যায় করেন।

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর কোনো চার্জ আছে কি?

    চার্জ
    শ্রেণীবিন্যাসতারিখস্থিতিবিস্তারিত
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ০১ ফেব, ২০১৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ০৪ ফেব, ২০১৬
    বকেয়া
    ফ্লোটিং চার্জ সবকিছু অন্তর্ভুক্ত করে: হ্যাঁ
    নেতিবাচক প্রতিশ্রুতি রয়েছে: হ্যাঁ
    ফ্লোটিং চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    ফিক্সড চার্জ রয়েছে: হ্যাঁ
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ০৪ ফেব, ২০১৬একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    A registered charge
    তৈরি করা হয়েছে ২৬ মার্চ, ২০১৪
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৭ মার্চ, ২০১৪
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    None.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Zurich Insurance Public Limited Company
    ব্যবসায়
    • ২৭ মার্চ, ২০১৪একটি চার্জের নিবন্ধন (MR01)
    • ০২ জুন, ২০১৪একটি চার্জের সন্তুষ্টি (MR04)
    Charge of deposit
    তৈরি করা হয়েছে ১৩ এপ্রি, ২০১১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৮ এপ্রি, ২০১১
    বকেয়া
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    All amounts now and in the future credited to account number 48260142 with the bank.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ২৮ এপ্রি, ২০১১একটি চার্জের নিবন্ধন (MG01)
    Debenture
    তৈরি করা হয়েছে ০৬ জানু, ২০০৬
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৮ জানু, ২০০৬
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • National Westminster Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১৮ জানু, ২০০৬একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ০৫ জানু, ২০১৩একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (MG02)
    Deed
    তৈরি করা হয়েছে ০৮ অক্টো, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১৬ অক্টো, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of schedule 4 of the agreement dated 25 may 1999
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Property k/a 30 the ropewalk nottingham t/n NT308629.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Queen's Medical Centre Nottingham University Hospital National Health Service Trust
    ব্যবসায়
    • ১৬ অক্টো, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed and floating security document
    তৈরি করা হয়েছে ০৩ মে, ২০০১
    ডেলিভারি করা হয়েছে ১০ মে, ২০০১
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any finance party on any account whatsoever
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • Hsbc Bank PLC
    ব্যবসায়
    • ১০ মে, ২০০১একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)
    Fixed legal charge
    তৈরি করা হয়েছে ১৪ জুল, ২০০০
    ডেলিভারি করা হয়েছে ২৫ জুল, ২০০০
    পুরোপুরি পরিশোধিত
    সুরক্ষিত পরিমাণ
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether under the legal charge or a funding agreement dated 7 june 2000
    সংক্ষিপ্ত বিবরণ
    F/H land and buildings at west moor park near west moor lane armthorpe doncaster south yorkshire t/n SYK374614. See the mortgage charge document for full details.
    অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা
    • The Urban Regeneration Agency
    ব্যবসায়
    • ২৫ জুল, ২০০০একটি চার্জের নিবন্ধন (395)
    • ১৭ ফেব, ২০০৬একটি চার্জের সম্পূর্ণ বা আংশিক সন্তুষ্টির বিবৃতি (403a)

    CLUGSTON CONSTRUCTION LIMITED এর কোনো দেউলিয়া মামলা আছে কি?

    মামলা নম্বরতারিখপ্রকারঅভ্যাসকারীঅন্যান্য
    1
    তারিখপ্রকার
    ০৬ ডিসে, ২০১৯প্রশাসন শুরু
    ২৫ নভে, ২০২১প্রশাসন শেষ
    প্রশাসনের অধীনে
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    James Richard Clark
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    2
    তারিখপ্রকার
    ২৫ নভে, ২০২১ওয়াইন্ডিং আপের শুরু
    ঋণদাতাদের স্বেচ্ছাসেবী তরলীকরণ
    নামভূমিকাঠিকানানিয়োগ করা হয়েছেবন্ধ হয়েছে
    James Richard Clark
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    অভ্যাসকারী
    1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    West Yorkshire
    Howard Smith
    Interpath Advisory, 1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds
    অভ্যাসকারী
    Interpath Advisory, 1 Sovereign Square Sovereign Street
    LS1 4DA Leeds

    তথ্য উৎস

    • ইউকে কম্পানিজ হাউস
      যুক্তরাজ্যের সরকারী কোম্পানি রেজিস্ট্রি, যা কোম্পানির তথ্য যেমন নাম, ঠিকানা, পরিচালক এবং আর্থিক ফাইলিং এর মতো তথ্যের জন্য জনসাধারণের অ্যাক্সেস সরবরাহ করে।
    • লাইসেন্স: CC0